WHITGIFT ONE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéWHITGIFT ONE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 05552966
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de WHITGIFT ONE LIMITED ?

    • Location de propriété intellectuelle et de produits similaires, à l'exception des œuvres protégées par le droit d'auteur (77400) / Activités administratives et de soutien

    Où se situe WHITGIFT ONE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    21 St Thomas Street
    Bristol
    BS1 6JS
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de WHITGIFT ONE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour WHITGIFT ONE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Avis de cessation d'activité en tant qu'administrateur judiciaire ou gérant

    4 pagesRM02

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 13 févr. 2018

    4 pagesREC2

    Avis de cessation d'activité en tant qu'administrateur judiciaire ou gérant

    4 pagesRM02

    Avis de cessation d'activité en tant qu'administrateur judiciaire ou gérant

    4 pagesRM02

    Avis de cessation d'activité en tant qu'administrateur judiciaire ou gérant

    4 pagesRM02

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 10 déc. 2017

    4 pagesREC2

    Comptes d'exonération totale établis au 30 sept. 2015

    6 pagesAA

    Comptes d'exonération totale établis au 30 sept. 2016

    6 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 02 sept. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 10 juin 2016

    2 pages3.6

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 10 déc. 2016

    2 pages3.6

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 10 juin 2017

    4 pagesREC2

    Déclaration de confirmation établie le 02 sept. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Résumé des recettes et paiements du récepteur jusqu'au 10 déc. 2015

    2 pages3.6

    Déclaration annuelle jusqu'au 02 sept. 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital08 sept. 2015

    État du capital au 08 sept. 2015

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs Nina Christine Johnston le 13 août 2015

    2 pagesCH01

    Comptes d'exonération totale établis au 30 sept. 2014

    6 pagesAA

    Nomination d'un administrateur judiciaire ou d'un gérant

    4 pagesRM01

    Nomination d'un administrateur judiciaire ou d'un gérant

    4 pagesRM01

    Nomination d'un administrateur judiciaire ou d'un gérant

    5 pagesRM01

    Nomination d'un administrateur judiciaire ou d'un gérant

    4 pagesRM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 02 sept. 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital16 sept. 2014

    État du capital au 16 sept. 2014

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Qui sont les dirigeants de WHITGIFT ONE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    EQUIOM CORPORATE SERVICES LIMITED
    Jubilee Buildings
    Victoria Street
    IM1 2SH Douglas
    First Floor
    Isle Of Man
    Isle Of Man
    Secrétaire
    Jubilee Buildings
    Victoria Street
    IM1 2SH Douglas
    First Floor
    Isle Of Man
    Isle Of Man
    Forme juridiqueLIMITED COMPANY
    Type d'identificationHors EEE
    Autorité légaleISLE OF MAN (COMPANIES ACT 1931)
    Numéro d'enregistrement011528C
    123093280001
    DEAN, Sheila Margaret
    The Rowans The Falls
    Tromode Road Cronkbourne
    IM4 4PZ Douglas
    Isle Of Man
    Administrateur
    The Rowans The Falls
    Tromode Road Cronkbourne
    IM4 4PZ Douglas
    Isle Of Man
    Isle Of ManBritishChartered Certified Accountant79912300002
    JOHNSTON, Nina Christine
    Victoria Street
    IM1 2SH Douglas
    Jubilee Buildings
    Isle Of Man
    Administrateur
    Victoria Street
    IM1 2SH Douglas
    Jubilee Buildings
    Isle Of Man
    Isle Of ManBritishManager155566400004
    NOON, Fiona Doris
    15 Ballagarey Road
    IM4 4EB Glen Vine
    15
    Isle Of Man
    Administrateur
    15 Ballagarey Road
    IM4 4EB Glen Vine
    15
    Isle Of Man
    Isle Of ManBritishAssistant Manager176861450001
    DEAN, Sheila Margaret
    The Rowans The Falls
    Tromode Road Cronkbourne
    IM4 4PZ Douglas
    Isle Of Man
    Secrétaire
    The Rowans The Falls
    Tromode Road Cronkbourne
    IM4 4PZ Douglas
    Isle Of Man
    BritishChartered Certified Accountant79912300002
    DUFFIELD, David Mark Johnston
    58 West Chiltern
    Woodcote
    RG8 0SG Reading
    Berkshire
    Secrétaire
    58 West Chiltern
    Woodcote
    RG8 0SG Reading
    Berkshire
    British49654480002
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    DAVIES, Stewart John
    8 Glen Darragh Gardens
    Glen Darragh Road
    IM4 4DD Glen Vine
    Isle Of Man
    Administrateur
    8 Glen Darragh Gardens
    Glen Darragh Road
    IM4 4DD Glen Vine
    Isle Of Man
    BritishDirector109715100001
    DAVIN, Aidan Francis
    5 Olafs Close
    IM2 7AR Douglas
    Isle Of Man
    Administrateur
    5 Olafs Close
    IM2 7AR Douglas
    Isle Of Man
    Isle Of ManBritishTrust Manager109160260001
    DEIGMAN, Patrick
    Frith Hill House
    Frith Hill
    HP16 0QR Great Missenden
    Buckinghamshire
    Administrateur
    Frith Hill House
    Frith Hill
    HP16 0QR Great Missenden
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishBuilding Suveyor37099910001
    ELLIS, Katherine Sarah
    Daleside
    10 Cronkbourne Road
    IM2 3LB Douglas
    Isle Of Man
    Administrateur
    Daleside
    10 Cronkbourne Road
    IM2 3LB Douglas
    Isle Of Man
    Isle Of ManBritishAccountant116580660002
    HORSTHUIS, Peter Nicholas
    The Old Ford House
    IM4 3AQ St Johns
    Isle Of Man
    Administrateur
    The Old Ford House
    IM4 3AQ St Johns
    Isle Of Man
    BritishChartered Accountant40872340002
    INGRASSIA, Sarah Joanne
    Highfield Drive
    Baldrine
    IM4 6EE Isle Of Man
    Larkrise
    Administrateur
    Highfield Drive
    Baldrine
    IM4 6EE Isle Of Man
    Larkrise
    Isle Of ManBritish,Trust Manager277736980001
    INGRASSIA, Sarah Joanne
    Larkrise
    Highfield Drive
    IM4 6EE Baldrine
    Isle Of Man
    Administrateur
    Larkrise
    Highfield Drive
    IM4 6EE Baldrine
    Isle Of Man
    Isle Of ManBritish,Assistant Manager277736980001
    JOHNSTON, Nina Christine
    Erin View
    IM9 6FG Port Erin
    2
    Isle Of Man
    British Isles
    Administrateur
    Erin View
    IM9 6FG Port Erin
    2
    Isle Of Man
    British Isles
    Isle Of ManBritishSenior Manager155566400001
    PULSFORD, Jeffrey Mark
    Highcroft 15 Little Warren Close
    GU4 8PW Guildford
    Surrey
    Administrateur
    Highcroft 15 Little Warren Close
    GU4 8PW Guildford
    Surrey
    BritishAccountant49776690003
    WILLIS, Samantha Jayne
    24 Ennerdale Avenue
    IM3 2DL Onchan
    Isle Of Man
    Administrateur
    24 Ennerdale Avenue
    IM3 2DL Onchan
    Isle Of Man
    Isle Of ManBritishCompany Administrator102956890001
    WINSLOW, Timothy Simon
    The Dial House
    24 Birds Hill Road
    KT22 0NJ Oxshott
    Surrey
    Administrateur
    The Dial House
    24 Birds Hill Road
    KT22 0NJ Oxshott
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director76547740001

    Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour WHITGIFT ONE LIMITED ?

    Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
    Notifié leCessé leDéclaration
    02 sept. 2016La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société.

    WHITGIFT ONE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 04 janv. 2008
    Livré le 18 janv. 2008
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any member of the bank's group of companies (the bank group) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The whitgift centre croydon (sgl 56478), units 110 and 1110 whitgift centre croydon (sgl 580613), 60, 62, 64, 66, 68 and part 70 north end croydon (sfl 560378) for details of further properties charged please refer to form 395.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transactions
    • 18 janv. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 115 déc. 2014Nomination d'un administrateur ou d'un gestionnaire (RM01)
    • 323 janv. 2015Nomination d'un administrateur ou d'un gestionnaire (RM01)
    • 117 févr. 2018Avis de cessation d'exercer en tant qu'administrateur ou gestionnaire (RM02)
    • 317 févr. 2018Avis de cessation d'exercer en tant qu'administrateur ou gestionnaire (RM02)
      • Numéro de dossier 1
      • Numéro de dossier 3
    Legal charge
    Créé le 04 janv. 2008
    Livré le 18 janv. 2008
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from anglo irish assurance company limited and francis edward gormley timothy gregory coughlan brian joseph madden and brendan murtagh to the chargee or any member of the bank's group of companies under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The whitgift centre croydon t/n SGL564748, units 110 and 1110 whitgift centre croydon t/n SGL580613, 60 62 64 66 68 and part 70 north end croydon t/n SGL560378, for details of further properties charged, please refer to form 395,. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transactions
    • 18 janv. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 215 déc. 2014Nomination d'un administrateur ou d'un gestionnaire (RM01)
    • 423 janv. 2015Nomination d'un administrateur ou d'un gestionnaire (RM01)
    • 217 févr. 2018Avis de cessation d'exercer en tant qu'administrateur ou gestionnaire (RM02)
    • 422 mars 2018Avis de cessation d'exercer en tant qu'administrateur ou gestionnaire (RM02)
      • Numéro de dossier 2
      • Numéro de dossier 4
    Legal charge
    Créé le 12 mars 2007
    Livré le 14 mars 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the borrowers to the chargee and/or to any member of the bank group on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The whitgift centre croydon t/no SGL564748, units 110 and 1110 whitgift centre croydon t/no SGL580613 and 60, 62, 64, 66, 68 and part 70 north end croydon t/no SGL560378 the rents the plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transactions
    • 14 mars 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 29 sept. 2005
    Livré le 18 oct. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any of the borrowers to the chargee and/or to any members of the bank group on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    100 north end croydon t/n SY48407 106 north end croydon t/n SGL624289 96 and 98 north end croydon SGL606190 for further details of the properties charged please refer to form 395 together with all buildings fixtures and fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transactions
    • 18 oct. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 mai 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    WHITGIFT ONE LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1Receiver/Manager appointed
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Chad Griffin
    Fti Consulting Llp 200 Aldersgate
    Aldersgate Street
    EC1A 4HD London
    receiver manager
    Fti Consulting Llp 200 Aldersgate
    Aldersgate Street
    EC1A 4HD London
    Simon John Granger
    200 Aldersgate
    Aldersgate Street
    EC1A 4HD London
    receiver manager
    200 Aldersgate
    Aldersgate Street
    EC1A 4HD London
    2Receiver/Manager appointed
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Chad Griffin
    Fti Consulting Llp 200 Aldersgate
    Aldersgate Street
    EC1A 4HD London
    receiver manager
    Fti Consulting Llp 200 Aldersgate
    Aldersgate Street
    EC1A 4HD London
    Simon John Granger
    200 Aldersgate
    Aldersgate Street
    EC1A 4HD London
    receiver manager
    200 Aldersgate
    Aldersgate Street
    EC1A 4HD London
    3Receiver/Manager appointed
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Chad Griffin
    Fti Consulting Llp 200 Aldersgate
    Aldersgate Street
    EC1A 4HD London
    receiver manager
    Fti Consulting Llp 200 Aldersgate
    Aldersgate Street
    EC1A 4HD London
    Simon John Granger
    200 Aldersgate
    Aldersgate Street
    EC1A 4HD London
    receiver manager
    200 Aldersgate
    Aldersgate Street
    EC1A 4HD London
    4Receiver/Manager appointed
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Chad Griffin
    Fti Consulting Llp 200 Aldersgate
    Aldersgate Street
    EC1A 4HD London
    receiver manager
    Fti Consulting Llp 200 Aldersgate
    Aldersgate Street
    EC1A 4HD London
    Simon John Granger
    200 Aldersgate
    Aldersgate Street
    EC1A 4HD London
    receiver manager
    200 Aldersgate
    Aldersgate Street
    EC1A 4HD London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0