OP REALISATIONS (ALASKA) LIMITED

OP REALISATIONS (ALASKA) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéOP REALISATIONS (ALASKA) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 05554875
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de OP REALISATIONS (ALASKA) LIMITED ?

    • (7415) /

    Où se situe OP REALISATIONS (ALASKA) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    12 Plumtree Court
    EC4A 4HT London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de OP REALISATIONS (ALASKA) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    ORCHID PUBS ALASKA LIMITED26 juin 200626 juin 2006
    PUNCH TAVERNS (REDWOOD NEWCO 1) LIMITED30 nov. 200530 nov. 2005
    BARNBRIGHT LIMITED06 sept. 200506 sept. 2005

    Quels sont les derniers comptes de OP REALISATIONS (ALASKA) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2007

    Quels sont les derniers dépôts pour OP REALISATIONS (ALASKA) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 20 nov. 2009

    5 pages2.24B

    Avis de transition de l'administration à la dissolution le 20 nov. 2009

    5 pages2.35B

    legacy

    1 pages287

    legacy

    1 pages288b

    Statuts

    22 pagesMA

    Déclaration des affaires avec le formulaire 2.14B

    6 pages2.16B

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    16 pages2.17B

    Certificat de changement de nom

    Company name changed orchid pubs alaska LIMITED\certificate issued on 10/02/09
    2 pagesCERTNM

    Nomination d'un administrateur

    1 pages2.12B

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2007

    11 pagesAA

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Amendment ot deeds 24/09/2008
    RES13

    legacy

    3 pages363a

    Résolutions

    Resolutions
    16 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Co business 09/07/2008
    RES13
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    legacy

    2 pages363a

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2006

    11 pagesAA

    legacy

    1 pages190

    legacy

    1 pages287

    legacy

    1 pages353

    legacy

    1 pages287

    legacy

    2 pages403a

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution d'assistance financière pour l'acquisition d'actions

    RES07

    legacy

    14 pages155(6)b

    legacy

    14 pages155(6)b

    legacy

    14 pages155(6)b

    Qui sont les dirigeants de OP REALISATIONS (ALASKA) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    FREEMAN, Charles Truscott
    9 The Uplands
    AL5 2PG Harpenden
    Hertfordshire
    Administrateur
    9 The Uplands
    AL5 2PG Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritish67008750001
    HALL, Jonathan Rufus
    47 Crouch Hall Lane
    Redbourn
    AL3 7EU St. Albans
    Hertfordshire
    Administrateur
    47 Crouch Hall Lane
    Redbourn
    AL3 7EU St. Albans
    Hertfordshire
    UkBritish109659060001
    RUDD, Susan Clare
    23 Whitehouse Drive
    WS13 8FE Lichfield
    Staffordshire
    Secrétaire
    23 Whitehouse Drive
    WS13 8FE Lichfield
    Staffordshire
    British81789210002
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Secrétaire désigné
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    900005620001
    T&H SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Sceptre Court
    40 Tower Hill
    EC3N 4DX London
    Secrétaire
    Sceptre Court
    40 Tower Hill
    EC3N 4DX London
    64631620001
    LEVY, Adrian Joseph Morris
    2 Carlisle Gardens
    HA3 0JX Harrow
    Middlesex
    Administrateur
    2 Carlisle Gardens
    HA3 0JX Harrow
    Middlesex
    United KingdomBritish147682410001
    MCDONALD, Robert James
    46 Wentworth Drive
    WS14 9HN Lichfield
    Staffordshire
    Administrateur
    46 Wentworth Drive
    WS14 9HN Lichfield
    Staffordshire
    British42019620001
    PRESTON, Neil David
    Postern Road
    Tatenhill
    DE13 9SJ Burton On Trent
    57
    Staffordshire
    Administrateur
    Postern Road
    Tatenhill
    DE13 9SJ Burton On Trent
    57
    Staffordshire
    United KingdomBritish63043630002
    PUDGE, David John
    20 Herondale Avenue
    SW18 3JL London
    Administrateur désigné
    20 Herondale Avenue
    SW18 3JL London
    British900028170001
    THORLEY, Giles Alexander
    Charlton Manor
    Ashley Road Charlton Kings
    GL52 6NS Cheltenham
    Gloucestershire
    Administrateur
    Charlton Manor
    Ashley Road Charlton Kings
    GL52 6NS Cheltenham
    Gloucestershire
    Gb-EngBritish81928120001

    OP REALISATIONS (ALASKA) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 29 janv. 2007
    Livré le 09 févr. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Properties k/a brb hampstead 48 rosslynhill london t/no NGL866531 green man green man lane hatton bedfont t/no AGL128345 railway hotel 390 oldfield lane greenford t/no AGL133528 (for details of further properties charged please refer to th. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Security Agent)
    Transactions
    • 09 févr. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Security accession deed
    Créé le 25 juin 2006
    Livré le 05 juil. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Security Agent)
    Transactions
    • 05 juil. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 févr. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Share charge
    Créé le 23 mai 2006
    Livré le 31 mai 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of first fixed charge all its present and future shares and dividends. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland as Security Agent
    Transactions
    • 31 mai 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 juin 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    OP REALISATIONS (ALASKA) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    13 déc. 2008Administration started
    20 nov. 2009Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Colin Michael Trevethyn Haig
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Plumtree Court 3rd Floor
    EC4A 4HT London
    practitioner
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Plumtree Court 3rd Floor
    EC4A 4HT London
    David Christian Chubb
    Pricewaterhousecoopers Llp Richmond Hill
    BH2 6HR Bournemouth
    Dorset
    practitioner
    Pricewaterhousecoopers Llp Richmond Hill
    BH2 6HR Bournemouth
    Dorset
    Michael John Andrew Jervis
    Pricewaterhousecoopers Llp 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    practitioner
    Pricewaterhousecoopers Llp 7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0