PANGOLIN ENTERPRISES LTD

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéPANGOLIN ENTERPRISES LTD
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 05554990
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de PANGOLIN ENTERPRISES LTD ?

    • Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (82990) / Activités administratives et de soutien

    Où se situe PANGOLIN ENTERPRISES LTD ?

    Adresse du siège social
    1st Floor, 27 Shirwell Crescent
    Furzton
    MK4 1GA Milton Keynes
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de PANGOLIN ENTERPRISES LTD ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2021

    Quels sont les derniers dépôts pour PANGOLIN ENTERPRISES LTD ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Comptes de micro-entité établis au 30 sept. 2021

    5 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 06 sept. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Changement d'adresse du siège social de 1st Floor, 181 Queensway Bletchley Milton Keynes MK2 2DZ England à 1st Floor, 27 Shirwell Crescent Furzton Milton Keynes MK4 1GA le 03 août 2021

    1 pagesAD01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr James Malcolm Hall le 02 déc. 2020

    2 pagesCH01

    Comptes de micro-entité établis au 30 sept. 2020

    5 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 06 sept. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes de micro-entité établis au 30 sept. 2019

    5 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 06 sept. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes de micro-entité établis au 30 sept. 2018

    5 pagesAA

    Satisfaction de la charge 1 en totalité

    1 pagesMR04

    Notification d'une déclaration relative à une personne disposant d'un contrôle significatif

    2 pagesPSC08

    Déclaration de confirmation établie le 06 sept. 2018 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Cessation de Karen Ann Hall en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 31 déc. 2017

    1 pagesPSC07

    Cessation de James Malcolm Hall en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 31 déc. 2017

    1 pagesPSC07

    Résolutions

    Resolutions
    6 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Comptes de micro-entité établis au 30 sept. 2017

    6 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 06 sept. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 sept. 2016

    7 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 06 sept. 2016 avec mises à jour

    6 pagesCS01

    Changement d'adresse du siège social de 2nd Floor 181 Queensway Bletchley Milton Keynes MK2 2DZ à 1st Floor, 181 Queensway Bletchley Milton Keynes MK2 2DZ le 26 sept. 2016

    1 pagesAD01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 sept. 2015

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 06 sept. 2015 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital05 oct. 2015

    État du capital au 05 oct. 2015

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Qui sont les dirigeants de PANGOLIN ENTERPRISES LTD ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    HALL, Karen Ann
    Shirwell Crescent
    Furzton
    MK4 1GA Milton Keynes
    1st Floor, 27
    England
    Secrétaire
    Shirwell Crescent
    Furzton
    MK4 1GA Milton Keynes
    1st Floor, 27
    England
    British107957560001
    HALL, James Malcolm
    Shirwell Crescent
    Furzton
    MK4 1GA Milton Keynes
    1st Floor, 27
    England
    Administrateur
    Shirwell Crescent
    Furzton
    MK4 1GA Milton Keynes
    1st Floor, 27
    England
    EnglandBritish108138210003
    FORM 10 SECRETARIES FD LTD
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Secrétaire désigné
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    900015000001
    FORM 10 DIRECTORS FD LTD
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    Administrateur désigné
    39a Leicester Road
    Salford
    M7 4AS Manchester
    900014990001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur PANGOLIN ENTERPRISES LTD ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Mr James Malcolm Hall
    Queensway
    Bletchley
    MK2 2DZ Milton Keynes
    1st Floor, 181
    England
    06 avr. 2016
    Queensway
    Bletchley
    MK2 2DZ Milton Keynes
    1st Floor, 181
    England
    Oui
    Nationalité: British
    Pays de résidence: United Kingdom
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des droits de vote dans la société.
    Mrs Karen Ann Hall
    Queensway
    Bletchley
    MK2 2DZ Milton Keynes
    1st Floor, 181
    England
    06 avr. 2016
    Queensway
    Bletchley
    MK2 2DZ Milton Keynes
    1st Floor, 181
    England
    Oui
    Nationalité: British
    Pays de résidence: United Kingdom
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des droits de vote dans la société.

    Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour PANGOLIN ENTERPRISES LTD ?

    Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
    Notifié leCessé leDéclaration
    31 déc. 2017La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société.

    PANGOLIN ENTERPRISES LTD a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal mortgage
    Créé le 16 mai 2008
    Livré le 24 mai 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    15 old groveway simpson milton keynes assigns the goodwill of all businesses, from time to time carried on at the property, with the benefit of all authorisations, permits, registration certificates or licences of any kind, also by way of fixed charge the equipment & goods (if any) & all other fixtures, fittings, plant & machinery & by way of floating charge on other moveable plant, machinery, furniture, equipment, goods & other effects which are from time to time on the property.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank PLC
    Transactions
    • 24 mai 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 juin 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 16 avr. 2008
    Livré le 22 avr. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank PLC
    Transactions
    • 22 avr. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 nov. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal mortgage (own account)
    Créé le 18 déc. 2007
    Livré le 19 déc. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    16 colley hill bradwell milton keynes MK13 9DA. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank PLC
    Transactions
    • 19 déc. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 06 juil. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal mortgage
    Créé le 04 sept. 2007
    Livré le 06 sept. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    44 westfield road bletchley bucks. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 06 sept. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 nov. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 10 mai 2007
    Livré le 12 mai 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £168,000.00 due or to become due from the company to
    Brèves mentions
    6 lamb close newport pagnell buckinghamshire.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank Public Limited Company
    Transactions
    • 12 mai 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 25 sept. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 16 mars 2007
    Livré le 29 mars 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    7 william smith close woolstone milton keynes bucks.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank PLC
    Transactions
    • 29 mars 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 nov. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 28 févr. 2007
    Livré le 17 mars 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    2 thane court stantonbury milton keyenes bucks. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 17 mars 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 nov. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 18 sept. 2006
    Livré le 26 sept. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    F/H property k/a 164 tickford street newport pagnell. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 26 sept. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 avr. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 19 juin 2006
    Livré le 27 juin 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    31 warren bank simpson milton keynes buckinghamshire. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 27 juin 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 janv. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 09 mai 2006
    Livré le 11 mai 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    17 thresher grove greenleys milton keynes. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 11 mai 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 oct. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 25 avr. 2006
    Livré le 04 mai 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 04 mai 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 déc. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0