COUNTRYSIDE PROPERTIES (HOUSEBUILDING) LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | COUNTRYSIDE PROPERTIES (HOUSEBUILDING) LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 05555391 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe COUNTRYSIDE PROPERTIES (HOUSEBUILDING) LIMITED ?
| Adresse du siège social | 11 Tower View, Kings Hill West Malling ME19 4UY Kent United Kingdom United Kingdom |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de COUNTRYSIDE PROPERTIES (HOUSEBUILDING) LIMITED ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 31 déc. 2025 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 30 sept. 2026 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2024 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour COUNTRYSIDE PROPERTIES (HOUSEBUILDING) LIMITED ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 27 juin 2026 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 11 juil. 2026 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 27 juin 2025 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour COUNTRYSIDE PROPERTIES (HOUSEBUILDING) LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |
|---|---|---|---|---|
Cessation de la nomination de Michael Philip Woolliscroft en tant que directeur le 31 mars 2026 | 1 pages | TM01 | ||
Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 déc. 2024 | 20 pages | AA | ||
legacy | 229 pages | PARENT_ACC | ||
legacy | 3 pages | GUARANTEE2 | ||
legacy | 1 pages | AGREEMENT2 | ||
Changement d'adresse du siège social de Countryside House the Drive Brentwood Essex CM13 3AT à 11 Tower View, Kings Hill West Malling Kent United Kingdom ME19 4UY le 08 juil. 2025 | 1 pages | AD01 | ||
Modification des détails de Copthorn Holdings Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 03 juil. 2025 | 2 pages | PSC05 | ||
Inscription de la charge 055553910008, créée le 02 juil. 2025 | 30 pages | MR01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 27 juin 2025 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Satisfaction de la charge 055553910006 en totalité | 1 pages | MR04 | ||
Cessation de la nomination de Earl Sibley en tant que directeur le 31 déc. 2024 | 1 pages | TM01 | ||
Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 déc. 2023 | 29 pages | AA | ||
legacy | 216 pages | PARENT_ACC | ||
legacy | 3 pages | GUARANTEE2 | ||
legacy | 1 pages | AGREEMENT2 | ||
Déclaration de confirmation établie le 27 juin 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2022 | 38 pages | AA | ||
Période comptable précédente raccourcie du 30 sept. 2023 au 31 déc. 2022 | 1 pages | AA01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 27 juin 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes annuels établis au 30 sept. 2022 | 31 pages | AA | ||
Cessation de la nomination de Philip Andrew Chapman en tant que directeur le 31 mars 2023 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Phillip Victor Lyons en tant que directeur le 31 déc. 2022 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Vistry Secretary Limited en tant que secrétaire le 29 nov. 2022 | 2 pages | AP04 | ||
Nomination de Timothy Charles Lawlor en tant qu'administrateur le 29 nov. 2022 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Gary Whitaker en tant que secrétaire le 29 nov. 2022 | 1 pages | TM02 | ||
Qui sont les dirigeants de COUNTRYSIDE PROPERTIES (HOUSEBUILDING) LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VISTRY SECRETARY LIMITED | Secrétaire | Tower View Kings Hill ME19 4UY West Malling 11 Kent United Kingdom |
| 284895390001 | ||||||||||
| BATES, Clare Jane | Administrateur | Tower View, Kings Hill West Malling ME19 4UY Kent 11 United Kingdom United Kingdom | United Kingdom | British | 178363560001 | |||||||||
| LAWLOR, Timothy Charles | Administrateur | The Drive Great Warley CM13 3AT Brentwood Countryside House Essex United Kingdom | United Kingdom | British | 302161610001 | |||||||||
| COLGRAVE, Wendy Elizabeth | Secrétaire | High Easter CM1 4RB Chelmsford Ellis Farm Essex England | British | 54431170001 | ||||||||||
| SHILLINGLAW, Gary Preston | Secrétaire | Wynsdale 9 Monkshanger GU9 8BU Farnham Surrey | British | 66825690001 | ||||||||||
| WHITAKER, Gary | Secrétaire | Countryside House The Drive CM13 3AT Brentwood Essex | 200949020001 | |||||||||||
| CARR-LOCKE, Andrew Charles Phillip | Administrateur | Countryside House The Drive CM13 3AT Brentwood Essex | United Kingdom | British | 2567850002 | |||||||||
| CHAPMAN, Philip Andrew | Administrateur | Countryside House The Drive CM13 3AT Brentwood Essex | England | British | 183918150002 | |||||||||
| CHERRY, Alan Herbert | Administrateur | Harvesters Green Street Fryerning CM4 ONS Ingatestone Essex | England | British | 2026150001 | |||||||||
| CHERRY, Graham Stewart | Administrateur | Fridays Fox Road Mashbury CM1 4TJ Chelmsford Essex | England | British | 7228590002 | |||||||||
| CHERRY, Richard Stephen | Administrateur | Countryside House The Drive CM13 3AT Brentwood Essex | United Kingdom | British | 68733260003 | |||||||||
| COLGRAVE, Wendy Elizabeth | Administrateur | High Easter CM1 4RB Chelmsford Ellis Farm Essex England | England | British | 54431170002 | |||||||||
| GUPTA, Trisha | Administrateur | 8 Lodge Road CM9 6HW Maldon Essex | United Kingdom | British | 107437190001 | |||||||||
| KELLEY, Ian Russell | Administrateur | Countryside House The Drive CM13 3AT Brentwood Essex | England | British | 81216850001 | |||||||||
| LYONS, Phillip Victor | Administrateur | Countryside House The Drive CM13 3AT Brentwood Essex | England | British | 231980680001 | |||||||||
| MCPHERSON, Iain Duncan | Administrateur | Countryside House The Drive CM13 3AT Brentwood Essex | England | British | 252865210001 | |||||||||
| SCOTT, Michael Ian | Administrateur | Countryside House The Drive CM13 3AT Brentwood Essex | United Kingdom | British | 290228130001 | |||||||||
| SIBLEY, Earl | Administrateur | Countryside House The Drive CM13 3AT Brentwood Essex | United Kingdom | British | 346400680001 | |||||||||
| SUTCLIFFE, Ian Calvert | Administrateur | Countryside House The Drive CM13 3AT Brentwood Essex | England | British | 112534590004 | |||||||||
| WOOLLISCROFT, Michael Philip | Administrateur | Tower View, Kings Hill West Malling ME19 4UY Kent 11 United Kingdom United Kingdom | United Kingdom | British | 256271880001 | |||||||||
| WORTHINGTON, Rebecca Jane | Administrateur | Countryside House The Drive CM13 3AT Brentwood Essex | England | British | 130493170001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur COUNTRYSIDE PROPERTIES (HOUSEBUILDING) LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Copthorn Holdings Limited | 06 avr. 2016 | Tower View, Kings Hill West Malling ME19 4UY Kent 11 United Kingdom United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0