ADVANCED ONCOTHERAPY PLC

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéADVANCED ONCOTHERAPY PLC
    Statut de la sociétéEn administration
    Forme juridiqueSociété anonyme cotée en bourse
    Numéro de société 05564418
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ADVANCED ONCOTHERAPY PLC ?

    • Autres activités liées à la santé humaine (86900) / Activités de santé humaine et d'action sociale

    Où se situe ADVANCED ONCOTHERAPY PLC ?

    Adresse du siège social
    110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de ADVANCED ONCOTHERAPY PLC ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    CARECAPITAL GROUP PLC12 juin 200612 juin 2006
    COPPERSILVER PUBLIC LIMITED COMPANY15 sept. 200515 sept. 2005

    Quels sont les derniers comptes de ADVANCED ONCOTHERAPY PLC ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 déc. 2022
    Date d'échéance des prochains comptes30 sept. 2023
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2021

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour ADVANCED ONCOTHERAPY PLC ?

    En retardOui
    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au15 sept. 2024
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation29 sept. 2024
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au15 sept. 2023
    En retardOui

    Quels sont les derniers dépôts pour ADVANCED ONCOTHERAPY PLC ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    24 pagesAM10

    Déclaration des affaires avec le formulaire AM02SOA

    66 pagesAM02

    Cessation de la nomination de Henry Edmund Alexander Clarke en tant que secrétaire le 14 août 2024

    1 pagesTM02

    Avis d'approbation réputée des propositions

    3 pagesAM06

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    51 pagesAM03

    Changement d'adresse du siège social de 143 Harley Street Ground Floor London W1G 6BH England à 110 Cannon Street London EC4N 6EU le 19 juin 2024

    3 pagesAD01

    Nomination d'un administrateur

    3 pagesAM01

    La procédure de radiation d'office a été suspendue

    1 pagesDISS16(SOAS)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Déclaration de confirmation établie le 15 sept. 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Inscription de la charge 055644180017, créée le 09 mai 2023

    18 pagesMR01

    Inscription de la charge 055644180018, créée le 09 mai 2023

    46 pagesMR01

    Inscription de la charge 055644180019, créée le 09 mai 2023

    22 pagesMR01

    Changement d'adresse du siège social de Level 17 Dashwood House 69 Old Broad Street London England EC2M 1QS à 143 Harley Street Ground Floor London W1G 6BH le 03 févr. 2023

    1 pagesAD01

    État du capital après une attribution d'actions au 17 oct. 2022

    • Capital: GBP 132,807,802.3
    3 pagesSH01

    Déclaration de confirmation établie le 15 sept. 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    État du capital après une attribution d'actions au 18 août 2022

    • Capital: GBP 126,807,802
    3 pagesSH01

    État du capital après une attribution d'actions au 01 août 2022

    • Capital: GBP 125,342,802.3
    3 pagesSH01

    Comptes consolidés établis au 31 déc. 2021

    155 pagesAA

    État du capital après une attribution d'actions au 28 juin 2022

    • Capital: GBP 123,723,052.8
    3 pagesSH01

    État du capital après une attribution d'actions au 10 juin 2022

    • Capital: GBP 118,338,053
    3 pagesSH01

    État du capital après une attribution d'actions au 12 avr. 2022

    • Capital: GBP 117,538,052.8
    3 pagesSH01

    Inscription de la charge 055644180015, créée le 28 mars 2022

    23 pagesMR01

    Inscription de la charge 055644180016, créée le 28 mars 2022

    24 pagesMR01

    État du capital après une attribution d'actions au 24 mars 2022

    • Capital: GBP 115,803,052.8
    3 pagesSH01

    Qui sont les dirigeants de ADVANCED ONCOTHERAPY PLC ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BRADFIELD, Michael Stephen
    Cannon Street
    EC4N 6EU London
    110
    Administrateur
    Cannon Street
    EC4N 6EU London
    110
    EnglandBritishCompany Director4184880002
    CELSING, Hans Henrik Von
    Cannon Street
    EC4N 6EU London
    110
    Administrateur
    Cannon Street
    EC4N 6EU London
    110
    United KingdomSwedishDirector223837760001
    CROSS, Lori Jo
    Cannon Street
    EC4N 6EU London
    110
    Administrateur
    Cannon Street
    EC4N 6EU London
    110
    United StatesAmericanDirector101388320001
    HAN, Chunlin
    Cannon Street
    EC4N 6EU London
    110
    Administrateur
    Cannon Street
    EC4N 6EU London
    110
    ChinaChineseInvestment Director250053040001
    MYERS, Stephen, Professor
    Cannon Street
    EC4N 6EU London
    110
    Administrateur
    Cannon Street
    EC4N 6EU London
    110
    PortugalIrish,BritishElectronic Engineer223687270001
    PLOWMAN, Piers Nicholas, Dr
    Cannon Street
    EC4N 6EU London
    110
    Administrateur
    Cannon Street
    EC4N 6EU London
    110
    United KingdomBritishSenior Radiotherapist86534500001
    SERANDOUR, Nicolas
    Cannon Street
    EC4N 6EU London
    110
    Administrateur
    Cannon Street
    EC4N 6EU London
    110
    EnglandFrenchChief Financial Officer183161770001
    SINCLAIR, Michael Jeffrey, Dr
    Cannon Street
    EC4N 6EU London
    110
    Administrateur
    Cannon Street
    EC4N 6EU London
    110
    IsraelBritishBusinessman73399780028
    VANNI, Enrico
    Cannon Street
    EC4N 6EU London
    110
    Administrateur
    Cannon Street
    EC4N 6EU London
    110
    MonacoSwissCompany Director183439500001
    ZHANG, Renhua
    Cannon Street
    EC4N 6EU London
    110
    Administrateur
    Cannon Street
    EC4N 6EU London
    110
    ChinaChineseDirector250052960001
    CLARKE, Henry Edmund Alexander
    4 Tenterden Street
    W1S 1TE London
    Third Floor
    United Kingdom
    Secrétaire
    4 Tenterden Street
    W1S 1TE London
    Third Floor
    United Kingdom
    258880470001
    OTTMANN, Ina
    Gloucester Place
    W1U 6HP London
    86
    United Kingdom
    Secrétaire
    Gloucester Place
    W1U 6HP London
    86
    United Kingdom
    152650260001
    WHITTEN, Celia Linda
    Dashwood House
    69 Old Broad Street
    EC2M 1QS London
    Level 17
    England
    England
    Secrétaire
    Dashwood House
    69 Old Broad Street
    EC2M 1QS London
    Level 17
    England
    England
    190925510001
    WILDEN, Stephen Kenneth
    Lawn Cottage Rectory Road
    Streatley
    RG8 9LE Reading
    Berkshire
    Secrétaire
    Lawn Cottage Rectory Road
    Streatley
    RG8 9LE Reading
    Berkshire
    BritishAccountant42543070001
    FILEX SERVICES LIMITED
    179 Great Portland Street
    W1W 5LS London
    Secrétaire
    179 Great Portland Street
    W1W 5LS London
    3620420001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BALADASAN, Donald Ahelan
    Croham Valley Road
    CR2 7NB South Croydon
    66
    Surrey
    United Kingdom
    Administrateur
    Croham Valley Road
    CR2 7NB South Croydon
    66
    Surrey
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector150900370001
    BOSHOFF, Christoffer Hendrik, Dr
    Gloucester Place
    W1U 6HP London
    86
    United Kingdom
    Administrateur
    Gloucester Place
    W1U 6HP London
    86
    United Kingdom
    EnglandBritishProfessor Of Cancer Medicine177216660001
    BROWN, Trevor
    10
    6300
    Eschenring
    Zug
    Switzerland
    Administrateur
    10
    6300
    Eschenring
    Zug
    Switzerland
    SwitzerlandBritishDirector170245060001
    EVANS, David Charles, Lord Evans Of Watford
    Dashwood House
    69 Old Broad Street
    EC2M 1QS London
    Level 17
    England
    England
    Administrateur
    Dashwood House
    69 Old Broad Street
    EC2M 1QS London
    Level 17
    England
    England
    EnglandBritishCompany Director12256950012
    GIBBS, Keith George
    Sharlands
    Blackboys
    TN22 5HN Uckfield
    East Sussex
    Administrateur
    Sharlands
    Blackboys
    TN22 5HN Uckfield
    East Sussex
    EnglandBritishCompany Director56358480002
    HUANG, Yuelong
    Dashwood House
    69 Old Broad Street
    EC2M 1QS London
    Level 17
    England
    Administrateur
    Dashwood House
    69 Old Broad Street
    EC2M 1QS London
    Level 17
    England
    ChinaChineseDirector250052970001
    HYMAN, Clive Mark
    West Common Way
    AL5 2LH Harpenden
    33
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    West Common Way
    AL5 2LH Harpenden
    33
    Hertfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishDirector103746450001
    KANORIA, Sanjeev, Dr
    314 Regents Park Road
    N3 2TX London
    3rd Floor
    England
    England
    Administrateur
    314 Regents Park Road
    N3 2TX London
    3rd Floor
    England
    England
    United KingdomBritishDirector53225660002
    KHEMKA, Sneh, Chief Operating Officer
    Gloucester Place
    W1U 6HP London
    86
    United Kingdom
    Administrateur
    Gloucester Place
    W1U 6HP London
    86
    United Kingdom
    EnglandBritishChief Operating Officer111965130001
    LEBUS, Timothy Andrew
    Dashwood House
    69 Old Broad Street
    EC2M 1QS London
    Level 17
    England
    England
    Administrateur
    Dashwood House
    69 Old Broad Street
    EC2M 1QS London
    Level 17
    England
    England
    EnglandBritishCompany Director6855830002
    MCDONAGH, Margaret Josephine, Baroness
    21 Clive Road
    SW19 2JA London
    Administrateur
    21 Clive Road
    SW19 2JA London
    EnglandBritishDirector104727330001
    NUTTING, Christopher Martin, Professor
    Dashwood House
    69 Old Broad Street
    EC2M 1QS London
    Level 17
    England
    England
    Administrateur
    Dashwood House
    69 Old Broad Street
    EC2M 1QS London
    Level 17
    England
    England
    EnglandBritishProfessor76390810002
    PANDYA, Sanjeev
    Dashwood House
    69 Old Broad Street
    EC2M 1QS London
    Level 17
    England
    England
    Administrateur
    Dashwood House
    69 Old Broad Street
    EC2M 1QS London
    Level 17
    England
    England
    EnglandBritishCompany Director158071330002
    SJOSTRAND, Peter Sigurd Ivar, Dr
    Dashwood House
    69 Old Broad Street
    EC2M 1QS London
    Level 17
    England
    Administrateur
    Dashwood House
    69 Old Broad Street
    EC2M 1QS London
    Level 17
    England
    SwedenSwedishMedical Doctor250052990001
    STACEY, Paul Quentin Cullum
    St. Peter's Court
    Bradwell-On-Sea
    CM0 7JE Southminster
    Victoria House
    Essex
    Administrateur
    St. Peter's Court
    Bradwell-On-Sea
    CM0 7JE Southminster
    Victoria House
    Essex
    United KingdomBritishCompany Director154497940001
    THOMSON, Euan Stuart
    Dashwood House
    69 Old Broad Street
    EC2M 1QS London
    Level 17
    England
    England
    Administrateur
    Dashwood House
    69 Old Broad Street
    EC2M 1QS London
    Level 17
    England
    England
    United StatesAmericanVenture Capitalist191466210001
    URWITZ, Bo Gabriel
    Dashwood House
    69 Old Broad Street
    EC2M 1QS London
    Level 17
    England
    Administrateur
    Dashwood House
    69 Old Broad Street
    EC2M 1QS London
    Level 17
    England
    SwedenSwedishDirector250053010001
    WILDEN, Stephen Kenneth
    Lawn Cottage Rectory Road
    Streatley
    RG8 9LE Reading
    Berkshire
    Administrateur
    Lawn Cottage Rectory Road
    Streatley
    RG8 9LE Reading
    Berkshire
    EnglandBritishAccountant42543070001
    FILEX NOMINEES LIMITED
    179 Great Portland Street
    W1W 5LS London
    Administrateur
    179 Great Portland Street
    W1W 5LS London
    67847560001

    Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour ADVANCED ONCOTHERAPY PLC ?

    Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
    Notifié leCessé leDéclaration
    26 juin 2017La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société.

    ADVANCED ONCOTHERAPY PLC a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 09 mai 2023
    Livré le 09 mai 2023
    En cours
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Glas Trust Corporation Limited as Security Agent and Trustee for the Secured Parties (As Defined in the Instrument)
    Transactions
    • 09 mai 2023Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 09 mai 2023
    Livré le 09 mai 2023
    En cours
    Brève description
    The intellectual property as described against the name of the company at schedule 2 to the instrument including, but not limited to, the trademarks with tm numbers TMAVO03, TMAVO09 and TMAVO10. For more information, please refer to the instrument.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Glas Trust Corporation Limited as Security Trustee for the Secured Parties (As Defined in the Instrument)
    Transactions
    • 09 mai 2023Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 09 mai 2023
    Livré le 09 mai 2023
    En cours
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Glas Trust Corporation Limited as Security Agent and Trustee for the Secured Parties (As Defined in the Instrument)
    Transactions
    • 09 mai 2023Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 28 mars 2022
    Livré le 04 avr. 2022
    En cours
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Nerano Pharma Limited
    Transactions
    • 04 avr. 2022Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 28 mars 2022
    Livré le 04 avr. 2022
    En cours
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Nerano Pharma Limited
    Transactions
    • 04 avr. 2022Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 10 mars 2022
    Livré le 18 mars 2022
    En cours
    Brève description
    Leasehold of part basement of 145 harley street, london W1.
    Contient une promesse négative: Oui
    Personnes ayant droit
    • Nerano Pharma Limited
    Transactions
    • 18 mars 2022Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 23 juin 2021
    Livré le 28 juin 2021
    En cours
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Nerano Pharma LTD
    Transactions
    • 28 juin 2021Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 23 juin 2021
    Livré le 28 juin 2021
    En cours
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Nerano Pharma LTD
    Transactions
    • 28 juin 2021Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 23 juin 2021
    Livré le 28 juin 2021
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Nerano Pharma LTD
    Transactions
    • 28 juin 2021Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 11 juin 2021
    Livré le 14 juin 2021
    En cours
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Nerano Pharma Limited
    Transactions
    • 14 juin 2021Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 07 mai 2021
    Livré le 10 mai 2021
    En cours
    Brève description
    Trademark "light" + logo with trademark number TMAVO03. For more details of intellectual property charged please refer to the instrument.
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Nerano Pharma LTD
    Transactions
    • 10 mai 2021Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 10 août 2020
    Livré le 19 août 2020
    En cours
    Brève description
    Trade mark TMAVO03; trade mark TMAVO09; trade mark TMAVO10; trade mark TMAVO11; trade mark TMAVO17 and certain other trade marks and patents, for more details please refer to the instrument.
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Nerano Pharma Limited
    Transactions
    • 19 août 2020Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 10 août 2020
    Livré le 19 août 2020
    En cours
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Nerano Pharma Limited
    Transactions
    • 19 août 2020Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 28 août 2019
    Livré le 16 sept. 2019
    En cours
    Brève description
    141 harley street 29 devonshire mews west and 143 harley street london (for further properties being charged please see the attache document).
    Personnes ayant droit
    • Nerano Pharma Limited
    Transactions
    • 16 sept. 2019Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 08 mai 2019
    Livré le 17 mai 2019
    Totalement satisfaite
    Brève description
    141 and 143 harley street, london.
    Personnes ayant droit
    • Nerano Pharma Limited
    Transactions
    • 17 mai 2019Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 03 sept. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 07 mai 2019
    Livré le 14 mai 2019
    En cours
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Credit Suisse Ag
    Transactions
    • 14 mai 2019Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 24 mars 2017
    Livré le 29 mars 2017
    Totalement satisfaite
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Henslow Trading Limited
    Transactions
    • 29 mars 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 13 juin 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 24 déc. 2010
    Livré le 08 janv. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from gersungheitszentrum adlershof 2 gmbh or the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Folkestone ru 8A unit bouverie place shopping centre folkestone (for further details of property charged please refer to form MG01), fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Charles Street Securities Europe LLP as Security Trustee
    Transactions
    • 08 janv. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 31 juil. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Rent and service charge deposit deed
    Créé le 12 févr. 2007
    Livré le 14 févr. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £64,419.37 due or to become due from the company to
    Brèves mentions
    All interest in a rent deposit.
    Personnes ayant droit
    • Lazari Investments Limited
    Transactions
    • 14 févr. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 déc. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)

    ADVANCED ONCOTHERAPY PLC a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    30 mai 2024Administration started
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Ian James Corfield
    2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    practitioner
    2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    David Paul Hudson
    2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    practitioner
    2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0