BROOKFIELDS CONTRACTORS MA1 LIMITED

BROOKFIELDS CONTRACTORS MA1 LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBROOKFIELDS CONTRACTORS MA1 LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 05585732
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BROOKFIELDS CONTRACTORS MA1 LIMITED ?

    • Autres travaux de finition du bâtiment (43390) / Construction

    Où se situe BROOKFIELDS CONTRACTORS MA1 LIMITED ?

    Adresse du siège social
    The Lodge
    Odell
    MK43 7BB Bedford
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de BROOKFIELDS CONTRACTORS MA1 LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 nov. 2012

    Quels sont les derniers dépôts pour BROOKFIELDS CONTRACTORS MA1 LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Cessation de la nomination de David Brian Elliott en tant que directeur le 14 oct. 2013

    2 pagesTM01

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 nov. 2012

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 06 oct. 2012 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital17 oct. 2012

    État du capital au 17 oct. 2012

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 nov. 2011

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 06 oct. 2011 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 nov. 2010

    5 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur John David Newton le 10 janv. 2011

    2 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 06 oct. 2010 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 nov. 2009

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 06 oct. 2009 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur David Brian Elliott le 06 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Colin Richard Godfrey le 06 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur John David Newton le 06 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Mark Glenn Bridgeman Shaw le 06 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 30 nov. 2008

    5 pagesAA

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    4 pages363a

    legacy

    1 pages288b

    Comptes pour une entreprise moyenne établis au 30 nov. 2007

    12 pagesAA

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    1 pages288c

    legacy

    3 pages363a

    Qui sont les dirigeants de BROOKFIELDS CONTRACTORS MA1 LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    GODFREY, Colin Richard
    Newdigate Road
    RH5 4QG Beare Green
    Broomells
    Surrey
    Secrétaire
    Newdigate Road
    RH5 4QG Beare Green
    Broomells
    Surrey
    BritishDirector125135720005
    GODFREY, Colin Richard
    Newdigate Road
    RH5 4QG Beare Green
    Broomells
    Surrey
    Administrateur
    Newdigate Road
    RH5 4QG Beare Green
    Broomells
    Surrey
    United KingdomBritishDirector125135720005
    NEWTON, John David
    Ivy Park Road
    Ranmoor
    S10 3LD Sheffield
    76
    United Kingdom
    Administrateur
    Ivy Park Road
    Ranmoor
    S10 3LD Sheffield
    76
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Surveyor91327940003
    SHAW, Mark Glenn Bridgman
    The Lodge
    High Street
    MK43 7PE Odell
    Bedfordshire
    Administrateur
    The Lodge
    High Street
    MK43 7PE Odell
    Bedfordshire
    EnglandBritishDirector146687830001
    BOSTOCK, Richard David Swinford
    Hanlye House
    Hanlye Lane
    RH17 5HR Cuckfield
    West Sussex
    Secrétaire
    Hanlye House
    Hanlye Lane
    RH17 5HR Cuckfield
    West Sussex
    BritishDirector76661730003
    IMCO SECRETARY LIMITED
    Queen Street
    LS1 2TW Leeds
    21
    West Yorkshire
    Secrétaire
    Queen Street
    LS1 2TW Leeds
    21
    West Yorkshire
    95592960001
    BOSTOCK, Richard David Swinford
    Hanlye House
    Hanlye Lane
    RH17 5HR Cuckfield
    West Sussex
    Administrateur
    Hanlye House
    Hanlye Lane
    RH17 5HR Cuckfield
    West Sussex
    BritishDirector76661730003
    BURRELL, Melvin James Edwin
    13 Hereford Road
    HG1 2NP Harrogate
    North Yorkshire
    Administrateur
    13 Hereford Road
    HG1 2NP Harrogate
    North Yorkshire
    BritishDirector9782030001
    ELLIOTT, David Brian
    56 Mowson Lane
    Worrall
    S35 0AJ Sheffield
    South Yorkshire
    Administrateur
    56 Mowson Lane
    Worrall
    S35 0AJ Sheffield
    South Yorkshire
    Great BritainBritishCompany Director67685070001
    IMCO DIRECTOR LIMITED
    21 Queen Street
    LS1 2TW Leeds
    West Yorkshire
    Administrateur
    21 Queen Street
    LS1 2TW Leeds
    West Yorkshire
    105552570001

    BROOKFIELDS CONTRACTORS MA1 LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 20 déc. 2006
    Livré le 29 déc. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 29 déc. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 21 mars 2006
    Livré le 04 avr. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Security Trustee)
    Transactions
    • 04 avr. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Construction cost account charge
    Créé le 21 mars 2006
    Livré le 29 mars 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All its right title and interest in and to an account k/a the brookfields contractors MA1 limited construction cost account numbered 06066024 and such other sums. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation (Iom) PLC as Trustee of the Tritax Next Ez Unit Trust
    Transactions
    • 29 mars 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 17 mars 2006
    Livré le 25 mars 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 25 mars 2006Enregistrement d'une charge (395)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0