LIGHTHOUSE UKCO 4 (GROUP) LIMITED

LIGHTHOUSE UKCO 4 (GROUP) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéLIGHTHOUSE UKCO 4 (GROUP) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 05586358
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de LIGHTHOUSE UKCO 4 (GROUP) LIMITED ?

    • Transformation et conservation de poissons, crustacés et mollusques (10200) / Industries manufacturières

    Où se situe LIGHTHOUSE UKCO 4 (GROUP) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Wilkin Chapman Llp, Cartergate House
    26 Chantry Lane
    DN31 2LJ Grimsby
    North East Lincolnshire
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de LIGHTHOUSE UKCO 4 (GROUP) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    FINDUS GROUP LIMITED28 mai 200928 mai 2009
    FOODVEST LIMITED08 nov. 200508 nov. 2005
    BROOMCO (3920) LIMITED07 oct. 200507 oct. 2005

    Quels sont les derniers comptes de LIGHTHOUSE UKCO 4 (GROUP) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 sept. 2018

    Quels sont les derniers dépôts pour LIGHTHOUSE UKCO 4 (GROUP) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Deuxième dépôt d'un bilan du capital suite à une émission d'actions au 03 juil. 2019

    • Capital: GBP 24,312.22
    18 pagesRP04SH01

    Nomination de Mr John Philip Madden en tant qu'administrateur le 08 nov. 2019

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de William John Showalter en tant que directeur le 11 nov. 2019

    1 pagesTM01

    Changement d'adresse du siège social de Ross House Wickham Road Grimsby North East Lincolnshire DN31 3SW à Wilkin Chapman Llp, Cartergate House 26 Chantry Lane Grimsby North East Lincolnshire DN31 2LJ le 08 nov. 2019

    1 pagesAD01

    Déclaration de confirmation établie le 07 oct. 2019 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Résolutions

    Resolutions
    41 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10
    capital

    Résolutions

    Conflicts of interest 03/07/2019
    RES13
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2018

    6 pagesAA

    État du capital après une attribution d'actions au 03 juil. 2019

    • Capital: GBP 24,312.22
    11 pagesSH01
    Annotations
    DateAnnotation
    27 nov. 2019Clarification A second filed SH01 was registered on 27/11/2019.

    Satisfaction de la charge 055863580006 en totalité

    4 pagesMR04

    Déclaration de confirmation établie le 07 oct. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes pour une société dormante établis au 30 sept. 2017

    7 pagesAA

    Modification des coordonnées du secrétaire Wilkin Chapman Company Secretarial Services Ltd le 02 janv. 2017

    1 pagesCH04

    Déclaration de confirmation établie le 07 oct. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2016

    16 pagesAA

    Statuts

    38 pagesMA

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution de modification des statuts

    RES01

    Cessation de la nomination de Karen Jeanette Noakes en tant que directeur le 01 févr. 2017

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 07 oct. 2016 avec mises à jour

    13 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 30 sept. 2015

    16 pagesAA

    Nomination de Karen Jeanette Noakes en tant qu'administrateur le 29 févr. 2016

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Guy Nicholas Anthony Faller en tant que directeur le 29 févr. 2016

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Christopher Frank Parker en tant que directeur le 31 janv. 2016

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de LIGHTHOUSE UKCO 4 (GROUP) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    WILKIN CHAPMAN COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    26 Chantry Lane
    DN31 2LJ Grimsby
    Cartergate House
    England
    Secrétaire désigné
    26 Chantry Lane
    DN31 2LJ Grimsby
    Cartergate House
    England
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement2249348
    900013350001
    MADDEN, John Philip
    26 Chantry Lane
    DN31 2LJ Grimsby
    Wilkin Chapman Llp, Cartergate House
    North East Lincolnshire
    England
    Administrateur
    26 Chantry Lane
    DN31 2LJ Grimsby
    Wilkin Chapman Llp, Cartergate House
    North East Lincolnshire
    England
    EnglandBritish264245380001
    LEADBEATER, Stephen Paul
    Allt Nam Breac
    Mill Lane, Legbourne
    LN11 8LT Louth
    Lincolnshire
    Secrétaire
    Allt Nam Breac
    Mill Lane, Legbourne
    LN11 8LT Louth
    Lincolnshire
    British84487230001
    DLA PIPER UK SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    Secrétaire
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    54146620002
    BRITTON, Christopher Paul
    Park Grange
    Main Street
    LS22 4AP Sicklinghall
    West Yorkshire
    Administrateur
    Park Grange
    Main Street
    LS22 4AP Sicklinghall
    West Yorkshire
    United KingdomBritish127835580001
    CAMPBELL, Christopher
    74 Coleherne Court
    Little Boltons
    SW5 0EF London
    Administrateur
    74 Coleherne Court
    Little Boltons
    SW5 0EF London
    American109921890001
    CANE, James Robert
    Chapel House
    Brigg Road
    LN7 6PQ South Kelsey
    Lincolnshire
    Administrateur
    Chapel House
    Brigg Road
    LN7 6PQ South Kelsey
    Lincolnshire
    United KingdomBritish104635350001
    FALLER, Guy Nicholas Anthony
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    North East Lincolnshire
    Administrateur
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    North East Lincolnshire
    United KingdomBritish108529830002
    FITZPATRICK, Seamus Philip
    Flat 1
    1 Onslow Gardens
    SW7 3LX London
    Administrateur
    Flat 1
    1 Onslow Gardens
    SW7 3LX London
    United KingdomIrish65991000003
    FORBES, Hamish Drummond
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    North East Lincolnshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    North East Lincolnshire
    United Kingdom
    EnglandBritish66295550001
    GRIFFITHS, Wynne Philip Morgan
    Hawerby Hall
    DN36 5PX Hawerby Cum Beesby
    Lincolnshire
    Administrateur
    Hawerby Hall
    DN36 5PX Hawerby Cum Beesby
    Lincolnshire
    United KingdomBritish58713750002
    HARKJAER, Per
    Strandvejen 399a
    Klampenborg
    2930
    Denmark
    Administrateur
    Strandvejen 399a
    Klampenborg
    2930
    Denmark
    Danish78882450002
    JOHANSSON, Roger
    Kompassgatan 36
    FOREIGN Malmo
    211 17
    Sweden
    Administrateur
    Kompassgatan 36
    FOREIGN Malmo
    211 17
    Sweden
    Swedish113571210001
    KARLSSON, Cecilia
    Vassarogatan 11
    Rydebaeck
    25733
    Sweden
    Administrateur
    Vassarogatan 11
    Rydebaeck
    25733
    Sweden
    Swedish113571120001
    LEADBEATER, Stephen Paul
    Allt Nam Breac
    Mill Lane, Legbourne
    LN11 8LT Louth
    Lincolnshire
    Administrateur
    Allt Nam Breac
    Mill Lane, Legbourne
    LN11 8LT Louth
    Lincolnshire
    EnglandBritish84487230001
    LITTLE, Malcolm John
    Leylandii House
    3 Shipton Road
    YO30 5RE York
    North Yorkshire
    Administrateur
    Leylandii House
    3 Shipton Road
    YO30 5RE York
    North Yorkshire
    United KingdomBritish44199400002
    MILNER, David Richard
    Park House
    Holkham
    NR23 1RN Norfolk
    Administrateur
    Park House
    Holkham
    NR23 1RN Norfolk
    United KingdomBritish150546560001
    NOAKES, Karen Jeanette
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    North East Lincolnshire
    Administrateur
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    North East Lincolnshire
    EnglandBritish134379900001
    OLSSON, Jorgen
    Grontevaegen 3
    Helsingborg
    25285
    Sweden
    Administrateur
    Grontevaegen 3
    Helsingborg
    25285
    Sweden
    Swedish113571020001
    PARKER, Christopher Frank
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    North East Lincolnshire
    Administrateur
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    North East Lincolnshire
    United KingdomBritish66681550001
    PARKER, Michael
    Humber Lodge Old Post Office Lane
    South Ferriby
    DN18 6HH Barton Upon Humber
    N E Lincolnshire
    Administrateur
    Humber Lodge Old Post Office Lane
    South Ferriby
    DN18 6HH Barton Upon Humber
    N E Lincolnshire
    United KingdomBritish2785890001
    SHOWALTER, William John
    26 Chantry Lane
    DN31 2LJ Grimsby
    Wilkin Chapman Llp, Cartergate House
    North East Lincolnshire
    England
    Administrateur
    26 Chantry Lane
    DN31 2LJ Grimsby
    Wilkin Chapman Llp, Cartergate House
    North East Lincolnshire
    England
    EnglandAmerican178622380001
    SHURE, Randl Louis
    2045 Dogwood Lane
    IRISH Charlottesville
    Virginia 22901
    Usa
    Administrateur
    2045 Dogwood Lane
    IRISH Charlottesville
    Virginia 22901
    Usa
    American94192640001
    WARD, Peter Selwyn
    155 Eastgate
    LN11 8DB Louth
    Lincolnshire
    Administrateur
    155 Eastgate
    LN11 8DB Louth
    Lincolnshire
    United KingdomBritish33803400001
    DLA PIPER UK NOMINEES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    Administrateur
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    54146610002
    DLA PIPER UK SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    Administrateur
    Fountain Precinct
    Balm Green
    S1 1RZ Sheffield
    South Yorkshire
    54146620002

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur LIGHTHOUSE UKCO 4 (GROUP) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    North East Lincolnshire
    England
    06 avr. 2016
    Wickham Road
    DN31 3SW Grimsby
    Ross House
    North East Lincolnshire
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleLaw Of England And Wales
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement06025321
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.

    LIGHTHOUSE UKCO 4 (GROUP) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 02 nov. 2015
    Livré le 09 nov. 2015
    Totalement satisfaite
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Security Agent)
    Transactions
    • 09 nov. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 13 mai 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 19 juil. 2013
    Livré le 25 juil. 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Notification of addition to or amendment of charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Societe Generale, London Branch
    Transactions
    • 25 juil. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 14 déc. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 23 oct. 2008
    Livré le 01 nov. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Societe Generale as Security Agent for the Secured Parties
    Transactions
    • 01 nov. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 juil. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 21 mars 2007
    Livré le 31 mars 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Societe Generale the Security Agent
    Transactions
    • 31 mars 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 oct. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 16 mars 2006
    Livré le 25 mars 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Societe Generale as Security Agent for the Secured Parties (The 'Security Agent')
    Transactions
    • 25 mars 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 oct. 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 12 déc. 2005
    Livré le 17 déc. 2005
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All material premises together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) and all the subsidiary shares and investments and all corresponding distribution rights. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Societe Generale (The Security Agent)
    Transactions
    • 17 déc. 2005Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 avr. 2006Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0