SPEED 100 LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSPEED 100 LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 05640059
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de SPEED 100 LIMITED ?

    • Activités de conseil en technologies de l'information (62020) / Information et communication

    Où se situe SPEED 100 LIMITED ?

    Adresse du siège social
    The Zenith Building
    26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de SPEED 100 LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    VIRTENSYS LIMITED30 nov. 200530 nov. 2005

    Quels sont les derniers comptes de SPEED 100 LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour SPEED 100 LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    12 pages4.72

    Cessation de la nomination de John Mcallister Nicholson en tant que directeur le 22 sept. 2012

    2 pagesTM01

    Changement d'adresse du siège social de 5500 Lakeside Cheadle Royal Business Park Stockport SK8 3GR le 28 sept. 2012

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution extraordinaire pour la liquidation au 21 sept. 2012

    LRESEX

    Déclaration des affaires avec le formulaire 4.19 attaché

    6 pages4.20

    Cessation de la nomination de Tomas Valis en tant que directeur le 14 août 2012

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 16 mars 2012 avec liste complète des actionnaires

    16 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital26 mars 2012

    État du capital au 26 mars 2012

    • Capital: GBP 9,879.17
    • Capital: USD 375,000
    SH01

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    Certificat de changement de nom

    Company name changed virtensys LIMITED\certificate issued on 20/02/12
    3 pagesCERTNM
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name

    Résolution de changement de nom

    RES15

    Avis de changement de nom"

    2 pagesCONNOT

    Cessation de la nomination de Peter Hayden en tant que directeur le 03 févr. 2012

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de SPEED 100 LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    LOMBARDELLI, Paul Joseph
    27 Thurlestone Drive
    Hazel Grove
    SK7 5RD Stockport
    Secrétaire
    27 Thurlestone Drive
    Hazel Grove
    SK7 5RD Stockport
    British81379720001
    PEDLEY, Timothy John
    58 Roundwood Road
    Northenden
    M22 4SF Manchester
    Secrétaire
    58 Roundwood Road
    Northenden
    M22 4SF Manchester
    BritishAccountant115475580001
    BRABERS, Alex Martin
    15a Sperrenstraat
    3110 Rotselaar
    Belgium
    Administrateur
    15a Sperrenstraat
    3110 Rotselaar
    Belgium
    DutchVenture Capitalist119542060001
    CHRISTENSEN, Mark Andrew
    5500 Lakeside
    Cheadle Royal Business Park
    SK8 3GR Stockport
    C/O Virtensys Limited
    United Kingdom
    Administrateur
    5500 Lakeside
    Cheadle Royal Business Park
    SK8 3GR Stockport
    C/O Virtensys Limited
    United Kingdom
    United StatesAmericanConsultant154745990001
    HAYDEN, Peter
    5500 Lakeside
    Cheadle Royal Business Park
    SK8 3GR Stockport
    C/O Virtensys Limited
    United Kingdom
    Administrateur
    5500 Lakeside
    Cheadle Royal Business Park
    SK8 3GR Stockport
    C/O Virtensys Limited
    United Kingdom
    United StatesAmericanRetired154746130001
    HOUSSEIN, Ahmet Dindjer
    15435 Sw Ashley Drive
    OR 97224 Tigard
    Oregon
    Usa
    Administrateur
    15435 Sw Ashley Drive
    OR 97224 Tigard
    Oregon
    Usa
    BritishCompany Director119509220001
    LOMBARDELLI, Paul Joseph
    27 Thurlestone Drive
    Hazel Grove
    SK7 5RD Stockport
    Administrateur
    27 Thurlestone Drive
    Hazel Grove
    SK7 5RD Stockport
    United KingdomBritishElectronic Engineer81379720001
    NICHOLSON, John Mcallister
    Wellington Road
    Hodnet
    TF9 3JJ Market Drayton
    Greenfields Barn
    Shropshire
    Administrateur
    Wellington Road
    Hodnet
    TF9 3JJ Market Drayton
    Greenfields Barn
    Shropshire
    EnglandBritishBusiness Consultant91072610003
    PALMER, Anthony Roger
    Highfield Road
    Cheadle Hulme
    SK8 6EL Cheadle
    2a
    Cheshire
    England
    Administrateur
    Highfield Road
    Cheadle Hulme
    SK8 6EL Cheadle
    2a
    Cheshire
    England
    EnglandBritishEngineer131290290001
    PATERSON, Andrew Stuart Weir
    27 Cleveden Drive
    Kelvinside
    G12 0SD Glasgow
    Administrateur
    27 Cleveden Drive
    Kelvinside
    G12 0SD Glasgow
    United KingdomBritishVenture Capitalist49543150003
    PIEKARSKI, Marek
    5500 Lakeside
    Cheadle Royal Business Park
    SK8 3GR Stockport
    C/O Virtensys Ebt Limited
    United Kingdom
    Administrateur
    5500 Lakeside
    Cheadle Royal Business Park
    SK8 3GR Stockport
    C/O Virtensys Ebt Limited
    United Kingdom
    United KingdomBritishElectrical Engineer160214790001
    PIEKARSKI, Marek
    Gawsworth Road
    Broken Cross
    SK11 8UE Macclesfield
    20
    Cheshire
    Administrateur
    Gawsworth Road
    Broken Cross
    SK11 8UE Macclesfield
    20
    Cheshire
    United KingdomBritishElectrical Engineer160214790001
    PIEKARSKI, Marek
    Gawsworth Road
    Broken Cross
    SK11 8UE Macclesfield
    20
    Cheshire
    Administrateur
    Gawsworth Road
    Broken Cross
    SK11 8UE Macclesfield
    20
    Cheshire
    United KingdomBritishEngineer160214790001
    ROBERTS, Andrew Henry
    The Old Keep House
    Sendmarsh Road
    GU23 7DG Woking
    Surrey
    Administrateur
    The Old Keep House
    Sendmarsh Road
    GU23 7DG Woking
    Surrey
    United KingdomBritishCompany Director41438540001
    SEVERIJNS, Rudi
    69 Ballewijerweg
    Zonhoven
    3520
    Belgium
    Administrateur
    69 Ballewijerweg
    Zonhoven
    3520
    Belgium
    BelgianVenture Capitalist115506680001
    VALIS, Tomas
    131 Grandview Road
    FOREIGN Ottawa
    Ontario K2h 8b8
    Canada
    Administrateur
    131 Grandview Road
    FOREIGN Ottawa
    Ontario K2h 8b8
    Canada
    CanadianVenture Capitalist115941920001

    SPEED 100 LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 15 déc. 2011
    Livré le 23 déc. 2011
    Partiellement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or virtensys inc. To the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Kreos Capital Iii (Luxembourg) S.A.R.L
    Transactions
    • 23 déc. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 18 févr. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 27 mai 2011
    Livré le 09 juin 2011
    Partiellement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Adviesbeheer Gimv Technology 2004 N.V
    Transactions
    • 09 juin 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 18 févr. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 27 mai 2011
    Livré le 09 juin 2011
    Partiellement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Sep Iii
    Transactions
    • 09 juin 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 18 févr. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 27 mai 2011
    Livré le 09 juin 2011
    Partiellement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Celtic House Venture Partners Fund Iii L.P.
    Transactions
    • 09 juin 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 18 févr. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 27 mai 2011
    Livré le 09 juin 2011
    Partiellement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Celtic House Venture Partners Fund Iii (Us) L.P.
    Transactions
    • 09 juin 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 18 févr. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 27 mai 2011
    Livré le 09 juin 2011
    Partiellement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Gimv N.V.
    Transactions
    • 09 juin 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 18 févr. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 22 févr. 2011
    Livré le 10 mars 2011
    Partiellement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Adviesbeheer Gimv Technology 2004 N.V. (The "Creditor")
    Transactions
    • 10 mars 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 18 févr. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 22 févr. 2011
    Livré le 10 mars 2011
    Partiellement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Gimv N.V. (The "Creditor")
    Transactions
    • 10 mars 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 18 févr. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 22 févr. 2011
    Livré le 10 mars 2011
    Partiellement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Celtic House Venture Partners Fund Iii L/P., (The "Creditor")
    Transactions
    • 10 mars 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 18 févr. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 22 févr. 2011
    Livré le 10 mars 2011
    Partiellement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Celtic House Venture Partners Fund Iii (U.S.) L/P., (the "Creditor")
    Transactions
    • 10 mars 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 18 févr. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 22 févr. 2011
    Livré le 10 mars 2011
    Partiellement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Sep Iii (The "Creditor")
    Transactions
    • 10 mars 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 18 févr. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 22 sept. 2010
    Livré le 11 oct. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Silicon Valley Bank
    Transactions
    • 11 oct. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 17 déc. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    An intellectual property security agreement
    Créé le 22 sept. 2010
    Livré le 11 oct. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All right title and interest in to and under its intellectual property see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Silicon Valley Bank
    Transactions
    • 11 oct. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 17 déc. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 22 sept. 2010
    Livré le 29 sept. 2010
    Partiellement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Kreos Capital Iii (Luxembourg) Sarl
    Transactions
    • 29 sept. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 18 févr. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 17 août 2010
    Livré le 01 sept. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Gimv N.V. (The "Creditor")
    Transactions
    • 01 sept. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 19 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 17 août 2010
    Livré le 01 sept. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Sep Iii (The "Creditor")
    Transactions
    • 01 sept. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 19 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 17 août 2010
    Livré le 01 sept. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Adviesbeheer Gimv Technology 22004 N.V. (The "Creditor")
    Transactions
    • 01 sept. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 19 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 17 août 2010
    Livré le 01 sept. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the creditor on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Celtic House Venture Partners Fund Iii (U.S.) L.P., a Delaware Limited Partnership (the "Creditor")
    Transactions
    • 01 sept. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 19 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 17 août 2010
    Livré le 01 sept. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Celtic House Venture Partners Fund Iii L.P., an Ontario Limited Partnership (The "Creditor")
    Transactions
    • 01 sept. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 19 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Rent deposit deed
    Créé le 04 juil. 2008
    Livré le 11 juil. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The sum from time to time standing to the credit of a deposit account at lloyds tsb or be any other account with any other institution and all interest and all other sums credited to either such account.
    Personnes ayant droit
    • Cravenhurst Properties Limited
    Transactions
    • 11 juil. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 27 juil. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 12 juin 2008
    Livré le 27 juin 2008
    Partiellement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Kreos Capital Iii (Luxembourg) S.A.R.L.
    Transactions
    • 27 juin 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 févr. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    SPEED 100 LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    29 nov. 2013Dissolved on
    21 sept. 2012Commencement of winding up
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Anne Clare O'Keefe
    The Zenith Building 26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    practitioner
    The Zenith Building 26 Spring Gardens
    M2 1AB Manchester
    Fraser James Gray
    Cornerstone, 107 West Regent Street
    G2 2BA Glasgow
    practitioner
    Cornerstone, 107 West Regent Street
    G2 2BA Glasgow

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0