ESPORTA HEALTH & RACQUETS CLUB LICHFIELD LIMITED

ESPORTA HEALTH & RACQUETS CLUB LICHFIELD LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéESPORTA HEALTH & RACQUETS CLUB LICHFIELD LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 05643076
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ESPORTA HEALTH & RACQUETS CLUB LICHFIELD LIMITED ?

    • (9999) /

    Où se situe ESPORTA HEALTH & RACQUETS CLUB LICHFIELD LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Active House
    21 North Fourth Street
    MK9 1HL Milton Keynes
    Buckinghamshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de ESPORTA HEALTH & RACQUETS CLUB LICHFIELD LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    JASMINEVALE LIMITED02 déc. 200502 déc. 2005

    Quels sont les derniers comptes de ESPORTA HEALTH & RACQUETS CLUB LICHFIELD LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2010

    Quels sont les derniers dépôts pour ESPORTA HEALTH & RACQUETS CLUB LICHFIELD LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    legacy

    3 pagesMG02

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 août 2011 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital26 sept. 2011

    État du capital au 26 sept. 2011

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Nomination de Matthew Graham Merrick en tant qu'administrateur

    4 pagesAP01
    Annotations
    DateAnnotation
    28 sept. 2011Clarification The document is a duplicate of AP01 registered on 12th September 2011.

    Nomination de James Archibald en tant que secrétaire

    4 pagesAP03
    Annotations
    DateAnnotation
    28 sept. 2011Clarification The document is a duplicate of AP03 registered on 12th September 2011.

    Nomination de James Archibald en tant que secrétaire le 18 juil. 2011

    3 pagesAP03

    Nomination de Matthew Graham Merrick en tant qu'administrateur le 18 juil. 2011

    3 pagesAP01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2010

    8 pagesAA

    Cessation de la nomination de Richard Lawrence Segal en tant que directeur le 18 juil. 2011

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de David Jon Leatherbarrow en tant que directeur le 18 juil. 2011

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Jog Dhody en tant que directeur le 18 juil. 2011

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Jonathan Bradley Cleland en tant que directeur le 18 juil. 2011

    2 pagesTM01

    Nomination de Mr Norman Mark Field en tant qu'administrateur le 18 juil. 2011

    3 pagesAP01

    Nomination de Mr Matthew William Bucknall en tant qu'administrateur le 18 juil. 2011

    3 pagesAP01

    Changement d'adresse du siège social de , Trinity Court, Molly Millars Lane, Wokingham, Berkshire, RG41 2PY le 08 sept. 2011

    2 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 31 août 2010 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Cessation de la nomination de Eugene Scales en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2009

    4 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur David Jon Leatherbarrow le 19 avr. 2010

    2 pagesCH01

    Nomination de Jonathan Bradley Cleland en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Modification des coordonnées du secrétaire Mr Eugene Patrick Scales le 01 oct. 2009

    1 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Jog Dhody le 01 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur David Jon Leatherbarrow le 01 oct. 2009

    2 pagesCH01

    Qui sont les dirigeants de ESPORTA HEALTH & RACQUETS CLUB LICHFIELD LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ARCHIBALD, James
    21 North Fourth Street
    MK9 1HL Milton Keynes
    Active House
    Buckinghamshire
    Secrétaire
    21 North Fourth Street
    MK9 1HL Milton Keynes
    Active House
    Buckinghamshire
    British162963110001
    BUCKNALL, Matthew William
    21 North Fourth Street
    MK9 1HL Milton Keynes
    Active House
    Buckinghamshire
    Administrateur
    21 North Fourth Street
    MK9 1HL Milton Keynes
    Active House
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishCompany Director162066820001
    FIELD, Norman Mark
    21 North Fourth Street
    MK9 1HL Milton Keynes
    Active House
    Buckinghamshire
    Administrateur
    21 North Fourth Street
    MK9 1HL Milton Keynes
    Active House
    Buckinghamshire
    United KingdomSouth AfricanManaging Director161860310001
    MERRICK, Matthew Graham
    21 North Fourth Street
    MK9 1HL Milton Keynes
    Active House
    Buckinghamshire
    Administrateur
    21 North Fourth Street
    MK9 1HL Milton Keynes
    Active House
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishUk Finance Director162110530001
    SCALES, Eugene Patrick
    Trinity Court
    Molly Millars Lane
    RG41 2PY Wokingham
    Berkshire
    Secrétaire
    Trinity Court
    Molly Millars Lane
    RG41 2PY Wokingham
    Berkshire
    Other124193970001
    TYSON, Roger Thomas Virley
    2 Gadd Close
    RG40 5PQ Wokingham
    Berkshire
    Secrétaire
    2 Gadd Close
    RG40 5PQ Wokingham
    Berkshire
    British113777700001
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Secrétaire désigné
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    900005620001
    BALL, Michael David
    Mulberry House
    Trumps Green Road
    GU25 4JA Virginia Water
    Surrey
    Administrateur
    Mulberry House
    Trumps Green Road
    GU25 4JA Virginia Water
    Surrey
    United KingdomBritishFinance Director Esporta Group58961410002
    CHARLTON, Stephen Paul
    9 Rowan Close
    L40 4LP Burscough
    Lancashire
    Administrateur
    9 Rowan Close
    L40 4LP Burscough
    Lancashire
    EnglandBritishExecutive Director, Esporta Gr96743210001
    CLELAND, Jonathan Bradley
    21 North Fourth Street
    MK9 1HL Milton Keynes
    Active House
    Buckinghamshire
    Administrateur
    21 North Fourth Street
    MK9 1HL Milton Keynes
    Active House
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishDirector146698270001
    DHODY, Jog
    21 North Fourth Street
    MK9 1HL Milton Keynes
    Active House
    Buckinghamshire
    Administrateur
    21 North Fourth Street
    MK9 1HL Milton Keynes
    Active House
    Buckinghamshire
    United KingdomBritishChief Financial Officer, Esporta Gr104269910002
    GILLIS, Neil Duncan
    Lodge Farm
    High Street, Thelnetham
    IP22 1JL Diss
    Norfolk
    Administrateur
    Lodge Farm
    High Street, Thelnetham
    IP22 1JL Diss
    Norfolk
    EnglandBritishChief Executive, Esporta Group69204500003
    GUYER, Paul John
    Oakwood House
    29 Leydene Park
    GU32 1HF East Meon
    Hampshire
    Administrateur
    Oakwood House
    29 Leydene Park
    GU32 1HF East Meon
    Hampshire
    BritishDivisional Director Esporta Gr100971720002
    HALL, Andrew James
    Tanglewood
    3 Badingham Drive
    AL5 2DA Harpenden
    Hertfordshire
    Administrateur
    Tanglewood
    3 Badingham Drive
    AL5 2DA Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritishCompany Director30306840002
    LEATHERBARROW, David Jon
    21 North Fourth Street
    MK9 1HL Milton Keynes
    Active House
    Buckinghamshire
    Administrateur
    21 North Fourth Street
    MK9 1HL Milton Keynes
    Active House
    Buckinghamshire
    EnglandBritishDirector135618280002
    LEVY, Adrian Joseph Morris
    2 Carlisle Gardens
    HA3 0JX Harrow
    Middlesex
    Administrateur
    2 Carlisle Gardens
    HA3 0JX Harrow
    Middlesex
    United KingdomBritishSolicitor147682410001
    MCGUIGAN, Marc Edward
    Avadi
    Chapel Lane
    GL20 7ER Tewkesbury
    Gloucester
    Administrateur
    Avadi
    Chapel Lane
    GL20 7ER Tewkesbury
    Gloucester
    EnglandBritishOperations Director Esporta Gr93677590002
    MOORE, Trevor Philip
    Malmsmead
    Bayleys Hill
    TN14 6HS Sevenoaks
    Kent
    Administrateur
    Malmsmead
    Bayleys Hill
    TN14 6HS Sevenoaks
    Kent
    United KingdomBritishManaging Director Operations113047410001
    PUDGE, David John
    20 Herondale Avenue
    SW18 3JL London
    Administrateur désigné
    20 Herondale Avenue
    SW18 3JL London
    British900028170001
    SEGAL, Richard Lawrence
    21 North Fourth Street
    MK9 1HL Milton Keynes
    Active House
    Buckinghamshire
    Administrateur
    21 North Fourth Street
    MK9 1HL Milton Keynes
    Active House
    Buckinghamshire
    EnglandBritishDirector138744060001
    TIMMS, Glenn Gordon
    8 Haywards Close
    RG9 1UY Henley On Thames
    Oxfordshire
    Administrateur
    8 Haywards Close
    RG9 1UY Henley On Thames
    Oxfordshire
    BritishChief Executive, Esporta Group54133140004

    ESPORTA HEALTH & RACQUETS CLUB LICHFIELD LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Fixed and floating security document
    Créé le 18 juin 2009
    Livré le 26 juin 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company or any other chargor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Societe Generale as Security Trustee for the Benefit of the Secured Parties
    Transactions
    • 26 juin 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 oct. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Group debenture
    Créé le 08 févr. 2006
    Livré le 18 févr. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Security Trustee for the Secured Parties)(in Such Capacity the "Security Agent")
    Transactions
    • 18 févr. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 mars 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0