BL HEALTH CLUBS PH NO 2 LIMITED

BL HEALTH CLUBS PH NO 2 LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBL HEALTH CLUBS PH NO 2 LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 05643261
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BL HEALTH CLUBS PH NO 2 LIMITED ?

    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe BL HEALTH CLUBS PH NO 2 LIMITED ?

    Adresse du siège social
    York House
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de BL HEALTH CLUBS PH NO 2 LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    EPH NO 2 LIMITED16 janv. 200616 janv. 2006
    JARVIEW LIMITED02 déc. 200502 déc. 2005

    Quels sont les derniers comptes de BL HEALTH CLUBS PH NO 2 LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2022

    Quels sont les derniers dépôts pour BL HEALTH CLUBS PH NO 2 LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Déclaration de confirmation établie le 30 août 2023 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Cessation de Bl Hc Dollview Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 25 nov. 2022

    1 pagesPSC07

    Notification de Bl Retail Warehousing Holding Company Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 25 nov. 2022

    2 pagesPSC02

    Cessation de la nomination de Katherine Fyfe en tant que directeur le 17 oct. 2022

    1 pagesTM01

    Déclaration de confirmation établie le 30 août 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs Katherine Fyfe le 20 juil. 2022

    2 pagesCH01

    Nomination de Mrs Katherine Fyfe en tant qu'administrateur le 20 juil. 2022

    2 pagesAP01
    Annotations
    DateAnnotation
    23 mai 2023Other The address of any individual marked (#) was replaced with a service address or partially redacted on 23/05/2023 under section 1088 of the Companies Act 2006

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2022

    5 pagesAA

    Cessation de la nomination de Charles John Middleton en tant que directeur le 31 mars 2022

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Nick Taunt en tant qu'administrateur le 18 mars 2022

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Gavin Bergin en tant qu'administrateur le 18 mars 2022

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Jonathan Charles Mcnuff en tant que directeur le 18 mars 2022

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2021

    4 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 30 août 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 mars 2020

    16 pagesAA

    legacy

    231 pagesPARENT_ACC

    legacy

    3 pagesGUARANTEE2

    legacy

    1 pagesAGREEMENT2

    legacy

    1 pagesAGREEMENT2

    legacy

    3 pagesGUARANTEE2

    Déclaration de confirmation établie le 30 août 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 mars 2019

    16 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de BL HEALTH CLUBS PH NO 2 LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BRITISH LAND COMPANY SECRETARIAL LIMITED
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Secrétaire
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrement8992198
    187856670001
    BERGIN, Gavin
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Administrateur
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Secretary251327820001
    TAUNT, Nick
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Administrateur
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant275050860001
    EKPO, Ndiana
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Secrétaire
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    162244110001
    SCALES, Eugene Patrick
    Trinity Court
    Molly Millars Lane
    RG41 2PY Wokingham
    Berkshire
    Secrétaire
    Trinity Court
    Molly Millars Lane
    RG41 2PY Wokingham
    Berkshire
    Other124193970001
    TYSON, Roger Thomas Virley
    2 Gadd Close
    RG40 5PQ Wokingham
    Berkshire
    Secrétaire
    2 Gadd Close
    RG40 5PQ Wokingham
    Berkshire
    British113777700001
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Secrétaire désigné
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    900005620001
    BALL, Michael David
    Mulberry House
    Trumps Green Road
    GU25 4JA Virginia Water
    Surrey
    Administrateur
    Mulberry House
    Trumps Green Road
    GU25 4JA Virginia Water
    Surrey
    United KingdomBritishFinance Director Esporta Group58961410002
    BARZYCKI, Sarah Morrell
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Administrateur
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritishHead Of Finance58016770004
    BELL, Lucinda Margaret
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Administrateur
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Accountant32809050044
    BRAINE, Anthony
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Administrateur
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Secretary32809000002
    CARTER, Simon Geoffrey
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Administrateur
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritishTreasury Executive170891060001
    CHARLTON, Stephen Paul
    9 Rowan Close
    L40 4LP Burscough
    Lancashire
    Administrateur
    9 Rowan Close
    L40 4LP Burscough
    Lancashire
    EnglandBritishExecutive Director, Esporta Gr96743210001
    CLELAND, Jonathan Bradley
    Trinity Court
    Molly Millars Lane
    RG41 2PY Wokingham
    Berkshire
    Administrateur
    Trinity Court
    Molly Millars Lane
    RG41 2PY Wokingham
    Berkshire
    United KingdomBritishDirector146698270001
    COUPE, David John
    1 Chelsea House
    13 Edith Grove
    SW10 0JZ London
    Administrateur
    1 Chelsea House
    13 Edith Grove
    SW10 0JZ London
    United KingdomBritishSolicitor125432970002
    DHODY, Jog
    Trinity Court
    Molly Millars Lane
    RG41 2PY Wokingham
    Berkshire
    Administrateur
    Trinity Court
    Molly Millars Lane
    RG41 2PY Wokingham
    Berkshire
    United KingdomBritishChief Financial Officer, Esporta Gr104269910002
    FORSHAW, Christopher Michael John
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Administrateur
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director1898090001
    FYFE, Katherine
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Administrateur
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    EnglandBritishAssistant Company Secretary293284010001
    GILLIS, Neil Duncan
    Lodge Farm
    High Street, Thelnetham
    IP22 1JL Diss
    Norfolk
    Administrateur
    Lodge Farm
    High Street, Thelnetham
    IP22 1JL Diss
    Norfolk
    EnglandBritishChief Executive, Esporta Grou69204500003
    GROSE, Benjamin Toby
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Administrateur
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Surveyor146546000001
    GROSE, Benjamin Toby
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Administrateur
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Surveyor146546000001
    GUYER, Paul John
    Oakwood House
    29 Leydene Park
    GU32 1HF East Meon
    Hampshire
    Administrateur
    Oakwood House
    29 Leydene Park
    GU32 1HF East Meon
    Hampshire
    BritishDivisional Director, Esporta G100971720002
    HALL, Andrew James
    Tanglewood
    3 Badingham Drive
    AL5 2DA Harpenden
    Hertfordshire
    Administrateur
    Tanglewood
    3 Badingham Drive
    AL5 2DA Harpenden
    Hertfordshire
    EnglandBritishCompany Director30306840002
    LEATHERBARROW, David Jon
    Trinity Court
    Molly Millars Lane
    RG41 2PY Wokingham
    Berkshire
    Administrateur
    Trinity Court
    Molly Millars Lane
    RG41 2PY Wokingham
    Berkshire
    EnglandBritishDirector135618280002
    LEVY, Adrian Joseph Morris
    2 Carlisle Gardens
    HA3 0JX Harrow
    Middlesex
    Administrateur
    2 Carlisle Gardens
    HA3 0JX Harrow
    Middlesex
    United KingdomBritishSolicitor147682410001
    MCGUIGAN, Marc Edward
    Avadi
    Chapel Lane
    GL20 7ER Tewkesbury
    Gloucester
    Administrateur
    Avadi
    Chapel Lane
    GL20 7ER Tewkesbury
    Gloucester
    EnglandBritishOperations Director Esporta Gr93677590002
    MCNUFF, Jonathan Charles
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    Administrateur
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant205624050001
    MIDDLETON, Charles John
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    Administrateur
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    United KingdomBritishCorporate Tax Executive79841030002
    MOORE, Trevor Philip
    Malmsmead
    Bayleys Hill
    TN14 6HS Sevenoaks
    Kent
    Administrateur
    Malmsmead
    Bayleys Hill
    TN14 6HS Sevenoaks
    Kent
    United KingdomBritishManaging Director Operations113047410001
    PENRICE, Victoria Margaret
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    Administrateur
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Secretary189931090001
    PUDGE, David John
    20 Herondale Avenue
    SW18 3JL London
    Administrateur désigné
    20 Herondale Avenue
    SW18 3JL London
    British900028170001
    REDBURN, Timothy John
    Little Abbotts Snower Hill Road
    RH3 7AQ Betchworth
    Surrey
    Administrateur
    Little Abbotts Snower Hill Road
    RH3 7AQ Betchworth
    Surrey
    EnglandBritishInterim Finance Director22018030002
    ROBERTS, Timothy Andrew
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    Administrateur
    Seymour Street
    York House
    W1H 7LX London
    45
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Surveyor63986410004
    SEGAL, Richard Lawrence
    Trinity Court
    Molly Millars Lane
    RG41 2PY Wokingham
    Berkshire
    Administrateur
    Trinity Court
    Molly Millars Lane
    RG41 2PY Wokingham
    Berkshire
    EnglandBritishDirector138744060001
    SIHRA, Harcharanjit Singh
    53 Cavendish Meads
    Sunninghill
    SL5 9TB Ascot
    Berkshire
    Administrateur
    53 Cavendish Meads
    Sunninghill
    SL5 9TB Ascot
    Berkshire
    United KingdomBritishExecutive83360810002

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur BL HEALTH CLUBS PH NO 2 LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Bl Retail Warehousing Holding Company Limited
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    25 nov. 2022
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementEngland
    Numéro d'enregistrement06002154
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.
    Bl Hc Dollview Limited
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    06 avr. 2016
    45 Seymour Street
    W1H 7LX London
    York House
    England
    Oui
    Forme juridiquePrivate Company Limited By Shares
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.
    • La personne a le droit d'exercer, ou exerce effectivement, une influence ou un contrôle significatif sur la société.

    BL HEALTH CLUBS PH NO 2 LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Fixed and floating security document
    Créé le 18 juin 2009
    Livré le 26 juin 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company or any other obligor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Societe Generale as Security Agent for the Benefit of the Secured Parties
    Transactions
    • 26 juin 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 juil. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 08 mai 2006
    Livré le 25 mai 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any present or future obligor and/or member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Security Trustee for the Secured Parties(in Such Capacity, the Security Agent)
    Transactions
    • 25 mai 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 mars 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Group debenture
    Créé le 08 mai 2006
    Livré le 24 mai 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any obligor and/or member of the group to the chargee and/or the other secured parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Security Agent)
    Transactions
    • 24 mai 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 mars 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 08 mai 2006
    Livré le 20 mai 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any present or future obligor and/or member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Security Agent)
    Transactions
    • 20 mai 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 mars 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0