BL HEALTH CLUBS PH NO 2 LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | BL HEALTH CLUBS PH NO 2 LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 05643261 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe BL HEALTH CLUBS PH NO 2 LIMITED ?
Adresse du siège social | York House 45 Seymour Street W1H 7LX London |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de BL HEALTH CLUBS PH NO 2 LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2022 |
Quels sont les derniers dépôts pour BL HEALTH CLUBS PH NO 2 LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||
Déclaration de confirmation établie le 30 août 2023 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||
Cessation de Bl Hc Dollview Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 25 nov. 2022 | 1 pages | PSC07 | ||||||
Notification de Bl Retail Warehousing Holding Company Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 25 nov. 2022 | 2 pages | PSC02 | ||||||
Cessation de la nomination de Katherine Fyfe en tant que directeur le 17 oct. 2022 | 1 pages | TM01 | ||||||
Déclaration de confirmation établie le 30 août 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mrs Katherine Fyfe le 20 juil. 2022 | 2 pages | CH01 | ||||||
Nomination de Mrs Katherine Fyfe en tant qu'administrateur le 20 juil. 2022 | 2 pages | AP01 | ||||||
| ||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2022 | 5 pages | AA | ||||||
Cessation de la nomination de Charles John Middleton en tant que directeur le 31 mars 2022 | 1 pages | TM01 | ||||||
Nomination de Mr Nick Taunt en tant qu'administrateur le 18 mars 2022 | 2 pages | AP01 | ||||||
Nomination de Mr Gavin Bergin en tant qu'administrateur le 18 mars 2022 | 2 pages | AP01 | ||||||
Cessation de la nomination de Jonathan Charles Mcnuff en tant que directeur le 18 mars 2022 | 1 pages | TM01 | ||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2021 | 4 pages | AA | ||||||
Déclaration de confirmation établie le 30 août 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||
Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 mars 2020 | 16 pages | AA | ||||||
legacy | 231 pages | PARENT_ACC | ||||||
legacy | 3 pages | GUARANTEE2 | ||||||
legacy | 1 pages | AGREEMENT2 | ||||||
legacy | 1 pages | AGREEMENT2 | ||||||
legacy | 3 pages | GUARANTEE2 | ||||||
Déclaration de confirmation établie le 30 août 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||
Comptes de filiale exemptée d'audit établis au 31 mars 2019 | 16 pages | AA | ||||||
Qui sont les dirigeants de BL HEALTH CLUBS PH NO 2 LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRITISH LAND COMPANY SECRETARIAL LIMITED | Secrétaire | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom |
| 187856670001 | ||||||||||
BERGIN, Gavin | Administrateur | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Secretary | 251327820001 | ||||||||
TAUNT, Nick | Administrateur | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 275050860001 | ||||||||
EKPO, Ndiana | Secrétaire | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | 162244110001 | |||||||||||
SCALES, Eugene Patrick | Secrétaire | Trinity Court Molly Millars Lane RG41 2PY Wokingham Berkshire | Other | 124193970001 | ||||||||||
TYSON, Roger Thomas Virley | Secrétaire | 2 Gadd Close RG40 5PQ Wokingham Berkshire | British | 113777700001 | ||||||||||
CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED | Secrétaire désigné | 10 Upper Bank Street E14 5JJ London | 900005620001 | |||||||||||
BALL, Michael David | Administrateur | Mulberry House Trumps Green Road GU25 4JA Virginia Water Surrey | United Kingdom | British | Finance Director Esporta Group | 58961410002 | ||||||||
BARZYCKI, Sarah Morrell | Administrateur | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | Head Of Finance | 58016770004 | ||||||||
BELL, Lucinda Margaret | Administrateur | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | England | British | Chartered Accountant | 32809050044 | ||||||||
BRAINE, Anthony | Administrateur | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Secretary | 32809000002 | ||||||||
CARTER, Simon Geoffrey | Administrateur | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | Treasury Executive | 170891060001 | ||||||||
CHARLTON, Stephen Paul | Administrateur | 9 Rowan Close L40 4LP Burscough Lancashire | England | British | Executive Director, Esporta Gr | 96743210001 | ||||||||
CLELAND, Jonathan Bradley | Administrateur | Trinity Court Molly Millars Lane RG41 2PY Wokingham Berkshire | United Kingdom | British | Director | 146698270001 | ||||||||
COUPE, David John | Administrateur | 1 Chelsea House 13 Edith Grove SW10 0JZ London | United Kingdom | British | Solicitor | 125432970002 | ||||||||
DHODY, Jog | Administrateur | Trinity Court Molly Millars Lane RG41 2PY Wokingham Berkshire | United Kingdom | British | Chief Financial Officer, Esporta Gr | 104269910002 | ||||||||
FORSHAW, Christopher Michael John | Administrateur | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | England | British | Company Director | 1898090001 | ||||||||
FYFE, Katherine | Administrateur | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | England | British | Assistant Company Secretary | 293284010001 | ||||||||
GILLIS, Neil Duncan | Administrateur | Lodge Farm High Street, Thelnetham IP22 1JL Diss Norfolk | England | British | Chief Executive, Esporta Grou | 69204500003 | ||||||||
GROSE, Benjamin Toby | Administrateur | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 146546000001 | ||||||||
GROSE, Benjamin Toby | Administrateur | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Surveyor | 146546000001 | ||||||||
GUYER, Paul John | Administrateur | Oakwood House 29 Leydene Park GU32 1HF East Meon Hampshire | British | Divisional Director, Esporta G | 100971720002 | |||||||||
HALL, Andrew James | Administrateur | Tanglewood 3 Badingham Drive AL5 2DA Harpenden Hertfordshire | England | British | Company Director | 30306840002 | ||||||||
LEATHERBARROW, David Jon | Administrateur | Trinity Court Molly Millars Lane RG41 2PY Wokingham Berkshire | England | British | Director | 135618280002 | ||||||||
LEVY, Adrian Joseph Morris | Administrateur | 2 Carlisle Gardens HA3 0JX Harrow Middlesex | United Kingdom | British | Solicitor | 147682410001 | ||||||||
MCGUIGAN, Marc Edward | Administrateur | Avadi Chapel Lane GL20 7ER Tewkesbury Gloucester | England | British | Operations Director Esporta Gr | 93677590002 | ||||||||
MCNUFF, Jonathan Charles | Administrateur | Seymour Street York House W1H 7LX London 45 United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 205624050001 | ||||||||
MIDDLETON, Charles John | Administrateur | Seymour Street York House W1H 7LX London 45 United Kingdom | United Kingdom | British | Corporate Tax Executive | 79841030002 | ||||||||
MOORE, Trevor Philip | Administrateur | Malmsmead Bayleys Hill TN14 6HS Sevenoaks Kent | United Kingdom | British | Managing Director Operations | 113047410001 | ||||||||
PENRICE, Victoria Margaret | Administrateur | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House United Kingdom | England | British | Company Secretary | 189931090001 | ||||||||
PUDGE, David John | Administrateur désigné | 20 Herondale Avenue SW18 3JL London | British | 900028170001 | ||||||||||
REDBURN, Timothy John | Administrateur | Little Abbotts Snower Hill Road RH3 7AQ Betchworth Surrey | England | British | Interim Finance Director | 22018030002 | ||||||||
ROBERTS, Timothy Andrew | Administrateur | Seymour Street York House W1H 7LX London 45 United Kingdom | England | British | Chartered Surveyor | 63986410004 | ||||||||
SEGAL, Richard Lawrence | Administrateur | Trinity Court Molly Millars Lane RG41 2PY Wokingham Berkshire | England | British | Director | 138744060001 | ||||||||
SIHRA, Harcharanjit Singh | Administrateur | 53 Cavendish Meads Sunninghill SL5 9TB Ascot Berkshire | United Kingdom | British | Executive | 83360810002 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur BL HEALTH CLUBS PH NO 2 LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bl Retail Warehousing Holding Company Limited | 25 nov. 2022 | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Bl Hc Dollview Limited | 06 avr. 2016 | 45 Seymour Street W1H 7LX London York House England | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
BL HEALTH CLUBS PH NO 2 LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Fixed and floating security document | Créé le 18 juin 2009 Livré le 26 juin 2009 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company or any other obligor to any secured party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 08 mai 2006 Livré le 25 mai 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from any present or future obligor and/or member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Group debenture | Créé le 08 mai 2006 Livré le 24 mai 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from any obligor and/or member of the group to the chargee and/or the other secured parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 08 mai 2006 Livré le 20 mai 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from any present or future obligor and/or member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0