STEELITE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

STEELITE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSTEELITE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 05643848
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de STEELITE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED ?

    • fabrication d'autres produits en céramique n.c.a. (23490) / Industries manufacturières

    Où se situe STEELITE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Steelite International Limited Orme Street
    Burslem
    ST6 3RB Stoke-On-Trent
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de STEELITE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2019

    Quels sont les derniers dépôts pour STEELITE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2019

    16 pagesAA

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 22 déc. 2020

    • Capital: GBP 1.00
    3 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Share premium account cancelled 03/12/2020
    RES13
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Satisfaction de la charge 056438480007 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 056438480008 en totalité

    1 pagesMR04

    Inscription de la charge 056438480008, créée le 24 mars 2020

    85 pagesMR01

    Cessation de la nomination de Andrew Wiechkoske en tant que directeur le 20 déc. 2019

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Michael Rost en tant que directeur le 20 déc. 2019

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Brody Donahue Lynn en tant qu'administrateur le 20 déc. 2019

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 02 déc. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2018

    15 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 02 déc. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2017

    16 pagesAA

    Cessation de la nomination de Neil Hooper en tant que directeur le 26 mars 2018

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Philip Ray en tant que secrétaire le 16 févr. 2018

    2 pagesAP03

    Changement d'adresse du siège social de The Broadgate Tower Third Floor 20 Primrose Street London EC2A 2RS United Kingdom à Steelite International Limited Orme Street Burslem Stoke-on-Trent ST6 3RB le 14 févr. 2018

    1 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Reed Smith Corporate Services Limited en tant que secrétaire le 01 févr. 2018

    1 pagesTM02

    Déclaration de confirmation établie le 02 déc. 2017 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2016

    16 pagesAA

    legacy

    17 pagesRP04CS01

    Qui sont les dirigeants de STEELITE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    RAY, Philip
    Orme Street
    Burslem
    ST6 3RB Stoke-On-Trent
    Steelite International Limited
    England
    Secrétaire
    Orme Street
    Burslem
    ST6 3RB Stoke-On-Trent
    Steelite International Limited
    England
    243600570001
    CAMERON, Jonathan Ian Duncan
    Burslem
    ST6 3RB Stoke-On-Trent
    Orme Street
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Burslem
    ST6 3RB Stoke-On-Trent
    Orme Street
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishFinance Director158270840001
    LYNN, Brody Donahue
    Orme Street
    Burslem
    ST6 3RB Stoke-On-Trent
    Steelite International Limited
    England
    Administrateur
    Orme Street
    Burslem
    ST6 3RB Stoke-On-Trent
    Steelite International Limited
    England
    United StatesAmericanDirector265559020001
    MILES, John David
    Orme Street, Burslem
    Stoke-On-Trent
    ST6 3RB Staffordshire
    Administrateur
    Orme Street, Burslem
    Stoke-On-Trent
    ST6 3RB Staffordshire
    United StatesAmericanCompany Director209524620001
    POOLE, Richard Edwin
    Orme Street, Burslem
    Stoke-On-Trent
    ST6 3RB Staffordshire
    Secrétaire
    Orme Street, Burslem
    Stoke-On-Trent
    ST6 3RB Staffordshire
    British13405890004
    REED SMITH CORPORATE SERVICES LIMITED
    Third Floor
    20 Primrose Street
    EC2A 2RS London
    The Broadgate Tower
    United Kingdom
    Secrétaire
    Third Floor
    20 Primrose Street
    EC2A 2RS London
    The Broadgate Tower
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement1865431
    128914620002
    ARKLEY, Alistair Grant
    Orme Street, Burslem
    Stoke-On-Trent
    ST6 3RB Staffordshire
    Administrateur
    Orme Street, Burslem
    Stoke-On-Trent
    ST6 3RB Staffordshire
    United KingdomBritishCompany Director16410280002
    HOOPER, Neil
    Burslem
    ST6 3RB Stoke-On-Trent
    Orme Street
    Staffordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Burslem
    ST6 3RB Stoke-On-Trent
    Orme Street
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishManaging Director209546690001
    MATTHEWS, Bernard
    Orme Street, Burslem
    Stoke-On-Trent
    ST6 3RB Staffordshire
    Administrateur
    Orme Street, Burslem
    Stoke-On-Trent
    ST6 3RB Staffordshire
    United KingdomEnglishCompany Director13448230002
    MEANOCK, Timothy James Ian
    37-43
    Sackville Street
    W1S 3DL London
    Pegasus House
    England
    Administrateur
    37-43
    Sackville Street
    W1S 3DL London
    Pegasus House
    England
    EnglandBritishInvestment Manager158599690001
    OAKES, Kevin Graham
    Orme Street, Burslem
    Stoke-On-Trent
    ST6 3RB Staffordshire
    Administrateur
    Orme Street, Burslem
    Stoke-On-Trent
    ST6 3RB Staffordshire
    United KingdomBritishDirector111230310001
    POOLE, Richard Edwin
    Orme Street, Burslem
    Stoke-On-Trent
    ST6 3RB Staffordshire
    Administrateur
    Orme Street, Burslem
    Stoke-On-Trent
    ST6 3RB Staffordshire
    United KingdomBritishCompany Director13405890004
    ROST, Michael
    620 Liberty Avenue
    22nd Floor
    15222 Pittsburgh
    C/O Pnc Riverarch Capital
    Pennsylvania
    United States
    Administrateur
    620 Liberty Avenue
    22nd Floor
    15222 Pittsburgh
    C/O Pnc Riverarch Capital
    Pennsylvania
    United States
    United StatesAmericanManaging Director - Private Equity208446140001
    SEABROOK, Michael Richard
    Broadacre Gardens
    236 Grange Road Dorridge
    B93 8QB Solihull
    5
    West Midlands
    England
    Administrateur
    Broadacre Gardens
    236 Grange Road Dorridge
    B93 8QB Solihull
    5
    West Midlands
    England
    EnglandBritishSolicitor1577930002
    WIECHKOSKE, Andrew
    620 Liberty Avenue
    22nd Floor
    15222 Pittsburgh
    C/O Pnc Riverarch Capital
    Pennsylvania
    United States
    Administrateur
    620 Liberty Avenue
    22nd Floor
    15222 Pittsburgh
    C/O Pnc Riverarch Capital
    Pennsylvania
    United States
    United StatesAmericanDirector - Private Equity208446150001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur STEELITE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Third Floor
    20 Primrose Street
    EC2A 2RS London
    The Broadgate Tower
    United Kingdom
    14 juin 2016
    Third Floor
    20 Primrose Street
    EC2A 2RS London
    The Broadgate Tower
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement10196646
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.
    Mr Richard Edwin Poole
    Orme Street
    Burslem
    ST6 3RB Stoke-On-Trent
    United Kingdom
    08 juin 2016
    Orme Street
    Burslem
    ST6 3RB Stoke-On-Trent
    United Kingdom
    Oui
    Nationalité: British
    Pays de résidence: United Kingdom
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des droits de vote dans la société.
    Mr Kevin Graham Oakes
    Orme Street
    Burslem
    ST6 3RB Stoke-On-Trent
    United Kingdom
    08 juin 2016
    Orme Street
    Burslem
    ST6 3RB Stoke-On-Trent
    United Kingdom
    Oui
    Nationalité: British
    Pays de résidence: England
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 25 % mais pas plus de 50 % des droits de vote dans la société.

    Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour STEELITE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED ?

    Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
    Notifié leCessé leDéclaration
    06 avr. 201608 juin 2016La société n'a pas encore achevé les mesures raisonnables pour déterminer si une personne est une personne enregistrable ou une entité juridique pertinente enregistrable en relation avec la société.

    STEELITE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 24 mars 2020
    Livré le 27 mars 2020
    Totalement satisfaite
    Brève description
    All present and future freehold or leasehold property, other than excluded property and all intellectual property pursuant to clause 3 of the accompanying copy instrument.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bmo Harris Bank N.A.
    Transactions
    • 27 mars 2020Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 15 déc. 2020Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 14 juin 2016
    Livré le 24 juin 2016
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Land:. Various freehold and leasehold property, including the freehold land at shirley street, adjacent to dalehall works, stoke-on-trent with the title number SF592830. For further details of all of the properties charged, please see schedule 2 of the charging document.. Intellectual property:. Various intellectual property, including the dunn bennett trademark with serial number 2374104 and registration number 2374104. for further details of all of the intellectual property charged, please see schedule 7 of the charging document.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Bmo Harris Bank N.A. as Security Agent
    Transactions
    • 24 juin 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 15 déc. 2020Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 23 déc. 2013
    Livré le 07 janv. 2014
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Land and buildings adjacent to newcastle street, burslem, stoke-on-trent t/no SF504131. Land and buildings on the east side of station street, longport, stoke-on-trent t/no SF504132. Notification of addition to or amendment of charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 07 janv. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 30 juin 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 21 oct. 2011
    Livré le 10 nov. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the obligors to the security beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    For details of property charged please refer to form MG01. Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC (In Its Capacity as Security Trustee for the Security Beneficiaries)
    Transactions
    • 10 nov. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 07 janv. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of assignment of keyman life policy
    Créé le 20 nov. 2006
    Livré le 01 déc. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the obligors to the security benificiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Its entire right, title and interest in and to the policy being, insurer:st andrew's life assurance PLC date of policy:25 april 2006 policy no:ASSH042685 life assured:richard poole sum assured:£500,000 term:5 years. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland in Its Capacity as a Security Trustee for Thesecured Beneficiaries, the Security Trustee
    Transactions
    • 01 déc. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 janv. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of assignment of keyman life policy
    Créé le 20 nov. 2006
    Livré le 01 déc. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the obligors to the security benificiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Its entire right, title and interest in and to the policy being, insurer:st andrew's life assurance PLC date of policy:25 april 2006 policy no:ASSH042689 life assured:bernard matthews sum assured:£500,000 term:5 years. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland in Its Capacity as a Security Trustee for Thesecured Beneficiaries, the Security Trustee
    Transactions
    • 01 déc. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 janv. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of assignment of keyman life policy
    Créé le 20 nov. 2006
    Livré le 01 déc. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the obligors to the security benificiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Its entire right, title and interest in and to the policy being, insurer:st andrew's life assurance PLC date of policy:25 april 2006 policy no:ASSH042686 life assured:kevin oakes sum assured:£1,000,000 term:5 years. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland in Its Capacity as a Security Trustee for Thesecured Beneficiaries, the Security Trustee
    Transactions
    • 01 déc. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 janv. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 06 janv. 2006
    Livré le 19 janv. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the obligors to security beneficiaries (or any of them) on any account whatsover under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland in Its Capacity as Security Trustee for Thesecurity Beneficiaries (The Security Trustee)
    Transactions
    • 19 janv. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 janv. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0