STEELITE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | STEELITE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 05643848 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe STEELITE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED ?
Adresse du siège social | Steelite International Limited Orme Street Burslem ST6 3RB Stoke-On-Trent England |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de STEELITE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2019 |
Quels sont les derniers dépôts pour STEELITE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2019 | 16 pages | AA | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||||||
État du capital au 22 déc. 2020
| 3 pages | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 2 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Satisfaction de la charge 056438480007 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||||||
Satisfaction de la charge 056438480008 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||||||
Inscription de la charge 056438480008, créée le 24 mars 2020 | 85 pages | MR01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Andrew Wiechkoske en tant que directeur le 20 déc. 2019 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Michael Rost en tant que directeur le 20 déc. 2019 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Nomination de Mr Brody Donahue Lynn en tant qu'administrateur le 20 déc. 2019 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 02 déc. 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2018 | 15 pages | AA | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 02 déc. 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2017 | 16 pages | AA | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Neil Hooper en tant que directeur le 26 mars 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||
Nomination de Mr Philip Ray en tant que secrétaire le 16 févr. 2018 | 2 pages | AP03 | ||||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de The Broadgate Tower Third Floor 20 Primrose Street London EC2A 2RS United Kingdom à Steelite International Limited Orme Street Burslem Stoke-on-Trent ST6 3RB le 14 févr. 2018 | 1 pages | AD01 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Reed Smith Corporate Services Limited en tant que secrétaire le 01 févr. 2018 | 1 pages | TM02 | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 02 déc. 2017 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2016 | 16 pages | AA | ||||||||||||||
legacy | 17 pages | RP04CS01 | ||||||||||||||
Qui sont les dirigeants de STEELITE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RAY, Philip | Secrétaire | Orme Street Burslem ST6 3RB Stoke-On-Trent Steelite International Limited England | 243600570001 | |||||||||||
CAMERON, Jonathan Ian Duncan | Administrateur | Burslem ST6 3RB Stoke-On-Trent Orme Street Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | Finance Director | 158270840001 | ||||||||
LYNN, Brody Donahue | Administrateur | Orme Street Burslem ST6 3RB Stoke-On-Trent Steelite International Limited England | United States | American | Director | 265559020001 | ||||||||
MILES, John David | Administrateur | Orme Street, Burslem Stoke-On-Trent ST6 3RB Staffordshire | United States | American | Company Director | 209524620001 | ||||||||
POOLE, Richard Edwin | Secrétaire | Orme Street, Burslem Stoke-On-Trent ST6 3RB Staffordshire | British | 13405890004 | ||||||||||
REED SMITH CORPORATE SERVICES LIMITED | Secrétaire | Third Floor 20 Primrose Street EC2A 2RS London The Broadgate Tower United Kingdom |
| 128914620002 | ||||||||||
ARKLEY, Alistair Grant | Administrateur | Orme Street, Burslem Stoke-On-Trent ST6 3RB Staffordshire | United Kingdom | British | Company Director | 16410280002 | ||||||||
HOOPER, Neil | Administrateur | Burslem ST6 3RB Stoke-On-Trent Orme Street Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | Managing Director | 209546690001 | ||||||||
MATTHEWS, Bernard | Administrateur | Orme Street, Burslem Stoke-On-Trent ST6 3RB Staffordshire | United Kingdom | English | Company Director | 13448230002 | ||||||||
MEANOCK, Timothy James Ian | Administrateur | 37-43 Sackville Street W1S 3DL London Pegasus House England | England | British | Investment Manager | 158599690001 | ||||||||
OAKES, Kevin Graham | Administrateur | Orme Street, Burslem Stoke-On-Trent ST6 3RB Staffordshire | United Kingdom | British | Director | 111230310001 | ||||||||
POOLE, Richard Edwin | Administrateur | Orme Street, Burslem Stoke-On-Trent ST6 3RB Staffordshire | United Kingdom | British | Company Director | 13405890004 | ||||||||
ROST, Michael | Administrateur | 620 Liberty Avenue 22nd Floor 15222 Pittsburgh C/O Pnc Riverarch Capital Pennsylvania United States | United States | American | Managing Director - Private Equity | 208446140001 | ||||||||
SEABROOK, Michael Richard | Administrateur | Broadacre Gardens 236 Grange Road Dorridge B93 8QB Solihull 5 West Midlands England | England | British | Solicitor | 1577930002 | ||||||||
WIECHKOSKE, Andrew | Administrateur | 620 Liberty Avenue 22nd Floor 15222 Pittsburgh C/O Pnc Riverarch Capital Pennsylvania United States | United States | American | Director - Private Equity | 208446150001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur STEELITE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St Athena Acquisition Company Limited | 14 juin 2016 | Third Floor 20 Primrose Street EC2A 2RS London The Broadgate Tower United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Mr Richard Edwin Poole | 08 juin 2016 | Orme Street Burslem ST6 3RB Stoke-On-Trent United Kingdom | Oui | ||||||||||
Nationalité: British Pays de résidence: United Kingdom | |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Mr Kevin Graham Oakes | 08 juin 2016 | Orme Street Burslem ST6 3RB Stoke-On-Trent United Kingdom | Oui | ||||||||||
Nationalité: British Pays de résidence: England | |||||||||||||
Nature du contrôle
|
Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour STEELITE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED ?
Notifié le | Cessé le | Déclaration |
---|---|---|
06 avr. 2016 | 08 juin 2016 | La société n'a pas encore achevé les mesures raisonnables pour déterminer si une personne est une personne enregistrable ou une entité juridique pertinente enregistrable en relation avec la société. |
STEELITE INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Créé le 24 mars 2020 Livré le 27 mars 2020 | Totalement satisfaite | ||
Brève description All present and future freehold or leasehold property, other than excluded property and all intellectual property pursuant to clause 3 of the accompanying copy instrument. La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A registered charge | Créé le 14 juin 2016 Livré le 24 juin 2016 | Totalement satisfaite | ||
Brève description Land:. Various freehold and leasehold property, including the freehold land at shirley street, adjacent to dalehall works, stoke-on-trent with the title number SF592830. For further details of all of the properties charged, please see schedule 2 of the charging document.. Intellectual property:. Various intellectual property, including the dunn bennett trademark with serial number 2374104 and registration number 2374104. for further details of all of the intellectual property charged, please see schedule 7 of the charging document. La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A registered charge | Créé le 23 déc. 2013 Livré le 07 janv. 2014 | Totalement satisfaite | ||
Brève description Land and buildings adjacent to newcastle street, burslem, stoke-on-trent t/no SF504131. Land and buildings on the east side of station street, longport, stoke-on-trent t/no SF504132. Notification of addition to or amendment of charge. La charge flottante couvre tout: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 21 oct. 2011 Livré le 10 nov. 2011 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the obligors to the security beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions For details of property charged please refer to form MG01. Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Deed of assignment of keyman life policy | Créé le 20 nov. 2006 Livré le 01 déc. 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the obligors to the security benificiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Its entire right, title and interest in and to the policy being, insurer:st andrew's life assurance PLC date of policy:25 april 2006 policy no:ASSH042685 life assured:richard poole sum assured:£500,000 term:5 years. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Deed of assignment of keyman life policy | Créé le 20 nov. 2006 Livré le 01 déc. 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the obligors to the security benificiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Its entire right, title and interest in and to the policy being, insurer:st andrew's life assurance PLC date of policy:25 april 2006 policy no:ASSH042689 life assured:bernard matthews sum assured:£500,000 term:5 years. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Deed of assignment of keyman life policy | Créé le 20 nov. 2006 Livré le 01 déc. 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the obligors to the security benificiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Its entire right, title and interest in and to the policy being, insurer:st andrew's life assurance PLC date of policy:25 april 2006 policy no:ASSH042686 life assured:kevin oakes sum assured:£1,000,000 term:5 years. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 06 janv. 2006 Livré le 19 janv. 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the obligors to security beneficiaries (or any of them) on any account whatsover under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0