AESICA FORMULATION DEVELOPMENT LIMITED

AESICA FORMULATION DEVELOPMENT LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéAESICA FORMULATION DEVELOPMENT LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 05661235
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de AESICA FORMULATION DEVELOPMENT LIMITED ?

    • fabrication de produits pharmaceutiques de base (21100) / Industries manufacturières
    • Recherche-développement en biotechnologie (72110) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe AESICA FORMULATION DEVELOPMENT LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Aesica Formulation Development Limited Windmill Industrial Estate
    Shotton Lane
    NE23 3JL Cramlington
    Northumberland
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de AESICA FORMULATION DEVELOPMENT LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    R5 PHARMACEUTICALS LIMITED14 août 200614 août 2006
    R5 LIMITED22 déc. 200522 déc. 2005

    Quels sont les derniers comptes de AESICA FORMULATION DEVELOPMENT LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 janv. 2020

    Quels sont les derniers dépôts pour AESICA FORMULATION DEVELOPMENT LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 22 déc. 2020 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    legacy

    1 pagesSH20

    État du capital au 14 oct. 2020

    • Capital: GBP 1
    5 pagesSH19

    legacy

    1 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    9 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06
    capital

    Résolutions

    Cancel share prem a/c 11/10/2020
    RES13

    Comptes annuels établis au 31 janv. 2020

    22 pagesAA

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de C/O Consort Medical Plc Breakspear Park Breakspear Way Hemel Hempstead Hertfordshire HP2 4TZ England à Aesica Formulation Development Limited Windmill Industrial Estate Shotton Lane Cramlington Northumberland NE23 3JL

    1 pagesAD02

    Changement d'adresse du siège social de Suite B Breakspear Park Breakspear Way Hemel Hempstead Hertfordshire HP2 4TZ England à Aesica Formulation Development Limited Windmill Industrial Estate Shotton Lane Cramlington Northumberland NE23 3JL le 24 juil. 2020

    1 pagesAD01

    Modification des détails de Aesica Queenborough Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 23 avr. 2020

    2 pagesPSC05

    Nomination de Mr Mark Royston Quick en tant qu'administrateur le 15 juin 2020

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Andrew Leonard Jackson en tant que secrétaire le 30 avr. 2020

    1 pagesTM02

    Période comptable précédente raccourcie du 30 avr. 2020 au 31 janv. 2020

    1 pagesAA01

    Cessation de la nomination de Paul Andrew Hayes en tant que directeur le 04 févr. 2020

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Jonathan Martin Glenn en tant que directeur le 04 févr. 2020

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Thomas Eldered en tant qu'administrateur le 04 févr. 2020

    2 pagesAP01

    Déclaration de confirmation établie le 22 déc. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Manja Hermina Elisabeth Maria Boerman en tant que directeur le 30 nov. 2019

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 30 avr. 2019

    18 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 22 déc. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Mr Andrew Leonard Jackson en tant que secrétaire le 07 sept. 2018

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Paul Andrew Hayes en tant que secrétaire le 07 sept. 2018

    1 pagesTM02

    Comptes annuels établis au 30 avr. 2018

    17 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de AESICA FORMULATION DEVELOPMENT LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ELDERED, Thomas Bengt
    Box 603
    101 32 Stockholm
    Recipharm Ab (Publ)
    Sweden
    Administrateur
    Box 603
    101 32 Stockholm
    Recipharm Ab (Publ)
    Sweden
    SwedenSwedish266996040001
    QUICK, Mark Royston
    Windmill Industrial Estate
    Shotton Lane
    NE23 3JL Cramlington
    Aesica Formulation Development Limited
    Northumberland
    England
    Administrateur
    Windmill Industrial Estate
    Shotton Lane
    NE23 3JL Cramlington
    Aesica Formulation Development Limited
    Northumberland
    England
    EnglandBritish124779290002
    CROCKER, Glenn, Dr
    Biocity Nottingham
    Pennyfoot Street
    NG1 1GF Nottingham
    Nottinghamshire
    Secrétaire
    Biocity Nottingham
    Pennyfoot Street
    NG1 1GF Nottingham
    Nottinghamshire
    British90368460001
    HAYES, Paul Andrew
    Breakspear Way
    HP2 4TZ Hemel Hempstead
    Suite B Breakspear Park
    Hertfordshire
    England
    Secrétaire
    Breakspear Way
    HP2 4TZ Hemel Hempstead
    Suite B Breakspear Park
    Hertfordshire
    England
    243809280001
    ILETT, John Edward
    Breakspear Way
    HP2 4TZ Hemel Hempstead
    Suite B Breakspear Park
    Hertfordshire
    England
    Secrétaire
    Breakspear Way
    HP2 4TZ Hemel Hempstead
    Suite B Breakspear Park
    Hertfordshire
    England
    202401700001
    JACKSON, Andrew Leonard
    Breakspear Way
    HP2 4TZ Hemel Hempstead
    Suite B Breakspear Park
    Hertfordshire
    England
    Secrétaire
    Breakspear Way
    HP2 4TZ Hemel Hempstead
    Suite B Breakspear Park
    Hertfordshire
    England
    250537540001
    NICHOLSON, Paul
    Quorum Business Park, Benton Lane
    NE12 8EZ Newcastle Upon Tyne
    Quorum 5
    Tyne & Wear
    England
    Secrétaire
    Quorum Business Park, Benton Lane
    NE12 8EZ Newcastle Upon Tyne
    Quorum 5
    Tyne & Wear
    England
    153169140001
    TUXFORD, Roy
    c/o Aesica Pharmaceuticals Limited
    Quorum Business Park, Benton Lane
    NE12 8BS Newcastle Upon Tyne
    Q5
    United Kingdom
    Secrétaire
    c/o Aesica Pharmaceuticals Limited
    Quorum Business Park, Benton Lane
    NE12 8BS Newcastle Upon Tyne
    Q5
    United Kingdom
    165813370001
    WARD, Iain Stuart
    c/o Aesica Pharmaceuticals Limited
    Quorum Business Park, Benton Lane
    NE12 8BS Newcastle Upon Tyne
    Q5
    Secrétaire
    c/o Aesica Pharmaceuticals Limited
    Quorum Business Park, Benton Lane
    NE12 8BS Newcastle Upon Tyne
    Q5
    192881670001
    BOERMAN, Manja Hermina Elisabeth Maria, Dr
    Breakspear Way
    HP2 4TZ Hemel Hempstead
    Suite B Breakspear Park
    Hertfordshire
    England
    Administrateur
    Breakspear Way
    HP2 4TZ Hemel Hempstead
    Suite B Breakspear Park
    Hertfordshire
    England
    NetherlandsDutch232164260001
    COTTON, Richard John
    Breakspear Way
    HP2 4TZ Hemel Hempstead
    Breakspear Park
    Hertfordshire
    England
    Administrateur
    Breakspear Way
    HP2 4TZ Hemel Hempstead
    Breakspear Park
    Hertfordshire
    England
    EnglandBritish170307480002
    CROCKER, Glenn, Dr
    Biocity Nottingham
    Pennyfoot Street
    NG1 1GF Nottingham
    Nottinghamshire
    Administrateur
    Biocity Nottingham
    Pennyfoot Street
    NG1 1GF Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritish90368460001
    FAZACKERLEY, Richard Newman
    c/o Aesica Pharmaceuticals Limited
    Quorum Business Park, Benton Lane
    NE12 8BS Newcastle Upon Tyne
    Q5
    Administrateur
    c/o Aesica Pharmaceuticals Limited
    Quorum Business Park, Benton Lane
    NE12 8BS Newcastle Upon Tyne
    Q5
    EnglandBritish192867410001
    GLENN, Jonathan Martin
    Breakspear Way
    HP2 4TZ Hemel Hempstead
    Suite B Breakspear Park
    Hertfordshire
    England
    Administrateur
    Breakspear Way
    HP2 4TZ Hemel Hempstead
    Suite B Breakspear Park
    Hertfordshire
    England
    United KingdomBritish148251560003
    HARDY, Robert, Dr
    Quorum Business Park, Benton Lane
    NE12 8EZ Newcastle Upon Tyne
    Quorum 5
    Tyne & Wear
    England
    Administrateur
    Quorum Business Park, Benton Lane
    NE12 8EZ Newcastle Upon Tyne
    Quorum 5
    Tyne & Wear
    England
    United KingdomBritish97702700002
    HAYES, Paul Andrew
    Breakspear Way
    HP2 4TZ Hemel Hempstead
    Suite B Breakspear Park
    Hertfordshire
    England
    Administrateur
    Breakspear Way
    HP2 4TZ Hemel Hempstead
    Suite B Breakspear Park
    Hertfordshire
    England
    EnglandBritish160870900001
    HUNNEYBALL, Ian Michael, Professor
    c/o Evotec
    Milton Park
    Milton
    OX14 4SA Abingdon
    114
    Oxfordshire
    United Kingdom
    Administrateur
    c/o Evotec
    Milton Park
    Milton
    OX14 4SA Abingdon
    114
    Oxfordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish86789270001
    JONES, Nicholas Vaughan
    Q5, Quorum Business Park
    Benton Lane
    NE12 8BS Newcastle Upon Tyne
    Aesica Pharmaceuticals,
    Tyne & Wear
    United Kingdom
    Administrateur
    Q5, Quorum Business Park
    Benton Lane
    NE12 8BS Newcastle Upon Tyne
    Aesica Pharmaceuticals,
    Tyne & Wear
    United Kingdom
    United KingdomBritish163997380001
    JONES, Nicholas Vaughan
    Biocity Nottingham
    Pennyfoot Lane
    NG1 1GF Nottingham
    Administrateur
    Biocity Nottingham
    Pennyfoot Lane
    NG1 1GF Nottingham
    United KingdomBritish163997380001
    JORDAN, David, Dr
    3 Leary Crescent
    Chicheley Park
    MK16 9GA Newport Pagnell
    Buckinghamshire
    Administrateur
    3 Leary Crescent
    Chicheley Park
    MK16 9GA Newport Pagnell
    Buckinghamshire
    EnglandBritish97712010001
    LAFFERTY, Ian William, Dr
    Quorum Business Park
    Benton Lane
    NE12 8EZ Newcastle Upon Tyne
    Quorum 5
    Tyne & Wear
    Administrateur
    Quorum Business Park
    Benton Lane
    NE12 8EZ Newcastle Upon Tyne
    Quorum 5
    Tyne & Wear
    United KingdomIrish101027170002
    MCCONNELL, John Martin
    Quorum Business Park, Benton Lane
    NE12 8EZ Newcastle Upon Tyne
    Quorum 5
    Tyne & Wear
    Administrateur
    Quorum Business Park, Benton Lane
    NE12 8EZ Newcastle Upon Tyne
    Quorum 5
    Tyne & Wear
    EnglandBritish153171460001
    MUIR, Ian Stuart
    Breakspear Way
    HP2 4TZ Hemel Hempstead
    Breakspear Park
    Hertfordshire
    England
    Administrateur
    Breakspear Way
    HP2 4TZ Hemel Hempstead
    Breakspear Park
    Hertfordshire
    England
    United KingdomBritish192862540001
    NICHOLSON, Paul
    Quorum Business Park
    Benton Lane
    NE12 8EZ Newcastle Upon Tyne
    Quorum 5
    Tyne & Wear
    Administrateur
    Quorum Business Park
    Benton Lane
    NE12 8EZ Newcastle Upon Tyne
    Quorum 5
    Tyne & Wear
    United KingdomBritish248337880001
    TITLEY, Paul Charlton
    West View
    The Heads
    CA12 5ES Keswick
    Cumbria
    Administrateur
    West View
    The Heads
    CA12 5ES Keswick
    Cumbria
    United KingdomBritish107189380001
    WARD, Iain Stuart
    c/o Aesica Pharmaceuticals Limited
    Quorum Business Park, Benton Lane
    NE12 8BS Newcastle Upon Tyne
    Q5
    Administrateur
    c/o Aesica Pharmaceuticals Limited
    Quorum Business Park, Benton Lane
    NE12 8BS Newcastle Upon Tyne
    Q5
    EnglandBritish192908500001
    WATERHOUSE, Janette, Dr
    16 Highfield Close
    SK3 8UB Stockport
    Cheshire
    Administrateur
    16 Highfield Close
    SK3 8UB Stockport
    Cheshire
    EnglandBritish117811100001
    WILDING, Ian, Dr
    10 Glebe Street
    NG11 6JS Beeston
    Nottinghamshire
    Administrateur
    10 Glebe Street
    NG11 6JS Beeston
    Nottinghamshire
    United KingdomBritish111933510001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur AESICA FORMULATION DEVELOPMENT LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    North Road
    ME11 5EL Queenborough
    Aesica Queenborough Limited
    Kent
    England
    06 avr. 2016
    North Road
    ME11 5EL Queenborough
    Aesica Queenborough Limited
    Kent
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementEngland & Wales
    Autorité légaleCompanies Act
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement6350087
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    AESICA FORMULATION DEVELOPMENT LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 21 mars 2014
    Livré le 25 mars 2014
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Tm numbers 2505093 and 2548332. notification of addition to or amendment of charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Ing Bank N.V., London Branch
    Transactions
    • 25 mars 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 03 déc. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Créé le 11 oct. 2011
    Livré le 13 oct. 2011
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currency unit, and the debt or debts from time to time.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 13 oct. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    Deed of accession to debenture
    Créé le 11 oct. 2011
    Livré le 13 oct. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee and/or the beneficiaries or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC (As the Security Agent)
    Transactions
    • 13 oct. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 01 avr. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of admission
    Créé le 28 juin 2010
    Livré le 09 juil. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company or any one or more of the other parties to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Any sums or sums standing to the credit of any one or more of any present of future accounts of the companies with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 09 juil. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 26 oct. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Deed of accession
    Créé le 28 juin 2010
    Livré le 09 juil. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each chargor to the chargee and/or the beneficiaries or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC (The "Security Trustee")
    Transactions
    • 09 juil. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 26 oct. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 23 févr. 2009
    Livré le 27 févr. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank PLC
    Transactions
    • 27 févr. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 juil. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Assignment of keyman life policy
    Créé le 23 juil. 2007
    Livré le 07 août 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Company canada life policy number 6024081 date 08/06/2007 sum £200000 life assured paul c titley together with the whole sums assured thereby and all bonuses and benefits which may arise thereunder.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 07 août 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 26 juin 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 28 mars 2007
    Livré le 31 mars 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including bookdebts buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 31 mars 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 avr. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 15 déc. 2006
    Livré le 03 janv. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Any f/h or l/h property fixed plant and machinery uncalled capital. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • East Midlands Regional Venture Capital Fund No 1 Limited Partnership
    Transactions
    • 03 janv. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 juil. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 15 déc. 2006
    Livré le 03 janv. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Any f/h or l/h property fixed plant and machinery uncalled capital. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Dr Ian Wilding
    Transactions
    • 03 janv. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 juil. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0