NORPRINT LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéNORPRINT LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 05665731
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de NORPRINT LIMITED ?

    • autres activités d'impression n.c.a. (18129) / Industries manufacturières

    Où se situe NORPRINT LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Mazars House Gelderd Road
    Gildersome
    LS27 7JN Leeds
    Yorkshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de NORPRINT LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    WILLOUGHBY (534) LIMITED04 janv. 200604 janv. 2006

    Quels sont les derniers comptes de NORPRINT LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2014

    Quels sont les derniers dépôts pour NORPRINT LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    20 pagesLIQ14

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 21 juil. 2020

    21 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 21 juil. 2019

    30 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 21 juil. 2018

    27 pagesLIQ03

    Révocation du liquidateur par ordonnance du tribunal

    18 pagesLIQ10

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Avis de transition de l'administration à la liquidation volontaire des créanciers

    27 pagesAM22

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    26 pagesAM10

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 21 déc. 2016

    33 pages2.24B

    Avis de nomination d'un administrateur de remplacement/supplémentaire

    1 pages2.40B

    Avis de vacance de poste par l'administrateur

    29 pages2.39B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 21 juin 2016

    21 pages2.24B

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    1 pages2.31B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 29 janv. 2016

    22 pages2.24B

    Déclaration des affaires avec le formulaire 2.14B/2.15B

    15 pages2.16B

    Avis d'approbation réputée des propositions

    1 pagesF2.18

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    32 pages2.17B

    Changement d'adresse du siège social de Horncastle Road Boston Lincolnshire PE21 9HZ à Mazars House Gelderd Road Gildersome Leeds Yorkshire LS27 7JN le 17 août 2015

    2 pagesAD01

    Nomination d'un administrateur

    1 pages2.12B

    Comptes annuels établis au 30 juin 2014

    18 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 04 janv. 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital05 janv. 2015

    État du capital au 05 janv. 2015

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Comptes annuels établis au 30 juin 2013

    18 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 04 janv. 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital10 janv. 2014

    État du capital au 10 janv. 2014

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Qui sont les dirigeants de NORPRINT LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    CHAMPION, David Neil
    Gelderd Road
    Gildersome
    LS27 7JN Leeds
    Mazars House
    Yorkshire
    Secrétaire
    Gelderd Road
    Gildersome
    LS27 7JN Leeds
    Mazars House
    Yorkshire
    BritishAccountant130150960001
    CHAMPION, David Neil
    Gelderd Road
    Gildersome
    LS27 7JN Leeds
    Mazars House
    Yorkshire
    Administrateur
    Gelderd Road
    Gildersome
    LS27 7JN Leeds
    Mazars House
    Yorkshire
    United KingdomBritishFinance Director152573210001
    COLCLOUGH, Roy Harry
    Gelderd Road
    Gildersome
    LS27 7JN Leeds
    Mazars House
    Yorkshire
    Administrateur
    Gelderd Road
    Gildersome
    LS27 7JN Leeds
    Mazars House
    Yorkshire
    EnglandBritishDirector56053020001
    JOHNSON, Paul Rowland
    Gelderd Road
    Gildersome
    LS27 7JN Leeds
    Mazars House
    Yorkshire
    Administrateur
    Gelderd Road
    Gildersome
    LS27 7JN Leeds
    Mazars House
    Yorkshire
    United KingdomBritishTechnical Sales Director71509040002
    LAIDLAW, Alan
    Gelderd Road
    Gildersome
    LS27 7JN Leeds
    Mazars House
    Yorkshire
    Administrateur
    Gelderd Road
    Gildersome
    LS27 7JN Leeds
    Mazars House
    Yorkshire
    United KingdomBritishDirector65449270007
    WISE, John Robert
    Gelderd Road
    Gildersome
    LS27 7JN Leeds
    Mazars House
    Yorkshire
    Administrateur
    Gelderd Road
    Gildersome
    LS27 7JN Leeds
    Mazars House
    Yorkshire
    United KingdomBritishDivisional Director149016400001
    FRAY, Timothy John
    49 Stamford Drive
    Groby
    LE6 0YD Leicester
    Leicestershire
    Secrétaire
    49 Stamford Drive
    Groby
    LE6 0YD Leicester
    Leicestershire
    BritishChartered Accountant121161680001
    WILLOUGHBY CORPORATE SECRETARIAL LIMITED
    Cumberland Court
    80 Mount Street
    NG1 6HH Nottingham
    Secrétaire
    Cumberland Court
    80 Mount Street
    NG1 6HH Nottingham
    68522760005
    DOVE, Nicholas Charles
    Horncastle Road
    Boston
    PE21 9HZ Lincolnshire
    Administrateur
    Horncastle Road
    Boston
    PE21 9HZ Lincolnshire
    United KingdomBritishGroup Finance Director107550720001
    FAWDINGTON, Eric Alexander
    Horncastle Road
    Boston
    PE21 9HZ Lincolnshire
    Administrateur
    Horncastle Road
    Boston
    PE21 9HZ Lincolnshire
    EnglandBritishNon-Executive Director59580130001
    FRAY, Timothy John
    49 Stamford Drive
    Groby
    LE6 0YD Leicester
    Leicestershire
    Administrateur
    49 Stamford Drive
    Groby
    LE6 0YD Leicester
    Leicestershire
    BritishDirector121161680001
    FRENCH, Nicholas Gordon
    6 Glebe Close
    Sibsey
    PE22 0RW Boston
    Lincolnshire
    Administrateur
    6 Glebe Close
    Sibsey
    PE22 0RW Boston
    Lincolnshire
    United KingdomBritishAccountant71509080001
    SEN, Jaidip
    Brinkhall Way
    Welton
    LN2 3NS Lincoln
    25
    Lincolnshire
    Administrateur
    Brinkhall Way
    Welton
    LN2 3NS Lincoln
    25
    Lincolnshire
    EnglandBritishAccountant136029390001
    SHOOTER, Michael William
    Horncastle Road
    Boston
    PE21 9HZ Lincolnshire
    Administrateur
    Horncastle Road
    Boston
    PE21 9HZ Lincolnshire
    United KingdomBritishProduction Director66802990002
    WILLOUGHBY CORPORATE REGISTRARS LIMITED
    80 Mount Street
    NG1 6HH Nottingham
    Administrateur
    80 Mount Street
    NG1 6HH Nottingham
    95689040001

    NORPRINT LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 05 déc. 2013
    Livré le 17 déc. 2013
    En cours
    Brève description
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lombard North Central PLC
    Transactions
    • 17 déc. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    Chattel mortgage
    Créé le 22 août 2012
    Livré le 29 août 2012
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each of the obligors to the security holder on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Nortag dynamic rf/rfid security tag laminator serial no M677 (rebuilt 2005), mark andy 4150-16B 16" 4 colour flexopress converter serial no 1005580 (1998) and mark andy norprint po washer tag converter serial no 061102 (for full list of mortgaged chattels please see form MG01) fixed charge all plant and machinery and the benefit of all rights and claims in respect of the design construction repair or replacement of the same see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Ge Commercial Finance Limited
    Transactions
    • 29 août 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    Composite all assets guarantee and indemnity
    Créé le 22 août 2012
    Livré le 29 août 2012
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and the obligors to the security holder on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Ge Capital Bank Limited
    Transactions
    • 29 août 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    Composite all assets guarantee and indemnity
    Créé le 22 août 2012
    Livré le 29 août 2012
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and the obligors to the security holder on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Ge Commercial Finance Limited
    Transactions
    • 29 août 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    Composite all assets guarantee and indemnity and debenture
    Créé le 28 avr. 2011
    Livré le 04 mai 2011
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and the obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Ge Commercial Finance Limited
    Transactions
    • 04 mai 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    Chattel mortgage
    Créé le 30 juin 2010
    Livré le 03 juil. 2010
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each of the obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed charge on all plant and machinery being- arsoma EM410 8 colour flexopress printing line s/no 410-293. arsoma EM410 13 station modular litho/flexopress printing line s/no 410-218. additional interchangeable modules including 3 x 24" litho printing heads (for further details of chattels charged please refer to form MG01) see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Ge Commercial Finance Limited
    Transactions
    • 03 juil. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    Chattel mortgage
    Créé le 16 avr. 2010
    Livré le 23 avr. 2010
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each of the obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fised charges all its plant and machinery,the benefit of all the company's rights and claims,the benefits arising under the policies see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Ge Commercial Finance Limited
    Transactions
    • 23 avr. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    Composite all assets guarantee and indemnity and debenture
    Créé le 16 avr. 2010
    Livré le 23 avr. 2010
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and the obligors to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • G E Commercial Finance Limited
    Transactions
    • 23 avr. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    Rent deposit deed
    Créé le 31 janv. 2008
    Livré le 06 févr. 2008
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    £150,000.00 in a seprate interest-earning deposit account.
    Personnes ayant droit
    • Norcros Estates Limited
    Transactions
    • 06 févr. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 27 avr. 2006
    Livré le 04 mai 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • National Westminster Bank PLC
    Transactions
    • 04 mai 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Guarantee & debenture
    Créé le 30 janv. 2006
    Livré le 15 févr. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company formerly known as willoughby (534) limited and magnadata group limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Close Securities Limited
    Transactions
    • 15 févr. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 juin 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Composite all assets guarantee and debenture
    Créé le 30 janv. 2006
    Livré le 14 févr. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company formerly known as willoughby (534) limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Ge Commercial Finance Limited
    Transactions
    • 14 févr. 2006Enregistrement d'une charge (395)

    NORPRINT LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    30 juil. 2015Administration started
    22 juil. 2017Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Robert David Adamson
    Mazars House Gelderd Road
    Gildersome
    LS27 7JN Leeds
    West Yorkshire
    practitioner
    Mazars House Gelderd Road
    Gildersome
    LS27 7JN Leeds
    West Yorkshire
    Roderick John Weston
    Mazars Llp Tower Bridge House
    St Katharines Way
    E1W 1DD London
    practitioner
    Mazars Llp Tower Bridge House
    St Katharines Way
    E1W 1DD London
    Patrick Alexander Lannagan
    The Lexicon 10-12 Mount Street
    M2 5NT Manchester
    practitioner
    The Lexicon 10-12 Mount Street
    M2 5NT Manchester
    2
    DateType
    22 juil. 2017Commencement of winding up
    23 juin 2021Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Robert David Adamson
    Mazars House Gelderd Road
    Gildersome
    LS27 7JN Leeds
    West Yorkshire
    practitioner
    Mazars House Gelderd Road
    Gildersome
    LS27 7JN Leeds
    West Yorkshire
    Patrick Alexander Lannagan
    Mazars Llp One St Peters Square
    M2 3DE Manchester
    practitioner
    Mazars Llp One St Peters Square
    M2 3DE Manchester
    Conrad Alexander Pearson
    Mazars Llp One St Peters Square
    M2 3DE Manchester
    practitioner
    Mazars Llp One St Peters Square
    M2 3DE Manchester

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0