CATALYST HOUSING CHARITABLE TRUST
Vue d'ensemble
Nom de la société | CATALYST HOUSING CHARITABLE TRUST |
---|---|
Statut de la société | Active |
Forme juridique | Société privée à responsabilité limitée par garantie sans capital social, exemption d'utilisation de 'Limited' |
Numéro de société | 05677196 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Non |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe CATALYST HOUSING CHARITABLE TRUST ?
Adresse du siège social | Ealing Gateway 26-30 Uxbridge Road W5 2AU Ealing London |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de CATALYST HOUSING CHARITABLE TRUST ?
En retard | Non |
---|---|
Prochains comptes | |
Fin de la prochaine période comptable le | 31 mars 2025 |
Date d'échéance des prochains comptes | 31 déc. 2025 |
Derniers comptes | |
Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2024 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour CATALYST HOUSING CHARITABLE TRUST ?
Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 17 janv. 2026 |
---|---|
Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 31 janv. 2026 |
Dernière déclaration de confirmation | |
Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 17 janv. 2025 |
En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour CATALYST HOUSING CHARITABLE TRUST ?
Date | Description | Document | Type | |
---|---|---|---|---|
Déclaration de confirmation établie le 17 janv. 2025 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2024 | 22 pages | AA | ||
Cessation de la nomination de Annemarie Fenlon en tant que directeur le 26 juin 2024 | 1 pages | TM01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 17 janv. 2024 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Cessation de la nomination de Delphine Merlot en tant que directeur le 21 déc. 2023 | 1 pages | TM01 | ||
Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2023 | 22 pages | AA | ||
Nomination de Rachel Solomon en tant qu'administrateur le 11 déc. 2023 | 2 pages | AP01 | ||
Nomination de Andrea Purslow en tant qu'administrateur le 11 déc. 2023 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Brenda Giles en tant que secrétaire le 01 déc. 2023 | 1 pages | TM02 | ||
Nomination de Sarah Cameron en tant que secrétaire le 01 déc. 2023 | 2 pages | AP03 | ||
Cessation de la nomination de Nicola Wheeler en tant que directeur le 21 sept. 2023 | 1 pages | TM01 | ||
Notification d'une déclaration relative à une personne disposant d'un contrôle significatif | 2 pages | PSC08 | ||
Cessation de Catalyst Housing Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 03 avr. 2023 | 1 pages | PSC07 | ||
Nomination de Nicola Wheeler en tant qu'administrateur le 01 avr. 2023 | 2 pages | AP01 | ||
Cessation de la nomination de Karina Skinner en tant que directeur le 31 mars 2023 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Marie Vernal en tant que directeur le 31 mars 2023 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Dipa Joshi en tant que directeur le 31 mars 2023 | 1 pages | TM01 | ||
Cessation de la nomination de Catherine Williams en tant que directeur le 31 mars 2023 | 1 pages | TM01 | ||
Nomination de Caroline Turberfield en tant qu'administrateur le 01 avr. 2023 | 2 pages | AP01 | ||
Nomination de Annemarie Fenlon en tant qu'administrateur le 01 avr. 2023 | 2 pages | AP01 | ||
Nomination de Mr Stephen Eric Burns en tant qu'administrateur le 01 avr. 2023 | 2 pages | AP01 | ||
Déclaration de confirmation établie le 17 janv. 2023 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||
Comptes pour une petite entreprise établis au 31 mars 2022 | 25 pages | AA | ||
Nomination de Brenda Giles en tant que secrétaire le 01 juin 2022 | 2 pages | AP03 | ||
Cessation de la nomination de Emma Suzanne Maguire en tant que secrétaire le 31 mai 2022 | 1 pages | TM02 | ||
Qui sont les dirigeants de CATALYST HOUSING CHARITABLE TRUST ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAMERON, Sarah | Secrétaire | Ealing Gateway 26-30 Uxbridge Road W5 2AU Ealing London | 316778680001 | |||||||
BURNS, Stephen Eric | Administrateur | Ealing Gateway 26-30 Uxbridge Road W5 2AU Ealing London | England | British | Director | 186495490001 | ||||
KHAN, Sahil | Administrateur | Ealing Gateway 26-30 Uxbridge Road W5 2AU Ealing London | United Kingdom | British | Director | 244521220001 | ||||
PURSLOW, Andrea | Administrateur | Ealing Gateway 26-30 Uxbridge Road W5 2AU Ealing London | England | British | Company Director | 316960000001 | ||||
SOLOMON, Rachel | Administrateur | Ealing Gateway 26-30 Uxbridge Road W5 2AU Ealing London | England | British | Director | 316960130001 | ||||
TURBERFIELD, Caroline | Administrateur | Ealing Gateway 26-30 Uxbridge Road W5 2AU Ealing London | England | British | Director | 261022690001 | ||||
ATKINSON, Sophie | Secrétaire | Ealing Gateway 26-30 Uxbridge Road W5 2AU Ealing London | 242047130001 | |||||||
GILES, Brenda | Secrétaire | Ealing Gateway 26-30 Uxbridge Road W5 2AU Ealing London | 296967310001 | |||||||
HARDYSMITH, Catherine | Secrétaire | Ealing Gateway 26-30 Uxbridge Road W5 2AU Ealing London | 238887900001 | |||||||
KING, Margaret | Secrétaire | Ealing Gateway 26-30 Uxbridge Road W5 2AU Ealing London | British | 105408510006 | ||||||
MAGUIRE, Emma Suzanne | Secrétaire | Ealing Gateway 26-30 Uxbridge Road W5 2AU Ealing London | 284854250001 | |||||||
MCBRIDE, Susan | Secrétaire | 26-30 Uxbridge Road W5 2AU Ealing Ealing Gateway London United Kingdom | 210314050001 | |||||||
ADAMS, Maureen | Administrateur | Cock Lane HP13 7DZ High Wycombe 85 United Kingdom | Irish | Civil Servant | 138306910002 | |||||
BLACK, Scott | Administrateur | Ealing Gateway 26-30 Uxbridge Road W5 2AU Ealing London | United Kingdom | British | Director | 251550760001 | ||||
BLACKMORE, Henrietta, Dr | Administrateur | James House Appleford Road W10 5GF London 20 England England | United Kingdom | British | Programme Manager | 191707010001 | ||||
BLAKEBURN, Alison | Administrateur | Ealing Gateway 26-30 Uxbridge Road W5 2AU Ealing London | United Kingdom | British | Local Government Officer | 255231550001 | ||||
BROWN, Richard Howard | Administrateur | Ealing Gateway 26-30 Uxbridge Road W5 2AU Ealing London | United Kingdom | British | Non-Executive Director | 84071750001 | ||||
CAHILL, Roderick Nicholas | Administrateur | Ealing Gateway 26-30 Uxbridge Road W5 2AU Ealing London | England | Irish | Chief Executive | 35832470007 | ||||
CHAMBERS, Joseph Paul | Administrateur | Ealing Gateway 26-30 Uxbridge Road W5 2AU Ealing London | England | British | Consultant | 251554900001 | ||||
CHAPMAN, Rosie | Administrateur | Alexandra Gardens N10 3RN London 21 England England | England | British | Independent Charity Advisor | 112227870002 | ||||
DUCKWORTH, Stephen Roger | Administrateur | Ealing Gateway 26-30 Uxbridge Road W5 2AU Ealing London | England | British | Housing Finance Consultant | 74042960001 | ||||
FENLON, Annemarie Elizabeth | Administrateur | Ealing Gateway 26-30 Uxbridge Road W5 2AU Ealing London | England | British | Director | 269053950001 | ||||
FOXALL, John | Administrateur | 12 Park Side Cricklewood NW2 6RH London | British | Managing Director | 89459060001 | |||||
GRAVES, Charlotte Louise | Administrateur | 30 Wordsworth Walk NW11 6AU London | England | British | Managing Director | 209162710001 | ||||
HICKS, David Vincent | Administrateur | Ealing Gateway 26-30 Uxbridge Road W5 2AU Ealing London | British | Customer Services Agent | 90039970001 | |||||
JOSHI, Dipa | Administrateur | Ealing Gateway 26-30 Uxbridge Road W5 2AU Ealing London | England | British | Architect | 236737650001 | ||||
KERR, Natasha | Administrateur | 5 Dolphin Road UB5 6UQ Northolt | United Kingdom | British | Mac Co-Ordinator | 119642170001 | ||||
MERLOT, Delphine | Administrateur | Ealing Gateway 26-30 Uxbridge Road W5 2AU Ealing London | United Kingdom | French | Director | 269017040001 | ||||
QAIYOOM, Rubina | Administrateur | 3 Warren Drive UB6 9ER Greenford Middlesex | British | Solicitor | 100401520001 | |||||
RILEY, David Mark | Administrateur | Ealing Gateway 26-30 Uxbridge Road W5 2AU Ealing London | United Kingdom | British | Director | 167941410001 | ||||
SHARMA, Arvind | Administrateur | 44 Castleview Road SL3 7NQ Slough Berkshire | England | British | Director | 66734780001 | ||||
SKINNER, Karina | Administrateur | Ealing Gateway 26-30 Uxbridge Road W5 2AU Ealing London | England | British | Nursery Teacher | 255247350001 | ||||
TITHERINGTON, Tom | Administrateur | Ealing Gateway 26-30 Uxbridge Road W5 2AU Ealing London | United Kingdom | British | Director Of Bd&M | 163968140001 | ||||
TOOGOOD, Martin | Administrateur | Cold Aston Cheltenham GL54 3BJ Gloucestershire Sycamore House England England | United Kingdom | English | Company Director | 64062440004 | ||||
UGWU, Chinyere | Administrateur | Ealing Gateway 26-30 Uxbridge Road W5 2AU Ealing London | England | British | Project Director | 77531020001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur CATALYST HOUSING CHARITABLE TRUST ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Catalyst Housing Limited | 30 juin 2016 | 26-30 Uxbridge Road Ealing W5 2AU London Ealing Gateway England | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour CATALYST HOUSING CHARITABLE TRUST ?
Notifié le | Cessé le | Déclaration |
---|---|---|
03 avr. 2023 | La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société. |
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0