GYLE SHOPPING CENTRE GENERAL PARTNER LIMITED

GYLE SHOPPING CENTRE GENERAL PARTNER LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéGYLE SHOPPING CENTRE GENERAL PARTNER LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 05716360
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de GYLE SHOPPING CENTRE GENERAL PARTNER LIMITED ?

    • Administration de biens immobiliers pour compte de tiers (68320) / Activités immobilières

    Où se situe GYLE SHOPPING CENTRE GENERAL PARTNER LIMITED ?

    Adresse du siège social
    35 Great St Helen's
    EC3A 6AP London
    England
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de GYLE SHOPPING CENTRE GENERAL PARTNER LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    LAWGRA (NO. 1225) LIMITED21 févr. 200621 févr. 2006

    Quels sont les derniers comptes de GYLE SHOPPING CENTRE GENERAL PARTNER LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour GYLE SHOPPING CENTRE GENERAL PARTNER LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 18 avr. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Annick Agnes Bredero en tant qu'administrateur le 04 avr. 2018

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Maurice Alexander Kalsbeek en tant que directeur le 04 avr. 2018

    1 pagesTM01

    Nomination de Miss Amy Nicole Lejune en tant qu'administrateur le 11 déc. 2017

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Daniel Christopher Vijselaar en tant que directeur le 11 déc. 2017

    1 pagesTM01

    Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016

    2 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 18 avr. 2017 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Déclaration de confirmation établie le 16 mars 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Déclaration de confirmation établie le 21 févr. 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Résolutions

    Resolutions
    6 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Période comptable précédente prolongée du 30 juin 2016 au 31 déc. 2016

    1 pagesAA01

    Inscription de la charge 057163600005, créée le 01 mars 2017

    22 pagesMR01

    Inscription de la charge 057163600004, créée le 23 févr. 2017

    52 pagesMR01

    Inscription de la charge 057163600003, créée le 23 févr. 2017

    28 pagesMR01

    Nomination de Mr Gerardus Johannes Schipper en tant qu'administrateur le 23 févr. 2017

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Raoul Rene Hofland en tant qu'administrateur le 23 févr. 2017

    2 pagesAP01

    Nomination de Intertrust (Uk) Limited en tant que secrétaire le 23 févr. 2017

    2 pagesAP04

    Changement d'adresse du siège social de C/O Teacher Stern Llp 37-41 Bedford Row London WC1R 4JH à 35 Great St Helen's London EC3A 6AP le 28 févr. 2017

    1 pagesAD01

    Nomination de Mr Maurice Alexander Kalsbeek en tant qu'administrateur le 23 févr. 2017

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Daniel Christopher Vijselaar en tant qu'administrateur le 23 févr. 2017

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Nicholas Emlyn Peter Reid en tant que directeur le 23 févr. 2017

    1 pagesTM01

    Nomination de Miss Melissa Gabrielle Bourgeois en tant qu'administrateur le 23 févr. 2017

    2 pagesAP01

    Qui sont les dirigeants de GYLE SHOPPING CENTRE GENERAL PARTNER LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    INTERTRUST (UK) LIMITED
    Great St. Helen's
    EC3A 6AP London
    35
    England
    Secrétaire
    Great St. Helen's
    EC3A 6AP London
    35
    England
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement06307550
    188126550001
    BOURGEOIS, Melissa Gabrielle
    Great St. Helen's
    EC3A 6AP London
    35
    England
    Administrateur
    Great St. Helen's
    EC3A 6AP London
    35
    England
    United KingdomBritishDirector222397120001
    BREDERO, Annick Agnes
    Great St Helen's
    EC3A 6AP London
    35
    England
    Administrateur
    Great St Helen's
    EC3A 6AP London
    35
    England
    United KingdomDutchDirector244929000001
    HOFLAND, Raoul Rene
    Great St. Helen's
    EC3A 6AP London
    35
    England
    Administrateur
    Great St. Helen's
    EC3A 6AP London
    35
    England
    NetherlandsDutchDirector203934820001
    LEJUNE, Amy Nicole
    Great St Helen's
    EC3A 6AP London
    35
    England
    Administrateur
    Great St Helen's
    EC3A 6AP London
    35
    England
    United KingdomAmericanAccountant216235620001
    SCHIPPER, Gerardus Johannes
    Great St. Helen's
    EC3A 6AP London
    35
    England
    Administrateur
    Great St. Helen's
    EC3A 6AP London
    35
    England
    NetherlandsDutchDirector172791800001
    CREIGHTON, David Andrew
    c/o Teacher Stern Llp
    Bedford Row
    WC1R 4JH London
    37-41
    England
    Secrétaire
    c/o Teacher Stern Llp
    Bedford Row
    WC1R 4JH London
    37-41
    England
    British83528100001
    SHERLOCK, Ian Montague
    73 Queens Avenue
    Meols
    CH47 0LT Wirral
    Merseyside
    Secrétaire
    73 Queens Avenue
    Meols
    CH47 0LT Wirral
    Merseyside
    BritishAccountant106839080001
    LAWGRAM SECRETARIES LIMITED
    More London Riverside
    SE1 2AU London
    4
    Secrétaire désigné
    More London Riverside
    SE1 2AU London
    4
    900004760001
    BOYD, Francis Edward
    c/o Teacher Stern Llp
    Bedford Row
    WC1R 4JH London
    37-41
    England
    Administrateur
    c/o Teacher Stern Llp
    Bedford Row
    WC1R 4JH London
    37-41
    England
    Northern IrelandNorthern IrishProperty Developer83528370002
    BURNETT, Graham Alan
    17 Church Street
    Colne Engaine
    CO6 2EX Colchester
    Essex
    Administrateur
    17 Church Street
    Colne Engaine
    CO6 2EX Colchester
    Essex
    United KingdomBritishFund Manager111805410001
    CREIGHTON, David Andrew
    Malone Park House
    Malone Park
    BT9 6NL Belfast
    Administrateur
    Malone Park House
    Malone Park
    BT9 6NL Belfast
    Northern IrelandBritishDirector83528100001
    HUNTER, Colin Stewart
    11 Longworth Road
    Egerton
    BL7 9TS Bolton
    Greater Manchester
    Administrateur
    11 Longworth Road
    Egerton
    BL7 9TS Bolton
    Greater Manchester
    EnglandBritishAccountant53084060001
    KALSBEEK, Maurice Alexander
    Great St. Helen's
    EC3A 6AP London
    35
    England
    Administrateur
    Great St. Helen's
    EC3A 6AP London
    35
    England
    United KingdomDutchDirector199209280001
    REID, Nicholas Emlyn Peter
    c/o Teacher Stern Llp
    Bedford Row
    WC1R 4JH London
    37-41
    England
    Administrateur
    c/o Teacher Stern Llp
    Bedford Row
    WC1R 4JH London
    37-41
    England
    Northern IrelandBritishCompany Director75236310001
    SHERLOCK, Ian Montague
    73 Queens Avenue
    Meols
    CH47 0LT Wirral
    Merseyside
    Administrateur
    73 Queens Avenue
    Meols
    CH47 0LT Wirral
    Merseyside
    United KingdomBritishAccountant106839080001
    VIJSELAAR, Daniel Christopher
    Great St. Helen's
    EC3A 6AP London
    35
    England
    Administrateur
    Great St. Helen's
    EC3A 6AP London
    35
    England
    United KingdomDutchDirector195333960001
    WALDEN, Robert Graham
    Mapletons
    Crawley End, Chrishall
    SG8 8QN Royston
    Hertfordshire
    Administrateur
    Mapletons
    Crawley End, Chrishall
    SG8 8QN Royston
    Hertfordshire
    EnglandBritishSurveyor65156020001
    WILLIAMS, Guy Rodney
    346 The Chase
    SS7 3DN Benfleet
    Essex
    Administrateur
    346 The Chase
    SS7 3DN Benfleet
    Essex
    EnglandBritishChartered Surveyor100570560001
    WHALE ROCK DIRECTORS LIMITED
    More London Riverside
    SE1 2AU London
    4
    Administrateur désigné
    More London Riverside
    SE1 2AU London
    4
    900019450001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur GYLE SHOPPING CENTRE GENERAL PARTNER LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Great St. Helen's
    EC3A 6AP London
    35
    England
    23 févr. 2017
    Great St. Helen's
    EC3A 6AP London
    35
    England
    Non
    Forme juridiquePrivate Limited Company
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement10563127
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.

    Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour GYLE SHOPPING CENTRE GENERAL PARTNER LIMITED ?

    Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
    Notifié leCessé leDéclaration
    21 févr. 201716 mars 2017La société n'a pas encore achevé les mesures raisonnables pour déterminer si une personne est une personne enregistrable ou une entité juridique pertinente enregistrable en relation avec la société.

    GYLE SHOPPING CENTRE GENERAL PARTNER LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 01 mars 2017
    Livré le 06 mars 2017
    En cours
    Brève description
    All and whole the land known as gyle shopping centre, south gyle broadway, edinburgh, EH12 9JY, the registered proprietor's interest in which land being registered in the land register of scotland under title number MID91568 together with free ish and entry to and from the said land by south gyle broadway.
    Débiteur agissant en tant que fiduciaire nu: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Personnes ayant droit
    • Mount Street Mortgage Servicing Limited (As Common Security Agent)
    Transactions
    • 06 mars 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 23 févr. 2017
    Livré le 03 mars 2017
    En cours
    Brève description
    N/A.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Mount Street Mortgage Servicing Limited (As Security Trustee for Each of the Secured Parties (the "Common Security Agent"))
    Transactions
    • 03 mars 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 23 févr. 2017
    Livré le 02 mars 2017
    En cours
    Brève description
    None.
    Débiteur agissant en tant que fiduciaire nu: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Mount Street Mortgage Servicing Limited (As Common Security Agent)
    Transactions
    • 02 mars 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    Debenture
    Créé le 05 oct. 2006
    Livré le 24 oct. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee the security trustee (whether for its own account or as trustee for the secured parties) or any of the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All assets and undertakings. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transactions
    • 24 oct. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 févr. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    A standard security which was presented for registration in scotland on the 17/10/2006 and
    Créé le 05 oct. 2006
    Livré le 20 oct. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Gyle shopping centre south gyle lying on or towards the north, northeast side of south gyle broadway edinburgh midlothian t/no MID91568 the parts privileges and pertinents fixtures and fittings. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transactions
    • 20 oct. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 févr. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0