GYLE SHOPPING CENTRE GENERAL PARTNER LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | GYLE SHOPPING CENTRE GENERAL PARTNER LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 05716360 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe GYLE SHOPPING CENTRE GENERAL PARTNER LIMITED ?
Adresse du siège social | 35 Great St Helen's EC3A 6AP London England |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de GYLE SHOPPING CENTRE GENERAL PARTNER LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2016 |
Quels sont les derniers dépôts pour GYLE SHOPPING CENTRE GENERAL PARTNER LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 18 avr. 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Nomination de Annick Agnes Bredero en tant qu'administrateur le 04 avr. 2018 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Maurice Alexander Kalsbeek en tant que directeur le 04 avr. 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Miss Amy Nicole Lejune en tant qu'administrateur le 11 déc. 2017 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Daniel Christopher Vijselaar en tant que directeur le 11 déc. 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2016 | 2 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 18 avr. 2017 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 16 mars 2017 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 21 févr. 2017 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 6 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Période comptable précédente prolongée du 30 juin 2016 au 31 déc. 2016 | 1 pages | AA01 | ||||||||||
Inscription de la charge 057163600005, créée le 01 mars 2017 | 22 pages | MR01 | ||||||||||
Inscription de la charge 057163600004, créée le 23 févr. 2017 | 52 pages | MR01 | ||||||||||
Inscription de la charge 057163600003, créée le 23 févr. 2017 | 28 pages | MR01 | ||||||||||
Nomination de Mr Gerardus Johannes Schipper en tant qu'administrateur le 23 févr. 2017 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Raoul Rene Hofland en tant qu'administrateur le 23 févr. 2017 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Intertrust (Uk) Limited en tant que secrétaire le 23 févr. 2017 | 2 pages | AP04 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de C/O Teacher Stern Llp 37-41 Bedford Row London WC1R 4JH à 35 Great St Helen's London EC3A 6AP le 28 févr. 2017 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Nomination de Mr Maurice Alexander Kalsbeek en tant qu'administrateur le 23 févr. 2017 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Daniel Christopher Vijselaar en tant qu'administrateur le 23 févr. 2017 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Nicholas Emlyn Peter Reid en tant que directeur le 23 févr. 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Miss Melissa Gabrielle Bourgeois en tant qu'administrateur le 23 févr. 2017 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de GYLE SHOPPING CENTRE GENERAL PARTNER LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTERTRUST (UK) LIMITED | Secrétaire | Great St. Helen's EC3A 6AP London 35 England |
| 188126550001 | ||||||||||
BOURGEOIS, Melissa Gabrielle | Administrateur | Great St. Helen's EC3A 6AP London 35 England | United Kingdom | British | Director | 222397120001 | ||||||||
BREDERO, Annick Agnes | Administrateur | Great St Helen's EC3A 6AP London 35 England | United Kingdom | Dutch | Director | 244929000001 | ||||||||
HOFLAND, Raoul Rene | Administrateur | Great St. Helen's EC3A 6AP London 35 England | Netherlands | Dutch | Director | 203934820001 | ||||||||
LEJUNE, Amy Nicole | Administrateur | Great St Helen's EC3A 6AP London 35 England | United Kingdom | American | Accountant | 216235620001 | ||||||||
SCHIPPER, Gerardus Johannes | Administrateur | Great St. Helen's EC3A 6AP London 35 England | Netherlands | Dutch | Director | 172791800001 | ||||||||
CREIGHTON, David Andrew | Secrétaire | c/o Teacher Stern Llp Bedford Row WC1R 4JH London 37-41 England | British | 83528100001 | ||||||||||
SHERLOCK, Ian Montague | Secrétaire | 73 Queens Avenue Meols CH47 0LT Wirral Merseyside | British | Accountant | 106839080001 | |||||||||
LAWGRAM SECRETARIES LIMITED | Secrétaire désigné | More London Riverside SE1 2AU London 4 | 900004760001 | |||||||||||
BOYD, Francis Edward | Administrateur | c/o Teacher Stern Llp Bedford Row WC1R 4JH London 37-41 England | Northern Ireland | Northern Irish | Property Developer | 83528370002 | ||||||||
BURNETT, Graham Alan | Administrateur | 17 Church Street Colne Engaine CO6 2EX Colchester Essex | United Kingdom | British | Fund Manager | 111805410001 | ||||||||
CREIGHTON, David Andrew | Administrateur | Malone Park House Malone Park BT9 6NL Belfast | Northern Ireland | British | Director | 83528100001 | ||||||||
HUNTER, Colin Stewart | Administrateur | 11 Longworth Road Egerton BL7 9TS Bolton Greater Manchester | England | British | Accountant | 53084060001 | ||||||||
KALSBEEK, Maurice Alexander | Administrateur | Great St. Helen's EC3A 6AP London 35 England | United Kingdom | Dutch | Director | 199209280001 | ||||||||
REID, Nicholas Emlyn Peter | Administrateur | c/o Teacher Stern Llp Bedford Row WC1R 4JH London 37-41 England | Northern Ireland | British | Company Director | 75236310001 | ||||||||
SHERLOCK, Ian Montague | Administrateur | 73 Queens Avenue Meols CH47 0LT Wirral Merseyside | United Kingdom | British | Accountant | 106839080001 | ||||||||
VIJSELAAR, Daniel Christopher | Administrateur | Great St. Helen's EC3A 6AP London 35 England | United Kingdom | Dutch | Director | 195333960001 | ||||||||
WALDEN, Robert Graham | Administrateur | Mapletons Crawley End, Chrishall SG8 8QN Royston Hertfordshire | England | British | Surveyor | 65156020001 | ||||||||
WILLIAMS, Guy Rodney | Administrateur | 346 The Chase SS7 3DN Benfleet Essex | England | British | Chartered Surveyor | 100570560001 | ||||||||
WHALE ROCK DIRECTORS LIMITED | Administrateur désigné | More London Riverside SE1 2AU London 4 | 900019450001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur GYLE SHOPPING CENTRE GENERAL PARTNER LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Promontoria Gyle Holdings (2) Ltd | 23 févr. 2017 | Great St. Helen's EC3A 6AP London 35 England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour GYLE SHOPPING CENTRE GENERAL PARTNER LIMITED ?
Notifié le | Cessé le | Déclaration |
---|---|---|
21 févr. 2017 | 16 mars 2017 | La société n'a pas encore achevé les mesures raisonnables pour déterminer si une personne est une personne enregistrable ou une entité juridique pertinente enregistrable en relation avec la société. |
GYLE SHOPPING CENTRE GENERAL PARTNER LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Créé le 01 mars 2017 Livré le 06 mars 2017 | En cours | ||
Brève description All and whole the land known as gyle shopping centre, south gyle broadway, edinburgh, EH12 9JY, the registered proprietor's interest in which land being registered in the land register of scotland under title number MID91568 together with free ish and entry to and from the said land by south gyle broadway. Débiteur agissant en tant que fiduciaire nu: Oui Contient une promesse négative: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A registered charge | Créé le 23 févr. 2017 Livré le 03 mars 2017 | En cours | ||
Brève description N/A. La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A registered charge | Créé le 23 févr. 2017 Livré le 02 mars 2017 | En cours | ||
Brève description None. Débiteur agissant en tant que fiduciaire nu: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 05 oct. 2006 Livré le 24 oct. 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee the security trustee (whether for its own account or as trustee for the secured parties) or any of the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions All assets and undertakings. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A standard security which was presented for registration in scotland on the 17/10/2006 and | Créé le 05 oct. 2006 Livré le 20 oct. 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee or any of the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Gyle shopping centre south gyle lying on or towards the north, northeast side of south gyle broadway edinburgh midlothian t/no MID91568 the parts privileges and pertinents fixtures and fittings. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0