GS EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND II GP LTD

GS EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND II GP LTD

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéGS EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND II GP LTD
    Statut de la sociétéLiquidation
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 05732029
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de GS EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND II GP LTD ?

    • Intermédiation financière n.c.a. (64999) / Activités financières et d'assurance

    Où se situe GS EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND II GP LTD ?

    Adresse du siège social
    C/O Interpath Ltd
    10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de GS EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND II GP LTD ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 déc. 2017
    Date d'échéance des prochains comptes30 sept. 2018
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2016

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour GS EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND II GP LTD ?

    En retardOui
    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au15 avr. 2020
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation29 avr. 2020
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au15 avr. 2019
    En retardOui

    Quels sont les derniers dépôts pour GS EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND II GP LTD ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 23 sept. 2024

    19 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 23 sept. 2023

    19 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 23 sept. 2022

    9 pagesLIQ03

    Changement d'adresse du siège social de 10 Fleet Place London EC4M 7QS à C/O Interpath Ltd 10 Fleet Place London EC4M 7RB le 04 juil. 2022

    2 pagesAD01

    Révocation du liquidateur par ordonnance du tribunal

    104 pagesLIQ10

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Changement d'adresse du siège social de 15 Canada Square London E14 5GL à 10 Fleet Place London EC4M 7QS le 21 déc. 2021

    2 pagesAD01

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 23 sept. 2021

    10 pagesLIQ03

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    42 pages600

    Démission d'un liquidateur

    3 pagesLIQ06

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 23 sept. 2020

    9 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 23 sept. 2019

    10 pagesLIQ03

    Modification des coordonnées du secrétaire Mr Thomas Kelly le 02 sept. 2019

    1 pagesCH03

    Modification des coordonnées de l'administrateur Ms. Jayshri Sriram le 02 sept. 2019

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Oliver John Bingham le 02 sept. 2019

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Jeremy Alan Wiltshire le 02 sept. 2019

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées du secrétaire Clare Charlotte Richards le 02 sept. 2019

    1 pagesCH03

    Déclaration de confirmation établie le 15 avr. 2019 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Changement d'adresse du siège social de Peterborough Court 133 Fleet Street London EC4A 2BB à 15 Canada Square London E14 5GL le 05 oct. 2018

    2 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    5 pagesLIQ01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 24 sept. 2018

    LRESSP

    Satisfaction de la charge 2 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 1 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 5 en totalité

    4 pagesMR04

    Qui sont les dirigeants de GS EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND II GP LTD ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    KELLY, Thomas
    25 Shoe Lane
    EC4A 4AU London
    Plumtree Court
    United Kingdom
    Secrétaire
    25 Shoe Lane
    EC4A 4AU London
    Plumtree Court
    United Kingdom
    180736550001
    RICHARDS, Clare Charlotte
    25 Shoe Lane
    EC4A 4AU London
    Plumtree Court
    United Kingdom
    Secrétaire
    25 Shoe Lane
    EC4A 4AU London
    Plumtree Court
    United Kingdom
    150039490001
    BINGHAM, Oliver John
    25 Shoe Lane
    EC4A 4AU London
    Plumtree Court
    United Kingdom
    Administrateur
    25 Shoe Lane
    EC4A 4AU London
    Plumtree Court
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant179230260001
    SRIRAM, Jayshri, Ms.
    25 Shoe Lane
    EC4A 4AU London
    Plumtree Court
    United Kingdom
    Administrateur
    25 Shoe Lane
    EC4A 4AU London
    Plumtree Court
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant236219160001
    WILTSHIRE, Jeremy Alan
    25 Shoe Lane
    EC4A 4AU London
    Plumtree Court
    United Kingdom
    Administrateur
    25 Shoe Lane
    EC4A 4AU London
    Plumtree Court
    United Kingdom
    United KingdomBritishBanker190987380001
    BROWN, Nola Jean, Ms.
    Peterborough Court
    133 Fleet Street
    EC4A 2BB London
    Secrétaire
    Peterborough Court
    133 Fleet Street
    EC4A 2BB London
    BritishCompany Secretary121744860001
    ELLIOTT, William James
    Peterborough Court
    133 Fleet Street
    EC4A 2BB London
    Secrétaire
    Peterborough Court
    133 Fleet Street
    EC4A 2BB London
    British56945250002
    RUSSELL, Nicholas David
    Peterborough Court
    133 Fleet Street
    EC4A 2BB London
    Secrétaire
    Peterborough Court
    133 Fleet Street
    EC4A 2BB London
    British83581360003
    HACKWOOD SECRETARIES LIMITED
    One Silk Street
    EC2Y 8HQ London
    Secrétaire désigné
    One Silk Street
    EC2Y 8HQ London
    900004790001
    CAMPBELL II, Roy Edwin
    Peterborough Court
    133 Fleet Street
    EC4A 2BB London
    Administrateur
    Peterborough Court
    133 Fleet Street
    EC4A 2BB London
    United States CitizenInvestment Banker100607170003
    COLLINS, Shaun Anthony, Mr.
    Peterborough Court
    133 Fleet Street
    EC4A 2BB London
    Administrateur
    Peterborough Court
    133 Fleet Street
    EC4A 2BB London
    EnglandBritishAccountant163985940001
    DICKENS, Charlotte Elise
    Peterborough Court
    133 Fleet Street
    EC4A 2BB London
    Administrateur
    Peterborough Court
    133 Fleet Street
    EC4A 2BB London
    EnglandBritishBanker122888200001
    GANLEY, James Patrick
    133 Fleet Street
    EC4A 2BB London
    Peterborough Court
    United Kingdom
    Administrateur
    133 Fleet Street
    EC4A 2BB London
    Peterborough Court
    United Kingdom
    OtherTrader128877580001
    HOLMES, Michael
    133 Fleet Street
    EC4A 2BB London
    Peterborough Court
    United Kingdom
    Administrateur
    133 Fleet Street
    EC4A 2BB London
    Peterborough Court
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant181558290001
    HUNT, Susan Jane
    Peterborough Court
    133 Fleet Street
    EC4A 2BB London
    Administrateur
    Peterborough Court
    133 Fleet Street
    EC4A 2BB London
    BritishInvestment Banker50630880005
    MARTE, Carolina
    Peterborough Court
    133 Fleet Street
    EC4A 2BB London
    Administrateur
    Peterborough Court
    133 Fleet Street
    EC4A 2BB London
    EnglandDominican RepublicExecutive Director / Vice President156951830001
    MCDERMOTT, Mathew Richard
    Peterborough Court
    133 Fleet Street
    EC4A 2BB London
    Administrateur
    Peterborough Court
    133 Fleet Street
    EC4A 2BB London
    BritishInvestment Banker109728670001
    MINSON, Gregory Paul
    Peterborough Court
    133 Fleet Street
    EC4A 2BB London
    Administrateur
    Peterborough Court
    133 Fleet Street
    EC4A 2BB London
    United KingdomAmerican,BritishInvestment Banker100607190002
    TAMMELA, Kimmo Benjam
    Peterborough Court
    133 Fleet Street
    EC4A 2BB London
    Administrateur
    Peterborough Court
    133 Fleet Street
    EC4A 2BB London
    BritishInvestment Banker95010560002
    HACKWOOD DIRECTORS LIMITED
    One Silk Street
    EC2Y 8HQ London
    Administrateur désigné
    One Silk Street
    EC2Y 8HQ London
    900004840001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur GS EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND II GP LTD ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    133 Fleet Street
    EC4A 2BB London
    Peterborough Court
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    133 Fleet Street
    EC4A 2BB London
    Peterborough Court
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement04762058
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    GS EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND II GP LTD a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Charge over shares
    Créé le 26 mars 2009
    Livré le 08 avr. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of a fixed charge all interest in and to the secured property being the shares in the capital of kypris acquisitions LTD registered in the name of the chargor and all rights including the dividends. See image for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Norinchukin Trust and Banking Co.,LTD as Lender of the Tranche a Loan, Tranche B Loan, Tranche C Loan, Tranche D Loan, Tranche E Loan and the Tranche F Loan
    Transactions
    • 08 avr. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 sept. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of assignment and charge
    Créé le 26 mars 2009
    Livré le 08 avr. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of first ranking security and by way of first floating charge all rights title and interest in and to the assigned assets. See image for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Norinchukin Trust and Banking Co.,LTD as Lender of the Tranche a Loan, Tranche B Loan, Tranche C Loan, Tranche D Loan, Tranche E Loan and the Tranche F Loan
    Transactions
    • 08 avr. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 sept. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Charge over shares
    Créé le 26 mars 2009
    Livré le 08 avr. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of a fixed charge all interest in and to the secured property being the shares in the capital of gs european investment group ii LTD registered in the name of the chargor and all rights including the dividends. See image for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Norinchukin Trust and Banking Co.,LTD as Lender of the Tranche a Loan, Tranche B Loan, Tranche C Loan, Tranche D Loan, Tranche E Loan and the Tranche F Loan
    Transactions
    • 08 avr. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 sept. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Charge over shares
    Créé le 26 mars 2009
    Livré le 08 avr. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of a fixed charge all interest in and to the secured property being the shares in the capital of kreta acquisitions LTD registered in the name of the chargor and all rights including the dividends. See image for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Norinchukin Trust and Banking Co.,LTD as Lender of the Tranche a Loan, Tranche B Loan, Tranche C Loan, Tranche D Loan, Tranche E Loan and the Tranche F Loan
    Transactions
    • 08 avr. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 sept. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Charge over shares
    Créé le 26 mars 2009
    Livré le 08 avr. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of a fixed charge all interest in and to the secured property being the shares in the capital of poseidon acquisitions LTD registered in the name of the chargor and all rights including the dividends. See image for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Norinchukin Trust and Banking Co.,LTD as Lender of the Tranche a Loan, Tranche B Loan, Tranche C Loan, Tranche D Loan, Tranche E Loan and the Tranche F Loan
    Transactions
    • 08 avr. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 sept. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Charge over shares
    Créé le 26 mars 2009
    Livré le 08 avr. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of a fixed charge all interest in and to the secured property being the shares in the capital of sana acquisitions LTD registered in the name of the chargor and all rights including the dividends. See image for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Norinchukin Trust and Banking Co.,LTD as Lender of the Tranche a Loan, Tranche B Loan, Tranche C Loan, Tranche D Loan, Tranche E Loan and the Tranche F Loan
    Transactions
    • 08 avr. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 sept. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Charge over shares
    Créé le 20 juil. 2007
    Livré le 08 août 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    First fixed charge all of its interest in and to all of the secured property being all shares stock including dividends. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Norinchukin Trust and Banking Co., LTD
    Transactions
    • 08 août 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 sept. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Charge over assets
    Créé le 10 avr. 2007
    Livré le 25 avr. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All interest in and to all the secured property,stocks,shares,warrants,securities,moneys,dividends or property. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Norinchukin Trust and Banking Co., LTD
    Transactions
    • 25 avr. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 sept. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Charge over shares
    Créé le 28 mars 2007
    Livré le 13 avr. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed charge the secured property being the shares in the capital of kypris registered in the name of the company. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Norinchukin Trust and Banking Co., LTD
    Transactions
    • 13 avr. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 sept. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Charge over shares
    Créé le 28 mars 2006
    Livré le 07 avr. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Interest in the secured property being the shares in the capital of kreta and all stock, shares, warrants, securities, rights, moneys or property. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Norinchukin Trust and Bank Co. LTD
    Transactions
    • 07 avr. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 sept. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Charge over shares
    Créé le 28 mars 2006
    Livré le 07 avr. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Interest in the secured property being the shares in the capital of gseig ii and all stock, shares, warrants, securities, rights, moneys or property. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Norinchukin Trust and Bank Co. LTD
    Transactions
    • 07 avr. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 sept. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)

    GS EUROPEAN OPPORTUNITIES FUND II GP LTD a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    24 sept. 2018Commencement of winding up
    24 sept. 2018Declaration of solvency sworn on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Nicholas James Timpson
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    practitioner
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    Mark Jeremy Orton
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    practitioner
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    David John Pike
    9th Floor 10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    practitioner
    9th Floor 10 Fleet Place
    EC4M 7RB London
    Stephen John Absolom
    15 Canada Square
    E14 5GL London
    practitioner
    15 Canada Square
    E14 5GL London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0