LMS CAPITAL PLC

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéLMS CAPITAL PLC
    Statut de la sociétéActive
    Forme juridiqueSociété anonyme cotée en bourse
    Numéro de société 05746555
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesNon
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de LMS CAPITAL PLC ?

    • Intermédiation financière n.c.a. (64999) / Activités financières et d'assurance
    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe LMS CAPITAL PLC ?

    Adresse du siège social
    3 Bromley Place
    W1T 6DB London
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de LMS CAPITAL PLC ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    LEO CAPITAL PLC07 avr. 200607 avr. 2006
    SHILLINGBRIDGE PLC17 mars 200617 mars 2006

    Quels sont les derniers comptes de LMS CAPITAL PLC ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 déc. 2025
    Date d'échéance des prochains comptes30 juin 2026
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2024

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour LMS CAPITAL PLC ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au17 mars 2027
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation31 mars 2027
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au17 mars 2026
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour LMS CAPITAL PLC ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Déclaration de confirmation établie le 17 mars 2026 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    État du capital après une attribution d'actions au 19 janv. 2026

    • Capital: GBP 1,622,621.745
    4 pagesSH01

    État du capital au 19 janv. 2026

    • Capital: GBP 8,072.745
    4 pagesSH02

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr James Mcmoran Wilson le 27 janv. 2026

    2 pagesCH01

    Démission de l'auditeur

    2 pagesAUD

    État du capital après une attribution d'actions au 14 juil. 2025

    • Capital: GBP 1,622,621.7450
    4 pagesSH01

    Changement de nom ou de désignation de la catégorie d'actions

    2 pagesSH08

    État du capital au 14 juil. 2025

    • Capital: GBP 8,072.7450
    4 pagesSH02

    État du capital au 04 août 2025

    • Capital: GBP 8,072.745
    3 pagesSH19

    État du capital au 13 juin 2025

    • Capital: GBP 80,727.45
    3 pagesSH19
    Annotations
    DateAnnotation
    04 août 2025Clarification A SECOND FILED SH19 WAS REGISTERED ON 04/08/2025.

    legacy

    2 pagesOC138

    Certificat de réduction du capital émis et de la prime d'émission et annulation de la prime d'émission et de la réserve de capital de remboursement

    1 pagesCERT18

    Résolutions

    Resolutions
    4 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Re: amended investment policy be approved / cancel share premium a/c and cap redemption reserve/ conditional upon the capital reduction becoming effective the directors from time to time can capitalise any sum or sums standing to the credit of any reserve of the company / conditional upon the capital reduction becoming effective and resolution 3 and 4 under section 551 of the companies act 2006 be authorised to allot and issue fixed rate preference shares 14/05/2025
    RES13
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06
    incorporation

    Résolution de modification des statuts

    RES01

    Statuts

    55 pagesMA

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de suppression des droits de préemption

    RES11
    capital

    Résolutions

    Re: short notice of a meeting other than an annual general meeting 14/05/2025
    RES13
    capital

    Résolution d'autorisation d'achat d'un certain nombre d'actions

    RES09
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2024

    88 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 17 mars 2025 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Nomination de Iq Eq Secretaries (Uk) Limited en tant que secrétaire le 13 nov. 2024

    2 pagesAP04

    Cessation de la nomination de Iq Eq Corporate Services (Uk) Limited en tant que secrétaire le 13 nov. 2024

    1 pagesTM02

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2023

    94 pagesAA

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution d'autorisation d'achat d'un certain nombre d'actions

    RES09
    capital

    Résolutions

    Rules of the lms capital PLC 2023 share incentive plan amended, notice of general meeting 15/05/2024
    RES13
    capital

    Résolution de suppression des droits de préemption

    RES11
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10

    Déclaration de confirmation établie le 17 mars 2024 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Graham Stedman le 28 août 2023

    2 pagesCH01

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de suppression des droits de préemption

    RES11
    capital

    Résolution d'autorisation d'achat d'un certain nombre d'actions

    RES09
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2022

    101 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de LMS CAPITAL PLC ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    IQ EQ SECRETARIES (UK) LIMITED
    3 More London Riverside
    SE1 2AQ London
    4th Floor
    United Kingdom
    Secrétaire
    3 More London Riverside
    SE1 2AQ London
    4th Floor
    United Kingdom
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrement09252280
    218147570017
    FRIEDLOS, Nicholas Robert
    Bromley Place
    W1T 6DB London
    3
    United Kingdom
    Administrateur
    Bromley Place
    W1T 6DB London
    3
    United Kingdom
    United KingdomBritish247728540001
    HARVEY, Peter Shaw
    Bromley Place
    W1T 6DB London
    3
    United Kingdom
    Administrateur
    Bromley Place
    W1T 6DB London
    3
    United Kingdom
    EnglandBritish265079960001
    RAYNE, Robert Anthony
    Bromley Place
    W1T 6DB London
    3
    United Kingdom
    Administrateur
    Bromley Place
    W1T 6DB London
    3
    United Kingdom
    EnglandBritish53009350017
    STEDMAN, Graham
    Bromley Place
    W1T 6DB London
    3
    United Kingdom
    Administrateur
    Bromley Place
    W1T 6DB London
    3
    United Kingdom
    EnglandBritish141455540002
    WILSON, James Mcmoran
    Bromley Place
    W1T 6DB London
    3
    United Kingdom
    Administrateur
    Bromley Place
    W1T 6DB London
    3
    United Kingdom
    United StatesAmerican265222500001
    EDIS-BATES, Jonathan Geoffrey
    32 High Street
    WD3 1ER Rickmansworth
    The Hour House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    32 High Street
    WD3 1ER Rickmansworth
    The Hour House
    Hertfordshire
    United Kingdom
    165670850001
    JONES, Matthew David Alexander
    George Street
    W1U 8NU London
    100
    United Kingdom
    Secrétaire
    George Street
    W1U 8NU London
    100
    United Kingdom
    British65657530001
    SWEET, Antony Charles Samuel
    George Street
    W1U 8NU London
    100
    United Kingdom
    Secrétaire
    George Street
    W1U 8NU London
    100
    United Kingdom
    176831010001
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Secrétaire désigné
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    900005620001
    EDIS- BATES ASSOCIATES LIMITED
    The Hour House
    32 High Street
    WD3 1ER Rickmansworth
    Hertfordshire
    Secrétaire
    The Hour House
    32 High Street
    WD3 1ER Rickmansworth
    Hertfordshire
    112308060001
    IQ EQ CORPORATE SERVICES (UK) LIMITED
    London Bridge
    SE1 9RA London
    Two
    England
    Secrétaire
    London Bridge
    SE1 9RA London
    Two
    England
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrement09838906
    203404770002
    AGNEW, Jonathan Geoffrey William
    Flat E
    51 Eaton Square
    SW1W 9BE London
    Administrateur
    Flat E
    51 Eaton Square
    SW1W 9BE London
    United KingdomBritish8333420001
    BARNSLEY, John Corbitt
    George Street
    W1U 8NU London
    100
    United Kingdom
    Administrateur
    George Street
    W1U 8NU London
    100
    United Kingdom
    EnglandBritish79608860004
    BIRKETT, Roderic Aidan
    London Bridge
    SE1 9RA London
    Two
    United Kingdom
    Administrateur
    London Bridge
    SE1 9RA London
    Two
    United Kingdom
    EnglandBritish43887230002
    CHRISTOU, Richard
    George Street
    W1U 8NU London
    100
    United Kingdom
    Administrateur
    George Street
    W1U 8NU London
    100
    United Kingdom
    SingaporeBritish5835350005
    DUROC DANNER, Bernard Jacques, Dr
    George Street
    W1U 8NU London
    100
    Administrateur
    George Street
    W1U 8NU London
    100
    UsaUnited States Citizen100021950002
    FRIEDLOS, Nicholas Robert
    George Street
    W1U 8NU London
    100
    United Kingdom
    Administrateur
    George Street
    W1U 8NU London
    100
    United Kingdom
    EnglandBritish166922260001
    KNIGHT, Martin Peter, Dr
    London Bridge
    SE1 9RA London
    Two
    United Kingdom
    Administrateur
    London Bridge
    SE1 9RA London
    Two
    United Kingdom
    United KingdomBritish166002790001
    LERNER, Neil Joseph
    London Bridge
    SE1 9RA London
    Two
    United Kingdom
    Administrateur
    London Bridge
    SE1 9RA London
    Two
    United Kingdom
    United KingdomBritish70372020001
    LEVY, Adrian Joseph Morris
    2 Carlisle Gardens
    HA3 0JX Harrow
    Middlesex
    Administrateur
    2 Carlisle Gardens
    HA3 0JX Harrow
    Middlesex
    United KingdomBritish147682410001
    PAYNE, Glenn Jeffrey
    George Street
    W1U 8NU London
    100
    United Kingdom
    Administrateur
    George Street
    W1U 8NU London
    100
    United Kingdom
    EnglandAmerican151283860003
    PEXTON, Martin Andrew
    Little Kensham Farm, Sandhurst Lane
    Rolvenden
    TN17 4PH Cranbrook
    Kent
    Administrateur
    Little Kensham Farm, Sandhurst Lane
    Rolvenden
    TN17 4PH Cranbrook
    Kent
    EnglandBritish87643530001
    PUDGE, David John
    20 Herondale Avenue
    SW18 3JL London
    Administrateur désigné
    20 Herondale Avenue
    SW18 3JL London
    British900028170001
    SEBBA, Mark Jonathan
    George Street
    W1U 8NU London
    100
    United Kingdom
    Administrateur
    George Street
    W1U 8NU London
    100
    United Kingdom
    EnglandBritish1184350001
    SWEET, Antony Charles Samuel
    George Street
    W1U 8NU London
    100
    United Kingdom
    Administrateur
    George Street
    W1U 8NU London
    100
    United Kingdom
    United KingdomBritish95204330001
    VEREY, David John, Sir
    George Street
    W1U 8NU London
    100
    United Kingdom
    Administrateur
    George Street
    W1U 8NU London
    100
    United Kingdom
    EnglandBritish4769330001

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0