JESSOP FUND MANAGERS LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | JESSOP FUND MANAGERS LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 05768993 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe JESSOP FUND MANAGERS LIMITED ?
Adresse du siège social | 6th Floor 65 Gresham Street EC2V 7NQ London United Kingdom |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de JESSOP FUND MANAGERS LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 30 juin 2020 |
Quels sont les derniers dépôts pour JESSOP FUND MANAGERS LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Cessation de la nomination de Christopher Addenbrooke en tant que directeur le 03 févr. 2022 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
La procédure de radiation volontaire a été suspendue. | 1 pages | SOAS(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 2 pages | DS01 | ||||||||||
legacy | 1 pages | SH20 | ||||||||||
État du capital au 17 juin 2021
| 3 pages | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 pages | CAP-SS | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes annuels établis au 30 juin 2020 | 16 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 31 mars 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Modification des détails de Link Asset Services (Holdings) Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 05 mars 2021 | 2 pages | PSC05 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 31 mars 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Nomination de Mr Karl Joseph Midl en tant qu'administrateur le 18 mars 2020 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Christopher Addenbrooke en tant qu'administrateur le 11 mars 2020 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Nigel Stephen Boyling en tant que directeur le 11 mars 2020 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 30 juin 2019 | 17 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Peter Hugh Smith en tant que directeur le 05 juil. 2019 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 31 mars 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 30 juin 2018 | 17 pages | AA | ||||||||||
Période comptable actuelle prolongée du 31 mai 2018 au 30 juin 2018 | 1 pages | AA01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 31 mars 2018 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Peter Hugh Smith le 13 oct. 2017 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Benjamin Hammond le 13 oct. 2017 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Nigel Stephen Boyling le 13 oct. 2017 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de JESSOP FUND MANAGERS LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINK GROUP CORPORATE SECRETARY LIMITED | Secrétaire | 65 Gresham Street EC2V 7NQ London 6th Floor United Kingdom |
| 239784340001 | ||||||||||
HAMMOND, Benjamin | Administrateur | 65 Gresham Street EC2V 7NQ London 6th Floor United Kingdom | England | British | Director | 202668770001 | ||||||||
MIDL, Karl Joseph | Administrateur | 65 Gresham Street EC2V 7NQ London 6th Floor United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 108256450004 | ||||||||
BAILEY, Stephen | Secrétaire | Cavendish Road Heaton Mersey SK4 3DN Stockport 32 England And Wales United Kingdom | 188590220001 | |||||||||||
BARKER, Steven James | Secrétaire | Rochester Row SW1P 1QT London 17 | 190322750001 | |||||||||||
BIRKETT, Timothy Lloyd | Secrétaire | 17 Padstow Drive Bramhall SK7 2HU Stockport Cheshire | British | Accountant | 99698140001 | |||||||||
COLLINS, Richard Hawke | Secrétaire | Halland Road GL53 0DJ Cheltenham 5 Gloucestershire United Kingdom | 152998560001 | |||||||||||
GLEDHILL, Stephen | Secrétaire | Knighton Drive Four Oaks B74 4QP Sutton Coldfield 18 West Midlands United Kingdom | 174673930001 | |||||||||||
SHEFFIELD, Anne Louise | Secrétaire | Flat 15 The Design Works 93-99 Goswell Road EC1V 7EY London | British | 85634660002 | ||||||||||
BEACH SECRETARIES LIMITED | Secrétaire | 100 Fetter Lane EC4A 1BN London | 76729800001 | |||||||||||
CAPITA GROUP SECRETARY LIMITED | Secrétaire | Rochester Row SW1P 1QT London 17 United Kingdom |
| 135207160001 | ||||||||||
UU SECRETARIAT LIMITED | Secrétaire | Haweswater House, Lingley Mere Business Park Lingley Green Avenue Great Sankey WA5 3LP Warrington | 94063410003 | |||||||||||
ADAMS, Andrea | Administrateur | 9 Beech Drive Whalley BB7 9RA Clitheroe Lancashire | England | British | H R Director | 124716290001 | ||||||||
ADDENBROOKE, Christopher | Administrateur | 65 Gresham Street EC2V 7NQ London 6th Floor United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 88420110011 | ||||||||
BARKER, Steven James | Administrateur | Rochester Row SW1P 1QT London 17 | United Kingdom | British | Director | 190319090001 | ||||||||
BOYLING, Nigel Stephen | Administrateur | 65 Gresham Street EC2V 7NQ London 6th Floor United Kingdom | England | British | Director | 64946040003 | ||||||||
CHARLESWORTH, Edward Mark | Administrateur | 11 Lambridge Place Larkhall BA1 6RU Bath Somerset | British | Director | 77811240002 | |||||||||
CHILD, David Michael | Administrateur | Woodleigh Staplow H28 1MP Ledbury Herefordshire | United Kingdom | British | Managing Director | 112452210001 | ||||||||
CHITTENDEN, Jeffrey George John | Administrateur | 11 Sheldon Square W2 6DQ London Apartment 68 | United Kingdom | British | Operations Manager | 123115670003 | ||||||||
COLEMAN, David | Administrateur | West View Cottage Worthing Road RH13 9BH Southwater West Sussex | British | Financial Services | 123508560001 | |||||||||
COLVIN, Andrew James | Administrateur | 12 Ifield Close RH1 6SW Redhill Surrey | British | Managing Director | 112969670001 | |||||||||
COYLE, Robert Charles | Administrateur | Jessop Avenue GL50 3SH Cheltenham Jessop House Gloucestershire United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 154742870002 | ||||||||
FORSTER, Stephan Dewi | Administrateur | 3 Chambon Close SN16 9QE Minety Wiltshire | British | Director | 121261220001 | |||||||||
GRAHAM, Richard Halton | Administrateur | 307 Sunup Holiday Park Ellicottville 1473196 New York New York 14731-9604 Usa | Canadian | Managing Director | 120665310001 | |||||||||
HOLDEN, Paul Jonathan Ewart | Administrateur | 327 Old Bath Road GL53 9AJ Cheltenham Gloucestershire | England | British | Finance Director | 113673400001 | ||||||||
HUGHES, David | Administrateur | Sawyers Hill, Minety, SN16 9QL Malmesbury, Clavis England And Wales United Kingdom | United Kingdom | British | General Manager | 168119570001 | ||||||||
HUNT, Andrew James | Administrateur | Millswood Old Neighbouring, Chalford GL6 8AA Stroud Gloucestershire | United Kingdom | British | Company Director | 54503850003 | ||||||||
JAMES, Gavin Keith, Mr. | Administrateur | Jessop Avenue GL50 3SH Cheltenham Jessop House Gloucestershire United Kingdom | England | British | Director | 44173560008 | ||||||||
LUCKHOO, Keith Robert Lionel | Administrateur | Old Shalesbrook Lodge Shalesbrook Lane RH18 5LS Forest Row Eastsussex | England | British | Company Director | 28073020002 | ||||||||
PURVEUR, Nigel Jeffrey | Administrateur | Haresfield House GL10 3EQ Stonehouse Gloucester | England | British | Head Of Life & Pensions Outsou | 121395620001 | ||||||||
SHEPHERD, Dale Stanley | Administrateur | 1004 Shenandoah Road IRISH Lexington Virginia 24450 Usa | American | Director | 124135650001 | |||||||||
SMITH, Peter Hugh | Administrateur | 65 Gresham Street EC2V 7NQ London 6th Floor United Kingdom | United Kingdom | British | Director | 193327160001 | ||||||||
STEPHENS, Sally | Administrateur | The Old Barn Cuckoo Corner SN10 4RA Devises Wiltshire | British | Operations Director | 123969210001 | |||||||||
SWEENY, Paul Terence | Administrateur | A Idar Court CT 06830 Greenwich 2 Connecticut Usa | United States | British | Chief Executive Officer | 140303320003 | ||||||||
TEAGUE, Ian Roger | Administrateur | The Cottage Malvern Road GL19 3NT Staunton Gloucestershire | British | Accountant | 98694760001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur JESSOP FUND MANAGERS LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Link Asset Services (Holdings) Limited | 25 sept. 2017 | 10th Floor, 29 Wellington Street LS1 4DL Leeds Central Square England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Capita Mortgage Administration Limited | 06 avr. 2016 | Rochester Row SW1P 1QT London 17 United Kingdom | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
JESSOP FUND MANAGERS LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Confirmatory english law security document | Créé le 08 juin 2012 Livré le 15 juin 2012 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
English law security document | Créé le 31 oct. 2011 Livré le 08 nov. 2011 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
An english law security document | Créé le 27 avr. 2011 Livré le 11 mai 2011 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed equitable charge over all real property, fixed charge on book debts, bank accounts, investments, uncalled capital, and goodwill and floating charge over the undertaking and all assets present and future. See image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0