ETONFIELDS GP LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéETONFIELDS GP LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 05771240
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ETONFIELDS GP LIMITED ?

    • Achat et vente de biens immobiliers propres (68100) / Activités immobilières

    Où se situe ETONFIELDS GP LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Castlegate House
    36 Castle Street
    SG14 1HH Hertford
    Hertfordshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de ETONFIELDS GP LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    ANGLO IRISH PRIVATE EQUITY GP (NO.23) LIMITED05 avr. 200605 avr. 2006

    Quels sont les derniers comptes de ETONFIELDS GP LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2014

    Quels sont les derniers dépôts pour ETONFIELDS GP LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    15 pagesLIQ14

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 04 févr. 2020

    20 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 04 févr. 2019

    21 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 04 févr. 2018

    20 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 04 févr. 2017

    9 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 04 févr. 2016

    9 pages4.68

    Changement d'adresse du siège social de C/O Tyburn Lane Private Equity 43-44 Albemarle Street London W1S 4JJ à Castlegate House 36 Castle Street Hertford Hertfordshire SG14 1HH le 19 févr. 2015

    2 pagesAD01

    Déclaration des affaires avec le formulaire 4.19 attaché

    5 pages4.20

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution extraordinaire pour la liquidation au 05 févr. 2015

    LRESEX

    Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2014

    11 pagesAA

    Nomination d'un administrateur judiciaire ou d'un gérant

    8 pagesRM01

    Nomination d'un administrateur judiciaire ou d'un gérant

    8 pagesRM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 05 avr. 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital09 avr. 2014

    État du capital au 09 avr. 2014

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2013

    11 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 05 avr. 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Cessation de la nomination de Philippa Scobie en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Nomination de Mr Robert Savill en tant que secrétaire

    1 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Philippa Scobie en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2012

    11 pagesAA

    Modification des coordonnées du secrétaire Mrs Philippa Scobie le 10 oct. 2012

    1 pagesCH03

    Déclaration annuelle jusqu'au 05 avr. 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Nomination de Mrs Philippa Scobie en tant que secrétaire

    1 pagesAP03

    Cessation de la nomination de David Morgan en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Qui sont les dirigeants de ETONFIELDS GP LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SAVILL, Robert
    36 Castle Street
    SG14 1HH Hertford
    Castlegate House
    Hertfordshire
    Secrétaire
    36 Castle Street
    SG14 1HH Hertford
    Castlegate House
    Hertfordshire
    176203530001
    DALY, John Francis
    36 Castle Street
    SG14 1HH Hertford
    Castlegate House
    Hertfordshire
    Administrateur
    36 Castle Street
    SG14 1HH Hertford
    Castlegate House
    Hertfordshire
    United KingdomBritish78960760003
    MACALPINE, Findlay Cameron
    76 Blacketts Wood Drive
    WD3 5QQ Chorley Wood
    Hertfordshire
    Administrateur
    76 Blacketts Wood Drive
    WD3 5QQ Chorley Wood
    Hertfordshire
    EnglandBritish61473240003
    NEWSOME, David Francis
    9 Priory Avenue
    Eden Gate
    IRISH Delgany
    Co Wicklow
    Ireland
    Administrateur
    9 Priory Avenue
    Eden Gate
    IRISH Delgany
    Co Wicklow
    Ireland
    IrelandIrish157637920001
    O'HARA, Patrick
    36 Castle Street
    SG14 1HH Hertford
    Castlegate House
    Hertfordshire
    Administrateur
    36 Castle Street
    SG14 1HH Hertford
    Castlegate House
    Hertfordshire
    EnglandIrish82724260003
    PARKER, Gordon
    36 Castle Street
    SG14 1HH Hertford
    Castlegate House
    Hertfordshire
    Administrateur
    36 Castle Street
    SG14 1HH Hertford
    Castlegate House
    Hertfordshire
    EnglandIrish85330570006
    DUNKLEY, Philippa
    Watcombe Cottages
    TW9 3BD Richmond
    15
    Surrey
    United Kingdom
    Secrétaire
    Watcombe Cottages
    TW9 3BD Richmond
    15
    Surrey
    United Kingdom
    Other124641320003
    MORGAN, David Richard
    C/O Tyburn Lane Private Equity
    43-44 Albemarle Street
    W1S 4JJ London
    Secrétaire
    C/O Tyburn Lane Private Equity
    43-44 Albemarle Street
    W1S 4JJ London
    147695530001
    PARKER, Gordon
    Tayles Cottage
    35 West End Street
    KT17 1XD Ewell Village
    Surrey
    Secrétaire
    Tayles Cottage
    35 West End Street
    KT17 1XD Ewell Village
    Surrey
    Irish85330570001
    SCOBIE, Philippa
    C/O Tyburn Lane Private Equity
    43-44 Albemarle Street
    W1S 4JJ London
    Secrétaire
    C/O Tyburn Lane Private Equity
    43-44 Albemarle Street
    W1S 4JJ London
    167237380001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    1 Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    Secrétaire
    1 Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    111451340001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    1 Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    Administrateur
    1 Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    93433510001

    ETONFIELDS GP LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Security assignment
    Créé le 06 déc. 2006
    Livré le 12 déc. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company acting on its own account and as general partner on behalf of anglo fii limited partnership to any of the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed charge its interest in and the benefit of the assigned agreement and the benefit of any guarantee or security for the performance of the assigned agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC for Itself and as Agent for the Beneficiaries
    Transactions
    • 12 déc. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Security assignment
    Créé le 06 déc. 2006
    Livré le 12 déc. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company acting on its own account and as general partner on behalf of anglo fii limited partnership to any of the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed charge its interest in and the benefit of the assigned agreement and the benefit of any guarantee or security for the performance of the assigned agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC for Itself and as Agent for the Beneficiaries
    Transactions
    • 12 déc. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 06 déc. 2006
    Livré le 12 déc. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company acting on its own account and as general partner on behalf of anglo fii limited partnership to any of the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All that f/h property k/a as the belfry business park, colonial way, watford, hertfordshire t/n HD55936 its interest in: all existing and future fittings, plant, equipment, machinery, tools, vehicles, furniture and other tangible movable property at the property. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC for Itself and as Agent for the Beneficiaries
    Transactions
    • 12 déc. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 06 déc. 2006
    Livré le 12 déc. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company acting on its own account and as general partner on behalf of anglo fii limited partnership to any of the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All that f/h property k/a as the belfry business park, colonial way, watford, hertfordshire t/n HD55936 its interest in: all existing and future fittings, plant, equipment, machinery, tools, vehicles, furniture and other tangible movable property at the property. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC for Itself and as Agent for the Beneficiaries
    Transactions
    • 12 déc. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 102 août 2014Nomination d'un administrateur ou d'un gestionnaire (RM01)
      • Numéro de dossier 1
    Security assignment
    Créé le 17 oct. 2006
    Livré le 21 oct. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company, acting as general partner on behalf of anglo fii limited partnership to any of the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed charge its interest in and the benefit of the assigned agreement and the benefit of any guarantee or security for the performance of the assigned agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transactions
    • 21 oct. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Security assignment
    Créé le 17 oct. 2006
    Livré le 21 oct. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to any of the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed charge its interest in and the benefit of the assigned agreement and the benefit of any guarantee or security for the performance of the assigned agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transactions
    • 21 oct. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 29 sept. 2006
    Livré le 05 oct. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company acting as general partner on behalf of anglo fii limited partnership to any of the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H property k/a alpha and beta house parkside court rooley lane bradford t/no WYK711270, f/h property k/a cedar and beech house manor road horsforth leeds t/no WYK607895, f/h property k/a crown house 81/89 great george street and 18 and 18A leighton street leeds t/no WYK561304 for details of further properties charged please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC for Itself and as Agent for the Beneficiaries
    Transactions
    • 05 oct. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 202 août 2014Nomination d'un administrateur ou d'un gestionnaire (RM01)
      • Numéro de dossier 2
    Debenture
    Créé le 29 sept. 2006
    Livré le 05 oct. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to any of the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H property k/a alpha and beta house parkside court rooley lane bradford t/no WYK711270, f/h property k/a cedar and beech house manor road horsforth leeds t/no WYK607895, f/h property k/a crown house 81/89 great george street and 18 and 18A leighton street leeds t/no WYK561304 for details of further properties charged please refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC for Itself and as Agent for the Beneficiaries
    Transactions
    • 05 oct. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 29 sept. 2006
    Livré le 05 oct. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company acting as general partner on behalf of anglo fii limited partnership to any of the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H property k/a leisure site 4 parkway birmingham great park west midlands t/no WM696792, f/h property k/a land on the east side of station road swinton salford greater manchester t/nos GM438354 and GM471358, f/h property k/a land on the north side of bone land newbury t/no BK282065 by way of fixed charge all fittings plant equipment machinery tools vehicles, any investment, any hedging agreement and all receivables. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC for Itself and as Agent for the Beneficiaries
    Transactions
    • 05 oct. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 29 sept. 2006
    Livré le 05 oct. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to any of the beneficiaries under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H property k/a leisure site 4 parkway birmingham great park west midlands t/no WM696792, f/h property k/a land on the east side of station road swinton salford greater manchester t/nos GM438354 and GM471358, f/h property k/a land on the north side of bone land newbury t/no BK282065 by way of fixed charge all fittings plant equipment machinery tools vehicles, any investment, any hedging agreement and all receivables. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC for Itself and as Agent for the Beneficiaries
    Transactions
    • 05 oct. 2006Enregistrement d'une charge (395)

    ETONFIELDS GP LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1Receiver/Manager appointed
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Kevin Peter Mersh
    33 Margaret Street
    W1G 0JD London
    receiver manager
    33 Margaret Street
    W1G 0JD London
    Matthew Richard Nagle
    33 Margaret Street
    W1G 0JD London
    receiver manager
    33 Margaret Street
    W1G 0JD London
    2Receiver/Manager appointed
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Kevin Peter Mersh
    33 Margaret Street
    W1G 0JD London
    receiver manager
    33 Margaret Street
    W1G 0JD London
    Matthew Richard Nagle
    33 Margaret Street
    W1G 0JD London
    receiver manager
    33 Margaret Street
    W1G 0JD London
    3
    DateType
    05 févr. 2015Commencement of winding up
    19 janv. 2021Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Richard William James Long
    Richard Long & Co
    Castlegate House
    SG14 1HH 36 Castle Street
    Hertford
    practitioner
    Richard Long & Co
    Castlegate House
    SG14 1HH 36 Castle Street
    Hertford

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0