JUPITER GREEN INVESTMENT TRUST PLC

JUPITER GREEN INVESTMENT TRUST PLC

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéJUPITER GREEN INVESTMENT TRUST PLC
    Statut de la sociétéLiquidation
    Forme juridiqueSociété anonyme cotée en bourse
    Numéro de société 05780006
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesNon
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de JUPITER GREEN INVESTMENT TRUST PLC ?

    • Activités des sociétés d'investissement mobilier (64301) / Activités financières et d'assurance

    Où se situe JUPITER GREEN INVESTMENT TRUST PLC ?

    Adresse du siège social
    The Zig Zag Building
    70 Victoria Street
    SW1E 6SQ London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de JUPITER GREEN INVESTMENT TRUST PLC ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    JUPITER GREEN CENTURY INVESTMENT TRUST PLC12 avr. 200612 avr. 2006

    Quels sont les derniers comptes de JUPITER GREEN INVESTMENT TRUST PLC ?

    En retardNon
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le31 mars 2025
    Date d'échéance des prochains comptes30 sept. 2025
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2024

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour JUPITER GREEN INVESTMENT TRUST PLC ?

    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au12 avr. 2025
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation26 avr. 2025
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au12 avr. 2024
    En retardNon

    Quels sont les derniers dépôts pour JUPITER GREEN INVESTMENT TRUST PLC ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 14 mars 2025

    LRESSP

    Statuts

    75 pagesMA

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Déclaration de solvabilité

    8 pagesLIQ01

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de modification des droits ou de la dénomination des actions

    RES12
    capital

    Résolution d'autorisation d'achat d'un certain nombre d'actions

    RES09
    capital

    Résolutions

    Re: variation of share rights/option to amend articles further/if scheme becomes unconditional then winding up and appointment of liquidator/liquidators auth. To undertake certain measures 05/03/2025
    RES13
    incorporation

    Résolution de modification des statuts

    RES01

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de suppression des droits de préemption

    RES11
    capital

    Résolutions

    Market purchases of a maximum of 2844469 ordinary shares/notice re general meetings not agm 30/09/2024
    RES13
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10

    Comptes annuels établis au 31 mars 2024

    94 pagesAA

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 7,782.8658
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    22 juil. 2024Clarification HMRC CONFIRMATION DUTY PAID

    Déclaration de confirmation établie le 12 avr. 2024 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 7,661.7598
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    07 mars 2024Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this transaction.

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 7,380.1628
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    20 févr. 2024Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 7,220.8048
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    19 févr. 2024Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase.

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 7,141.6478
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    12 févr. 2024Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 6,789.1158
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    13 nov. 2023Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 6,668.5768
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    02 nov. 2023Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase.

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de suppression des droits de préemption

    RES11
    capital

    Résolution d'autorisation d'achat d'un certain nombre d'actions

    RES09
    capital

    Résolutions

    Continuation vote in accordance with the articles, the directors are required to propose an ordinary resolution at the forthcoming agm (and at every third annual general meeting thereafter) that theresolution at the forthcoming agm (and at every third annual general meeting thereafter) that the company shall continue in being as an investment trust/ general meeting other than an annual general meeting may be called on not less than 14 clear days' notice 14/09/2023
    RES13
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 6,467.2658
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    31 août 2023Clarification HMRC CONFIRMATION DUTY PAID

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 5,993.6988
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    14 août 2023Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this transaction

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 6,298.4008
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    14 août 2023Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this transaction

    Vente ou cession d'actions de trésorerie. Capital de trésorerie:

    • Capital: GBP 5,980.239
    2 pagesSH04

    Comptes annuels établis au 31 mars 2023

    97 pagesAA

    État du capital après une attribution d'actions au 14 avr. 2023

    • Capital: GBP 33,724.958
    3 pagesSH01

    Déclaration de confirmation établie le 12 avr. 2023 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 5,993.878
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    11 avr. 2023Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this transaction

    Rachat d'actions propres. Actions achetées pour le trésor:

    • Capital: GBP 5,042.768
    4 pagesSH03
    Annotations
    DateAnnotation
    03 mars 2023Clarification HMRC confirmation received that appropriate duty has been paid on this repurchase.

    Qui sont les dirigeants de JUPITER GREEN INVESTMENT TRUST PLC ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    JUPITER ASSET MANAGEMENT LIMITED
    70 Victoria Street
    SW1E 6SQ London
    The Zig Zag Building
    United Kingdom
    Secrétaire
    70 Victoria Street
    SW1E 6SQ London
    The Zig Zag Building
    United Kingdom
    46510320002
    BAINS, Jasbir Singh
    70 Victoria Street
    SW1E 6SQ London
    The Zig Zag Building
    Administrateur
    70 Victoria Street
    SW1E 6SQ London
    The Zig Zag Building
    EnglandBritishCommercial Director84212440003
    BAKER, Simon John Donne
    70 Victoria Street
    SW1E 6SQ London
    The Zig Zag Building
    Administrateur
    70 Victoria Street
    SW1E 6SQ London
    The Zig Zag Building
    EnglandEnglishCompany Director79285320002
    NAYLOR, Michael Anthony
    70 Victoria Street
    SW1E 6SQ London
    The Zig Zag Building
    Administrateur
    70 Victoria Street
    SW1E 6SQ London
    The Zig Zag Building
    United KingdomBritishCompany Director61823000006
    WORTHINGTON, Bryony Katherine, Baroness
    Watts Avenue
    ME1 1RX Rochester
    21 Watts Avenue
    England
    Administrateur
    Watts Avenue
    ME1 1RX Rochester
    21 Watts Avenue
    England
    United StatesBritishCompany Director133701550004
    SH COMPANY SECRETARIES LIMITED
    St Paul's Churchyard
    EC4M 8SH London
    One
    Secrétaire
    St Paul's Churchyard
    EC4M 8SH London
    One
    85597290003
    COURTICE, Polly
    70 Victoria Street
    SW1E 6SQ London
    The Zig Zag Building
    Administrateur
    70 Victoria Street
    SW1E 6SQ London
    The Zig Zag Building
    BritishUniversity Professor112534100001
    CROLE, Charles Donald
    1 Grosvenor Place
    London
    SW1X 7JJ
    Administrateur
    1 Grosvenor Place
    London
    SW1X 7JJ
    United KingdomBritishCompany Director108455340003
    CROSTHWAITE, Peregrine Kenneth Oughton
    1 Grosvenor Place
    SW1X 7JJ London
    Jupiter Asset Management Limited
    England
    United Kingdom
    Administrateur
    1 Grosvenor Place
    SW1X 7JJ London
    Jupiter Asset Management Limited
    England
    United Kingdom
    United KingdomBritishCompany Director3249560001
    EDWARDS, Anthony Mark
    10 Balvernie Grove
    SW18 5RU London
    United Kingdom
    Administrateur
    10 Balvernie Grove
    SW18 5RU London
    United Kingdom
    United KingdomBritishSolicitor112160940001
    FERGUSON-YARDE, Marsha Kristin
    50 Ambler Road
    N4 2QU London
    United Kingdom
    Administrateur
    50 Ambler Road
    N4 2QU London
    United Kingdom
    BritishTrainee Solicitor112160930001
    HILLGARTH, Tristan Patrick Alan
    66 Bedford Gardens
    W8 7EH London
    Administrateur
    66 Bedford Gardens
    W8 7EH London
    United KingdomBritishInvestment Director44743540001
    HOARE, Alexander Simon
    Flat 3
    21 Craven Hill
    W2 3EN London
    Administrateur
    Flat 3
    21 Craven Hill
    W2 3EN London
    United KingdomBritishBanker112533970001

    JUPITER GREEN INVESTMENT TRUST PLC a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    14 mars 2025Commencement of winding up
    12 févr. 2025Declaration of solvency sworn on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Steven Sherry
    Pricewaterhousecoopers Llp 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    practitioner
    Pricewaterhousecoopers Llp 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Laura May Waters
    Pricewaterhousecoopers Llp 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    practitioner
    Pricewaterhousecoopers Llp 7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0