ALDWYCK COMPANY (SHEFFORD) LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | ALDWYCK COMPANY (SHEFFORD) LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 05798640 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe ALDWYCK COMPANY (SHEFFORD) LIMITED ?
Adresse du siège social | Ealing Gateway 26-30 Uxbridge Road Ealing W5 2AU London England |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de ALDWYCK COMPANY (SHEFFORD) LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2022 |
Quels sont les derniers dépôts pour ALDWYCK COMPANY (SHEFFORD) LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 1 pages | DS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Sarah Louise Thomas en tant que directeur le 31 mars 2023 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Ms Eleanor Case Hoult en tant qu'administrateur le 01 avr. 2023 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2022 | 2 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Brenda Giles en tant que secrétaire le 01 juin 2022 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Emma Suzanne Maguire en tant que secrétaire le 31 mai 2022 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 05 avr. 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Timothy Michael Jennings en tant que directeur le 01 avr. 2022 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Eamonn Hughes en tant qu'administrateur le 01 avr. 2022 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2021 | 2 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Ian Jeffrey Mcdermott en tant que directeur le 30 sept. 2021 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Sarah Thomas en tant qu'administrateur le 01 oct. 2021 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Emma Suzanne Maguire en tant que secrétaire le 17 juin 2021 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Sophie Atkinson en tant que secrétaire le 17 juin 2021 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 05 avr. 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2020 | 2 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 05 avr. 2020 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 21 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2019 | 6 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Mr Ian Jeffrey Mcdermott en tant qu'administrateur le 01 août 2019 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Ms Sophie Atkinson en tant que secrétaire le 01 mai 2019 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Louisa Loizou en tant que secrétaire le 01 mai 2019 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 6 Houghton Hall Business Park Porz Avenue Houghton Regis Bedfordshire LU5 5UZ à Ealing Gateway 26-30 Uxbridge Road Ealing London W5 2AU le 01 mai 2019 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de ALDWYCK COMPANY (SHEFFORD) LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GILES, Brenda | Secrétaire | 26-30 Uxbridge Road Ealing W5 2AU London Ealing Gateway England | 296967060001 | |||||||
HOULT, Eleanor Case | Administrateur | 26-30 Uxbridge Road Ealing W5 2AU London Ealing Gateway England | England | British | Chief Operating Officer | 272039150001 | ||||
HUGHES, Eamonn | Administrateur | Westminster Bridge Road SE1 7JB London 45 England | United Kingdom | Irish | Chief Financial Officer | 266799290001 | ||||
ATKINSON, Sophie | Secrétaire | 26-30 Uxbridge Road Ealing W5 2AU London Ealing Gateway England | 260083010001 | |||||||
CHIMANYA, Terrence | Secrétaire | 6 Houghton Hall Business Park Porz Avenue LU5 5UZ Houghton Regis Bedfordshire | 151741200001 | |||||||
EVANS-EVANS, Simon James Piers, Mr. | Secrétaire | 48 Wingate Drive MK45 2XF Ampthill Bedfordshire | British | Director | 101591020001 | |||||
JEFFERY, Peter | Secrétaire | 6 Houghton Hall Business Park Porz Avenue LU5 5UZ Houghton Regis Bedfordshire | 166712940001 | |||||||
LOIZOU, Louisa | Secrétaire | 26-30 Uxbridge Road Ealing W5 2AU London Ealing Gateway England | 253164310001 | |||||||
MAGUIRE, Emma Suzanne | Secrétaire | 26-30 Uxbridge Road Ealing W5 2AU London Ealing Gateway England | 284606170001 | |||||||
MARKE, Vincent | Secrétaire | 6 Houghton Hall Business Park Porz Avenue LU5 5UZ Houghton Regis Bedfordshire | 177784570001 | |||||||
ROSSER, Stephen Lloyd | Secrétaire | 6 Houghton Hall Business Park Porz Avenue LU5 5UZ Houghton Regis Bedfordshire | 186562040001 | |||||||
SINGH, Harjinder | Secrétaire | 6 Houghton Hall Business Park Porz Avenue LU5 5UZ Houghton Regis Bedfordshire | 149276010001 | |||||||
WATERLOW SECRETARIES LIMITED | Secrétaire désigné | 6-8 Underwood Street N1 7JQ London | 900003950001 | |||||||
BILLINGHAM, Patricia Marusia | Administrateur | 6 Houghton Hall Business Park Porz Avenue LU5 5UZ Houghton Regis Bedfordshire | England | British | Non Executive Director | 194659850001 | ||||
BROOMFIELD, Richard Ernest | Administrateur | 6 Houghton Hall Business Park Porz Avenue LU5 5UZ Houghton Regis Bedfordshire | England | British | Director | 86745100001 | ||||
COOK, Joseph | Administrateur | 6 Houghton Hall Business Park Porz Avenue LU5 5UZ Houghton Regis Bedfordshire | England | British | Quantity Surveyor | 178867790001 | ||||
CROWTHER, John Russell | Administrateur | Wrights Farm House Longstowe CB3 7UN Cambridge | England | British | Director | 50009800001 | ||||
EDWARDS, Keith | Administrateur | 1 Lammas Way MK45 2TR Ampthill Bedfordshire | British | Director | 113207260001 | |||||
EVANS-EVANS, Simon James Piers, Mr. | Administrateur | 48 Wingate Drive MK45 2XF Ampthill Bedfordshire | United Kingdom | British | Director | 101591020001 | ||||
HADDEN, Neil John | Administrateur | 21 Talbot Street SG5 2QU Hitchin Hertfordshire | England | British | Chief Executive | 107508200001 | ||||
JENNINGS, Timothy Michael | Administrateur | 26-30 Uxbridge Road Ealing W5 2AU London Ealing Gateway England | England | British | Finance Director | 212239000001 | ||||
LAVERS, Howard | Administrateur | 40 High Street MK44 3EB Roxton Linden House Bedfordshire | United Kingdom | British | Director | 50282970003 | ||||
MARKE, Vincent Stuckey | Administrateur | 6 Houghton Hall Business Park Porz Avenue LU5 5UZ Houghton Regis Bedfordshire | England | British | Acting Chief Executive | 187708590001 | ||||
MCDERMOTT, Ian Jeffrey | Administrateur | 26-30 Uxbridge Road Ealing W5 2AU London Ealing Gateway England | England | British | Director | 101774900001 | ||||
MCDERMOTT, Ian Jeffrey | Administrateur | 6 Houghton Hall Business Park Porz Avenue LU5 5UZ Houghton Regis Bedfordshire | England | British | Company Director | 101774900001 | ||||
RICHARDS, Paul David | Administrateur | Garfield SG18 9NG Langford 3 Beds | England | British | Director | 102709940004 | ||||
SINGH, Harjinder | Administrateur | Reddings Road B13 8LR Birmingham 73 England | England | British | Chief Executive | 122561300003 | ||||
THOMAS, Sarah Louise | Administrateur | 26-30 Uxbridge Road Ealing W5 2AU London Ealing Gateway England | United Kingdom | British | Director | 261347510001 | ||||
WILLIAMS, Tracy | Administrateur | 103 Pennycress Way MK16 8SN Newport Pagnell Buckinghamshire | British | Executive Director | 121022630001 | |||||
WILSON, Simon Philip | Administrateur | 6 Houghton Hall Business Park Porz Avenue LU5 5UZ Houghton Regis Bedfordshire | England | British | Non Executive Director | 98511670001 | ||||
WATERLOW NOMINEES LIMITED | Administrateur désigné | 6-8 Underwood Street N1 7JQ London | 900003940001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur ALDWYCK COMPANY (SHEFFORD) LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lea Valley Developments Limited | 06 avr. 2016 | Houghton Hall Park Houghton Regis LU5 5UZ Dunstable 6 England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
ALDWYCK COMPANY (SHEFFORD) LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Créé le 12 mars 2014 Livré le 20 mars 2014 | En cours | ||
Brève description Notification of addition to or amendment of charge. Contient une charge flottante: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0