LONDON & NEWCASTLE CAPITAL LIMITED

LONDON & NEWCASTLE CAPITAL LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Déclaration de confirmation
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéLONDON & NEWCASTLE CAPITAL LIMITED
    Statut de la sociétéLiquidation
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 05808612
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de LONDON & NEWCASTLE CAPITAL LIMITED ?

    • Développement de projets de construction (41100) / Construction
    • Achat et vente de biens immobiliers propres (68100) / Activités immobilières
    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe LONDON & NEWCASTLE CAPITAL LIMITED ?

    Adresse du siège social
    C/O Begbies Traynor
    40 Bank Street
    E14 5NR London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de LONDON & NEWCASTLE CAPITAL LIMITED ?

    En retardOui
    Prochains comptes
    Fin de la prochaine période comptable le30 déc. 2023
    Date d'échéance des prochains comptes30 sept. 2024
    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2022

    Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour LONDON & NEWCASTLE CAPITAL LIMITED ?

    En retardOui
    Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au24 avr. 2024
    Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation08 mai 2024
    Dernière déclaration de confirmation
    Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au24 avr. 2023
    En retardOui

    Quels sont les derniers dépôts pour LONDON & NEWCASTLE CAPITAL LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 02 juil. 2025

    24 pagesLIQ03

    Déclaration des affaires

    9 pagesLIQ02

    Changement d'adresse du siège social de Aston House Cornwall Avenue London N3 1LF England à C/O Begbies Traynor 40 Bank Street London E14 5NR le 08 juil. 2024

    3 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution extraordinaire pour la liquidation au 03 juil. 2024

    LRESEX

    Changement d'adresse du siège social de Aston House Cornwall Avenue London N3 1LF England à Aston House Cornwall Avenue London N3 1LF le 29 janv. 2024

    1 pagesAD01

    Changement d'adresse du siège social de 91 Wimpole Street London W1G 0EF England à Aston House Cornwall Avenue London N3 1LF le 29 janv. 2024

    1 pagesAD01

    Satisfaction de la charge 058086120010 en totalité

    1 pagesMR04

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2022

    8 pagesAA

    Cessation de la nomination de Christopher Robin Leslie Phillips en tant que directeur le 24 nov. 2023

    1 pagesTM01

    La procédure de radiation d'office a été abandonnée

    1 pagesDISS40

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office

    1 pagesGAZ1

    Déclaration de confirmation établie le 24 avr. 2023 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Cessation de la nomination de James Michael Shindler en tant que directeur le 20 mars 2023

    1 pagesTM01

    Changement d'adresse du siège social de 55 Loudoun Road St John's Wood London NW8 0DL à 91 Wimpole Street London W1G 0EF le 15 janv. 2023

    1 pagesAD01

    Période comptable précédente raccourcie du 31 déc. 2021 au 30 déc. 2021

    1 pagesAA01

    Déclaration de confirmation établie le 24 avr. 2022 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2020

    12 pagesAA

    Inscription de la charge 058086120012, créée le 20 mai 2022

    28 pagesMR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Robert Daniel Soning le 02 juil. 2021

    2 pagesCH01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2019

    13 pagesAA

    Inscription de la charge 058086120011, créée le 28 mai 2021

    29 pagesMR01

    Déclaration de confirmation établie le 24 avr. 2021 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Kandasamy Vijaishankar en tant que directeur le 25 avr. 2021

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Baerbel Schuett en tant que directeur le 31 mai 2020

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de LONDON & NEWCASTLE CAPITAL LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BARNETT, David Melvyn
    40 Bank Street
    E14 5NR London
    C/O Begbies Traynor
    Administrateur
    40 Bank Street
    E14 5NR London
    C/O Begbies Traynor
    United KingdomBritish39132210004
    SONING, Robert Daniel
    40 Bank Street
    E14 5NR London
    C/O Begbies Traynor
    Administrateur
    40 Bank Street
    E14 5NR London
    C/O Begbies Traynor
    EnglandBritish33156140034
    BARNETT, Timothy Edward
    Eastcastle Street
    W1W 8DH London
    27-28
    Secrétaire
    Eastcastle Street
    W1W 8DH London
    27-28
    British150400890001
    BOUSABA, Marie-Anne
    Loudoun Road
    St John's Wood
    NW8 0DL London
    55
    Secrétaire
    Loudoun Road
    St John's Wood
    NW8 0DL London
    55
    245754630001
    CARGIL MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    Melton Street
    NW1 2BW London
    22
    Secrétaire
    Melton Street
    NW1 2BW London
    22
    129435210001
    E L SERVICES LIMITED
    25 Harley Street
    W1G 9BR London
    Secrétaire
    25 Harley Street
    W1G 9BR London
    78638580003
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    ALLEN, Peter John
    Loudoun Road
    St John's Wood
    NW8 0DL London
    55
    United Kingdom
    Administrateur
    Loudoun Road
    St John's Wood
    NW8 0DL London
    55
    United Kingdom
    United KingdomBritish188188380001
    BARNETT, Timothy Edward
    Eastcastle Street
    W1W 8DH London
    27-28
    Administrateur
    Eastcastle Street
    W1W 8DH London
    27-28
    EnglandBritish157663990001
    BERG, Simon Mark
    12 Adelaide Close
    HA7 3EL Stanmore
    Middlesex
    Administrateur
    12 Adelaide Close
    HA7 3EL Stanmore
    Middlesex
    EnglandBritish66989000001
    BURROW, Robert Philip
    10 Queen Street Place
    EC4R 1BE London
    Administrateur
    10 Queen Street Place
    EC4R 1BE London
    EnglandBritish97252420005
    FRANKHAM, Vivienne
    Mortimer Street
    W1W 7SQ London
    73/75
    United Kingdom
    Administrateur
    Mortimer Street
    W1W 7SQ London
    73/75
    United Kingdom
    United KingdomBritish150385630001
    GATELEY, Donald Kenneth
    18 Clayhills Grove
    EH14 7NE Balerno
    Midlothian
    Administrateur
    18 Clayhills Grove
    EH14 7NE Balerno
    Midlothian
    United KingdomBritish104442220001
    HENRIKSEN, Troels Bugge
    Bagley Cottage
    Spring Copse
    OX1 5BJ Oxford
    Oxfordshire
    Administrateur
    Bagley Cottage
    Spring Copse
    OX1 5BJ Oxford
    Oxfordshire
    EnglandBritish44984800004
    HEPBURN, Alastair John Harley
    42 Hill Park Avenue
    EH4 7AH Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    42 Hill Park Avenue
    EH4 7AH Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish114477450001
    MCFADZEAN, Duncan Alistair Henry
    49 Balgreen Road
    EH12 5TY Edinburgh
    Midlothian
    Administrateur
    49 Balgreen Road
    EH12 5TY Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish115963740001
    MEGGESON, Julian David
    The Malt Cottage
    School Lane Cookham
    SL6 9QN Maidenhead
    Berkshire
    Administrateur
    The Malt Cottage
    School Lane Cookham
    SL6 9QN Maidenhead
    Berkshire
    British114481380001
    PHILLIPS, Christopher Robin Leslie
    Wimpole Street
    W1G 0EF London
    91
    England
    Administrateur
    Wimpole Street
    W1G 0EF London
    91
    England
    EnglandBritish46176700002
    SCHUETT, Baerbel
    Loudoun Road
    St John's Wood
    NW8 0DL London
    55
    United Kingdom
    Administrateur
    Loudoun Road
    St John's Wood
    NW8 0DL London
    55
    United Kingdom
    EnglandGerman150389260002
    SHINDLER, James Michael
    Wimpole Street
    W1G 0EF London
    91
    England
    Administrateur
    Wimpole Street
    W1G 0EF London
    91
    England
    United KingdomBritish135533150002
    VIJAISHANKAR, Kandasamy
    Loudoun Road
    St John's Wood
    NW8 0DL London
    55
    Administrateur
    Loudoun Road
    St John's Wood
    NW8 0DL London
    55
    United KingdomBritish150552890002
    WOLFRYD, Oliver
    Mortimer Street
    W1W 7SQ London
    73/75
    United Kingdom
    Administrateur
    Mortimer Street
    W1W 7SQ London
    73/75
    United Kingdom
    United KingdomBritish115187090001
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Administrateur désigné
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur LONDON & NEWCASTLE CAPITAL LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Loudoun Road
    St John's Wood
    NW8 0DL London
    55
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Loudoun Road
    St John's Wood
    NW8 0DL London
    55
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleUnited Kingdom (England And Wales)
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement07172291
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    LONDON & NEWCASTLE CAPITAL LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 20 mai 2022
    Livré le 24 mai 2022
    En cours
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Natwest Markets PLC
    Transactions
    • 24 mai 2022Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 28 mai 2021
    Livré le 07 juin 2021
    En cours
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Natwest Markets PLC
    Transactions
    • 07 juin 2021Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 22 mars 2019
    Livré le 04 avr. 2019
    Totalement satisfaite
    Brève description
    No specific land, ship, aircraft or intellectual property has been charged. For full details of the charges, please refer to the charging document directly.
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Beaufort Ventures Ii (Jersey) Limited
    Transactions
    • 04 avr. 2019Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 15 déc. 2023Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 14 août 2017
    Livré le 18 août 2017
    En cours
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Places for People Ventures Operations Limited
    Transactions
    • 18 août 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 04 mars 2015
    Livré le 11 mars 2015
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Ltg International Limited
    Transactions
    • 11 mars 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 15 mai 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 21 août 2013
    Livré le 24 août 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Notification of addition to or amendment of charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Ltg International Limited
    Transactions
    • 24 août 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 15 mai 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 06 juil. 2011
    Livré le 07 juil. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and each other borrower party to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Ltg International Limited
    Transactions
    • 07 juil. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 15 mai 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Secured deposit deed
    Créé le 12 nov. 2010
    Livré le 17 nov. 2010
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The credit balance which includes the initial deposit. Initial deposit means the sum of £36,000 see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Derwent Valley Central Limited
    Transactions
    • 17 nov. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    Debenture
    Créé le 29 mars 2010
    Livré le 03 avr. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due of each present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, all computers, plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Secured Finance Parties( the Security Agent)
    Transactions
    • 03 avr. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 08 juil. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 23 juin 2009
    Livré le 26 juin 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 26 juin 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 juil. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Insurance assignment
    Créé le 03 oct. 2006
    Livré le 13 oct. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other secured finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The policies being: insurer; halifax life, dated 22 august 2006, number ASSH048239, life assured david melvyn barnett, insurer; halifax life dated 12 july 2006, numbered ASSH048242 life assured robert daniel soning, insurer; halifax life dated 13 july 2006, numbered ASSH048238, life assured simon mark berg,. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for the Secured Financeparties (Security Agent)
    Transactions
    • 13 oct. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 juil. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Group debenture
    Créé le 19 juin 2006
    Livré le 04 juil. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the group to the security agent and/or the other secured finance parties (or any of them) on any account whatsoevere under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Security Trustee for the Secured Financeparties)
    Transactions
    • 04 juil. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 juil. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    LONDON & NEWCASTLE CAPITAL LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    03 juil. 2024Commencement of winding up
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Paul Robert Appleton
    31st Floor 40 Bank Street
    E14 5NR London
    practitioner
    31st Floor 40 Bank Street
    E14 5NR London
    Melissa Nagi
    31st Floor Forty Bank Street
    E14 5NR London
    practitioner
    31st Floor Forty Bank Street
    E14 5NR London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0