LONDON & NEWCASTLE CAPITAL LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | LONDON & NEWCASTLE CAPITAL LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Liquidation |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 05808612 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Oui |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe LONDON & NEWCASTLE CAPITAL LIMITED ?
| Adresse du siège social | C/O Begbies Traynor 40 Bank Street E14 5NR London |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de LONDON & NEWCASTLE CAPITAL LIMITED ?
| En retard | Oui |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 30 déc. 2023 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 30 sept. 2024 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2022 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour LONDON & NEWCASTLE CAPITAL LIMITED ?
| En retard | Oui |
|---|---|
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 24 avr. 2024 |
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 08 mai 2024 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 24 avr. 2023 |
| En retard | Oui |
Quels sont les derniers dépôts pour LONDON & NEWCASTLE CAPITAL LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 02 juil. 2025 | 24 pages | LIQ03 | ||||||||||
Déclaration des affaires | 9 pages | LIQ02 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Aston House Cornwall Avenue London N3 1LF England à C/O Begbies Traynor 40 Bank Street London E14 5NR le 08 juil. 2024 | 3 pages | AD01 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 3 pages | 600 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Aston House Cornwall Avenue London N3 1LF England à Aston House Cornwall Avenue London N3 1LF le 29 janv. 2024 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 91 Wimpole Street London W1G 0EF England à Aston House Cornwall Avenue London N3 1LF le 29 janv. 2024 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 058086120010 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2022 | 8 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Christopher Robin Leslie Phillips en tant que directeur le 24 nov. 2023 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
La procédure de radiation d'office a été abandonnée | 1 pages | DISS40 | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office | 1 pages | GAZ1 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 24 avr. 2023 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de James Michael Shindler en tant que directeur le 20 mars 2023 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 55 Loudoun Road St John's Wood London NW8 0DL à 91 Wimpole Street London W1G 0EF le 15 janv. 2023 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Période comptable précédente raccourcie du 31 déc. 2021 au 30 déc. 2021 | 1 pages | AA01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 24 avr. 2022 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2020 | 12 pages | AA | ||||||||||
Inscription de la charge 058086120012, créée le 20 mai 2022 | 28 pages | MR01 | ||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Robert Daniel Soning le 02 juil. 2021 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2019 | 13 pages | AA | ||||||||||
Inscription de la charge 058086120011, créée le 28 mai 2021 | 29 pages | MR01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 24 avr. 2021 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Kandasamy Vijaishankar en tant que directeur le 25 avr. 2021 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Baerbel Schuett en tant que directeur le 31 mai 2020 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de LONDON & NEWCASTLE CAPITAL LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BARNETT, David Melvyn | Administrateur | 40 Bank Street E14 5NR London C/O Begbies Traynor | United Kingdom | British | 39132210004 | |||||
| SONING, Robert Daniel | Administrateur | 40 Bank Street E14 5NR London C/O Begbies Traynor | England | British | 33156140034 | |||||
| BARNETT, Timothy Edward | Secrétaire | Eastcastle Street W1W 8DH London 27-28 | British | 150400890001 | ||||||
| BOUSABA, Marie-Anne | Secrétaire | Loudoun Road St John's Wood NW8 0DL London 55 | 245754630001 | |||||||
| CARGIL MANAGEMENT SERVICES LIMITED | Secrétaire | Melton Street NW1 2BW London 22 | 129435210001 | |||||||
| E L SERVICES LIMITED | Secrétaire | 25 Harley Street W1G 9BR London | 78638580003 | |||||||
| SWIFT INCORPORATIONS LIMITED | Secrétaire désigné | Church Street NW8 8EP London 26 | 900008300001 | |||||||
| ALLEN, Peter John | Administrateur | Loudoun Road St John's Wood NW8 0DL London 55 United Kingdom | United Kingdom | British | 188188380001 | |||||
| BARNETT, Timothy Edward | Administrateur | Eastcastle Street W1W 8DH London 27-28 | England | British | 157663990001 | |||||
| BERG, Simon Mark | Administrateur | 12 Adelaide Close HA7 3EL Stanmore Middlesex | England | British | 66989000001 | |||||
| BURROW, Robert Philip | Administrateur | 10 Queen Street Place EC4R 1BE London | England | British | 97252420005 | |||||
| FRANKHAM, Vivienne | Administrateur | Mortimer Street W1W 7SQ London 73/75 United Kingdom | United Kingdom | British | 150385630001 | |||||
| GATELEY, Donald Kenneth | Administrateur | 18 Clayhills Grove EH14 7NE Balerno Midlothian | United Kingdom | British | 104442220001 | |||||
| HENRIKSEN, Troels Bugge | Administrateur | Bagley Cottage Spring Copse OX1 5BJ Oxford Oxfordshire | England | British | 44984800004 | |||||
| HEPBURN, Alastair John Harley | Administrateur | 42 Hill Park Avenue EH4 7AH Edinburgh Midlothian | Scotland | British | 114477450001 | |||||
| MCFADZEAN, Duncan Alistair Henry | Administrateur | 49 Balgreen Road EH12 5TY Edinburgh Midlothian | Scotland | British | 115963740001 | |||||
| MEGGESON, Julian David | Administrateur | The Malt Cottage School Lane Cookham SL6 9QN Maidenhead Berkshire | British | 114481380001 | ||||||
| PHILLIPS, Christopher Robin Leslie | Administrateur | Wimpole Street W1G 0EF London 91 England | England | British | 46176700002 | |||||
| SCHUETT, Baerbel | Administrateur | Loudoun Road St John's Wood NW8 0DL London 55 United Kingdom | England | German | 150389260002 | |||||
| SHINDLER, James Michael | Administrateur | Wimpole Street W1G 0EF London 91 England | United Kingdom | British | 135533150002 | |||||
| VIJAISHANKAR, Kandasamy | Administrateur | Loudoun Road St John's Wood NW8 0DL London 55 | United Kingdom | British | 150552890002 | |||||
| WOLFRYD, Oliver | Administrateur | Mortimer Street W1W 7SQ London 73/75 United Kingdom | United Kingdom | British | 115187090001 | |||||
| INSTANT COMPANIES LIMITED | Administrateur désigné | Mitchell Lane BS1 6BU Bristol 1 Avon | 900008290001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur LONDON & NEWCASTLE CAPITAL LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London & Newcastle 2010 Limited | 06 avr. 2016 | Loudoun Road St John's Wood NW8 0DL London 55 United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
LONDON & NEWCASTLE CAPITAL LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Créé le 20 mai 2022 Livré le 24 mai 2022 | En cours | ||
Contient une promesse négative: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A registered charge | Créé le 28 mai 2021 Livré le 07 juin 2021 | En cours | ||
Contient une promesse négative: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A registered charge | Créé le 22 mars 2019 Livré le 04 avr. 2019 | Totalement satisfaite | ||
Brève description No specific land, ship, aircraft or intellectual property has been charged. For full details of the charges, please refer to the charging document directly. Contient une promesse négative: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A registered charge | Créé le 14 août 2017 Livré le 18 août 2017 | En cours | ||
Contient une promesse négative: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A registered charge | Créé le 04 mars 2015 Livré le 11 mars 2015 | Totalement satisfaite | ||
La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A registered charge | Créé le 21 août 2013 Livré le 24 août 2013 | Totalement satisfaite | ||
Brève description Notification of addition to or amendment of charge. La charge flottante couvre tout: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 06 juil. 2011 Livré le 07 juil. 2011 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and each other borrower party to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Secured deposit deed | Créé le 12 nov. 2010 Livré le 17 nov. 2010 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions The credit balance which includes the initial deposit. Initial deposit means the sum of £36,000 see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 29 mars 2010 Livré le 03 avr. 2010 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due of each present or future member of the group to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, all computers, plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 23 juin 2009 Livré le 26 juin 2009 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Insurance assignment | Créé le 03 oct. 2006 Livré le 13 oct. 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from each present or future member of the group to the chargee and/or the other secured finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions The policies being: insurer; halifax life, dated 22 august 2006, number ASSH048239, life assured david melvyn barnett, insurer; halifax life dated 12 july 2006, numbered ASSH048242 life assured robert daniel soning, insurer; halifax life dated 13 july 2006, numbered ASSH048238, life assured simon mark berg,. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Group debenture | Créé le 19 juin 2006 Livré le 04 juil. 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the group to the security agent and/or the other secured finance parties (or any of them) on any account whatsoevere under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
LONDON & NEWCASTLE CAPITAL LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
| Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Creditors voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0