GLOBAL RENEWABLES LANCASHIRE HOLDINGS NUMBER TWO LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | GLOBAL RENEWABLES LANCASHIRE HOLDINGS NUMBER TWO LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 05829649 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe GLOBAL RENEWABLES LANCASHIRE HOLDINGS NUMBER TWO LIMITED ?
| Adresse du siège social | 20 Triton Street NW1 3BF London England |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de GLOBAL RENEWABLES LANCASHIRE HOLDINGS NUMBER TWO LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2016 |
Quels sont les derniers dépôts pour GLOBAL RENEWABLES LANCASHIRE HOLDINGS NUMBER TWO LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Nicola Mary Johnson en tant que directeur le 23 mars 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Période comptable actuelle prolongée du 31 mars 2017 au 30 sept. 2017 | 1 pages | AA01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 26 mai 2017 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2016 | 1 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Jennifer Grace Draper en tant que secrétaire le 06 janv. 2017 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Nomination de Ms Nicola Mary Johnson en tant qu'administrateur le 29 déc. 2016 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 26 mai 2016 avec liste complète des actionnaires | 3 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomination de Ms Jennifer Grace Draper en tant que secrétaire le 08 juin 2016 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Lend Lease, Adamson House Towers Business Park Wilmslow Road Manchester M20 2YY England à 20 Triton Street London NW1 3BF le 13 juin 2016 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 mars 2015 | 15 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Ailison Louise Mitchell en tant que secrétaire le 19 janv. 2016 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 3rd Floor, the Venus 1 Old Park Lane Trafford Manchester M41 7HG à Lend Lease, Adamson House Towers Business Park Wilmslow Road Manchester M20 2YY le 06 oct. 2015 | 1 pages | AD01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 mars 2014 | 15 pages | AA | ||||||||||
La procédure de radiation d'office a été abandonnée | 1 pages | DISS40 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 26 mai 2015 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation d'office | 1 pages | GAZ1 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Michael William O'farrell en tant que directeur le 06 nov. 2014 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de James Richard Tremaine en tant que directeur le 06 nov. 2014 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Steven Paul Fraser en tant qu'administrateur le 06 nov. 2014 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 2 en totalité | 4 pages | MR04 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 26 mai 2014 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomination de Mr James Richard Tremaine en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de GLOBAL RENEWABLES LANCASHIRE HOLDINGS NUMBER TWO LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRASER, Steven Paul | Administrateur | Triton Street NW1 3BF London 20 England | England | British | 175869500001 | |||||
| PRIOR, Steven Marc | Administrateur | Triton Street NW1 3BF London 20 England | England | British | 142912290001 | |||||
| DRAPER, Jennifer Grace | Secrétaire | Triton Street NW1 3BF London 20 England | 209258800001 | |||||||
| FOY, Simon John | Secrétaire | 5 Lindisfarne Close Brooklands M33 3RB Sale Cheshire | British | 114274460001 | ||||||
| MITCHELL, Ailison Louise | Secrétaire | Towers Business Park Wilmslow Road M20 2YY Manchester Lend Lease, Adamson House England | British | 53150080001 | ||||||
| A G SECRETARIAL LIMITED | Secrétaire | 100 Barbirolli Square M2 3AB Manchester | 90084920001 | |||||||
| ANDERSON, Thomas Downs | Administrateur | 157 Percheron Drive The Mount GU21 2QX Knaphill Surrey | United Kingdom | British | 54976140002 | |||||
| ANDERSON, Thomas Downs | Administrateur | 157 Percheron Drive The Mount GU21 2QX Knaphill Surrey | United Kingdom | British | 54976140002 | |||||
| CHAMBERLAIN, Janet Patricia | Administrateur | Floor, The Venus 1 Old Park Lane Trafford M41 7HG Manchester 3rd | United Kingdom | British | 51278380001 | |||||
| COUZENS, Michael William | Administrateur | Roseberry Close B10 9FQ Ramsbottom 14 Uk | United Kingdom | British | 152537080001 | |||||
| EATOUGH, Peter Richard | Administrateur | 212 Myton Road CV34 6PS Warwick Warwickshire | United Kingdom | British | 105395140001 | |||||
| FRASER, Steven Paul | Administrateur | Floor, The Venus 1 Old Park Lane Trafford M41 7HG Manchester 3rd | England | British | 175869500001 | |||||
| HOCKADAY, Stephen | Administrateur | 33a Arterberry Road SW20 8AG London | England | British | 101894100001 | |||||
| JOHNSON, Nicola Mary | Administrateur | Triton Street NW1 3BF London 20 England | United Kingdom | Australian | 164399850003 | |||||
| KILGOUR, David John | Administrateur | Floor, The Venus 1 Old Park Lane Trafford M41 7HG Manchester 3rd | England | British | 195386090001 | |||||
| LAWRENSON, Mark Clifford | Administrateur | 17 Louise Sreet FOREIGN Nedlands 6009 Western Australia Australia | Australian | 118854460001 | ||||||
| MARTIN, Neil Christopher | Administrateur | Floor, The Venus 1 Old Park Lane Trafford M41 7HG Manchester 3rd | United Kingdom | British | 157057180001 | |||||
| O'FARRELL, Michael William | Administrateur | Floor, The Venus 1 Old Park Lane Trafford M41 7HG Manchester 3rd | England | British | 77541360001 | |||||
| POINTON, Christopher Richard | Administrateur | Holmwood Farm Greendown BA3 4NZ Chewton Mendip Somerset | United Kingdom | British | 142335020001 | |||||
| SINGH, Naveen David | Administrateur | 902 Imperial Point The Qu Ays M50 3RB Salford Lancashire | Australian | 118854400001 | ||||||
| TAYLOR, Gary Douglas | Administrateur | 44 Barham Road SW20 0ET London | United Kingdom | Australian | 124867200001 | |||||
| TREMAINE, James Richard | Administrateur | Floor, The Venus 1 Old Park Lane Trafford M41 7HG Manchester 3rd | England | British | 186213810001 | |||||
| WATSON, Bevan William | Administrateur | 5 Maddox Street Mayfair W1S 1QD London | United Kingdom | American | 127858860001 | |||||
| WRIGHT, Stephen John | Administrateur | Floor, The Venus 1 Old Park Lane Trafford M41 7HG Manchester 3rd | United Kingdom | British | 52357260002 | |||||
| INHOCO FORMATIONS LIMITED | Administrateur désigné | 100 Barbirolli Square M2 3AB Manchester | 900006560001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur GLOBAL RENEWABLES LANCASHIRE HOLDINGS NUMBER TWO LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Global Renewables Lancashire Holdings Limited | 06 avr. 2016 | Triton Street NW1 3BF London 20 England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
GLOBAL RENEWABLES LANCASHIRE HOLDINGS NUMBER TWO LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Créé le 02 mars 2007 Livré le 12 mars 2007 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 02 mars 2007 Livré le 13 mars 2007 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions All rights title benefit and interest in to and under the assigned documents the document claims and any guarantees warranties licences and/or other agreements, all right title benefit and interest in any account and all receivables book an. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0