EVOLVE ENERGY LTD
Vue d'ensemble
| Nom de la société | EVOLVE ENERGY LTD |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 05831752 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe EVOLVE ENERGY LTD ?
| Adresse du siège social | Ocean Court Caspian Road, Atlantic Street Broadheath WA14 5HH Altrincham Cheshire |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de EVOLVE ENERGY LTD ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2018 |
Quels sont les derniers dépôts pour EVOLVE ENERGY LTD ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Nomination de Nathan Sanders en tant qu'administrateur le 03 mai 2019 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Peter Bradley en tant qu'administrateur le 12 avr. 2019 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Aled Robert Humphreys en tant que directeur le 12 avr. 2019 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 01 févr. 2019 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2018 | 8 pages | AA | ||||||||||
Nomination de Brian Dominic Sharma en tant que secrétaire le 18 sept. 2018 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Archie Stuart Waddell en tant que secrétaire le 18 sept. 2018 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 01 févr. 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2017 | 8 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Brian Dominic Sharma en tant que secrétaire le 05 juil. 2017 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Nomination de Archie Stuart Waddell en tant que secrétaire le 05 juil. 2017 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 01 févr. 2017 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 mars 2016 | 8 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de James Mcphillimy en tant que directeur le 31 oct. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Brian Dominic Sharma en tant que secrétaire le 11 mai 2016 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Veronica Mary Niven en tant que secrétaire le 11 mai 2016 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 01 mars 2016 avec liste complète des actionnaires | 7 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 31 mars 2015 | 7 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Richard Brinsley Sheridan en tant que directeur le 15 oct. 2015 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Aled Robert Humphreys en tant qu'administrateur le 12 août 2015 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 21 mars 2015 avec liste complète des actionnaires | 7 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Deuxième dépôt de AR01 précédemment soumis à Companies House mis à jour jusqu'au 21 mars 2014 | 16 pages | RP04 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de EVOLVE ENERGY LTD ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHARMA, Brian Dominic | Secrétaire | 43 Forbury Road RG1 3JH Reading No.1 Forbury Place United Kingdom | 250773850001 | |||||||
| BRADLEY, Peter | Administrateur | Ocean Court Caspian Road, Atlantic Street WA14 5HH Altrincham Sse Enterprise Energy Solutions Cheshire United Kingdom | United Kingdom | British | 75211210001 | |||||
| GREENHORN, Kevin David Andrew | Administrateur | 200 Dunkeld Road PH1 3GH Perth Grampian House Scotland | Scotland | British | 145709970001 | |||||
| SANDERS, Nathan | Administrateur | 43 Forbury Road RG1 3JH Reading No.1 Forbury Place United Kingdom | England | British | 150936520002 | |||||
| BUDD, Gerald Lance | Secrétaire | Manston Road GU4 7YE Guildford 4 Surrey | British | 20717760001 | ||||||
| LOCHERY, Anthony Francis | Secrétaire | Caspian Road, Atlantic Street Broadheath WA14 5HH Altrincham Ocean Court Cheshire United Kingdom | 170751860001 | |||||||
| NIVEN, Veronica Mary | Secrétaire | Caspian Road Atlantic Street WA14 5HH Altrincham Ocean Court United Kingdom | 190141550001 | |||||||
| PARKE, Gary | Secrétaire | Marchwood The Crescent Lower Shiplake RG9 3LL Henley On Thames Oxfordshire | British | 118299620001 | ||||||
| SCHNEIDER, Tim | Secrétaire | Citra Barn Frizers Farm Sonning Eye RG4 6TN Reading Berkshire | Canadian | 117731640001 | ||||||
| SHARMA, Brian Dominic | Secrétaire | Vastern Road RG1 8BU Reading 55 Berkshire United Kingdom | 208039170001 | |||||||
| TOPP, Janice Susan | Secrétaire | Roman Way Longridge Road PR2 5BE Preston 70-71 Lancashire | Other | 139112080001 | ||||||
| WADDELL, Archie Stuart | Secrétaire | 200 Dunkeld Road PH1 3AQ Perth Inveralmond House Scotland | 234996520001 | |||||||
| DUPORT SECRETARY LIMITED | Secrétaire désigné | 2 Southfield Road BS9 3BH Westbury On Trym The Bristol Office Bristol | 900020060001 | |||||||
| BAETZ, Michael | Administrateur | 161 Bay Street, Suite 4540 PO BOX 709 M5J2S1 Toronto Canada Trust Tower Ontario Canada | Canada | Canadian | 166562600001 | |||||
| FRIGHT, Neil Grant | Administrateur | Roman Way Longridge Road PR2 5BE Preston 70-71 Lancashire United Kingdom | England | British | 165864840002 | |||||
| HIGGINS, Vanessa Claire | Administrateur | Denchworth OX12 0DX Wantage Denchworth Manor Oxfordshire United Kingdom | England | British | 139427570001 | |||||
| HILLMAN, Christopher Michael | Administrateur | Vastern Road RG1 8BU Reading 55 Berkshire United Kingdom | England | British | 17572470002 | |||||
| HUMPHREYS, Aled Robert | Administrateur | Caspian Road Atlantic Street WA14 5HH Altrincham Ocean Court United Kingdom | United Kingdom | British | 200150330001 | |||||
| LOCHERY, Anthony Francis | Administrateur | Caspian Road, Atlantic Street Broadheath WA14 5HH Altrincham Ocean Court Cheshire United Kingdom | England | British | 18996670003 | |||||
| MCPHILLIMY, James | Administrateur | 200 Dunkeld Road PH1 3AQ Perth Inveralmond House Scotland | United Kingdom | British | 94397700001 | |||||
| NIVEN, Veronica Mary | Administrateur | Caspian Road, Atlantic Street Broadheath WA14 5HH Altrincham Ocean Court Cheshire United Kingdom | United Kingdom | British | 173743440001 | |||||
| PARKE, Gary | Administrateur | Marchwood The Crescent Lower Shiplake RG9 3LL Henley On Thames Oxfordshire | British | 118299620001 | ||||||
| ROTHERHAM, David Scott | Administrateur | Roman Way Longridge Road PR2 5BE Preston 70-71 Lancashire United Kingdom | England | British | 146140260002 | |||||
| SCHNEIDER, Timothy John | Administrateur | Wyatt Close Wargrave RG10 8EB Reading 5 Berkshire United Kingdom | United Kingdom | Canadian | 150003200001 | |||||
| SHERIDAN, Richard Brinsley | Administrateur | Caspian Road Atlantic Street WA14 5HH Altrincham Ocean Court United Kingdom | United Kingdom | British | 192888360001 | |||||
| SHERIDAN, Richard Brinsley | Administrateur | Caspian Road, Atlantic Street Broadheath WA14 5HH Altrincham Ocean Court Cheshire United Kingdom | United Kingdom | British | 192888360001 | |||||
| SHLESINGER, Joseph Charles | Administrateur | Roman Way Longridge Road PR2 5BE Preston 70-71 Lancashire | Canada | Canadian | 139607450001 | |||||
| SOPER, Daniel | Administrateur | 20 Grey Road Toronto Ontario M5m 4ez Canada | Canadian | 117597800001 | ||||||
| STEVENSON, Lawrence Napier | Administrateur | Roman Way Longridge Road PR2 5BE Preston 70-71 Lancashire | Canada | Canadian | 131305220002 | |||||
| TENNENT, Colin Robert | Administrateur | Roman Way Longridge Road PR2 5BE Preston 70-71 Lancashire | England | British | 23661940005 | |||||
| DUPORT DIRECTOR LIMITED | Administrateur désigné | 2 Southfield Road Westbury-On-Trym BS9 3BH Bristol | 900020050001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur EVOLVE ENERGY LTD ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| The Energy Solutions Group Bidco Limited | 06 avr. 2016 | Caspian Road Atlantic Street WA14 5HH Altrincham Ocean Court United Kingdom | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
EVOLVE ENERGY LTD a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Créé le 02 nov. 2012 Livré le 10 nov. 2012 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.. See image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 25 juil. 2012 Livré le 15 août 2012 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, all equipment see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Créé le 21 juil. 2011 Livré le 29 juil. 2011 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and the obligor to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 20 juin 2008 Livré le 24 juin 2008 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Pledge | Créé le 30 nov. 2006 Livré le 14 déc. 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti £850,000.00 due or to become due from the company tounder the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Share capital in ashdown control services limited. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0