AMK AUTOMOTIVE COMPONENTS LIMITED

AMK AUTOMOTIVE COMPONENTS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéAMK AUTOMOTIVE COMPONENTS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 05835514
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de AMK AUTOMOTIVE COMPONENTS LIMITED ?

    • fabrication d'autres machines à usage spécial n.c.a. (28990) / Industries manufacturières

    Où se situe AMK AUTOMOTIVE COMPONENTS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    c/o FRP ADVISORY LLP
    110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de AMK AUTOMOTIVE COMPONENTS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    OSL AUTOMOTIVE LIMITED02 janv. 200702 janv. 2007
    AMK AUTOMOTIVE COMPONENTS LIMITED06 sept. 200606 sept. 2006
    SHELFCO (NO. 3272) LIMITED02 juin 200602 juin 2006

    Quels sont les derniers comptes de AMK AUTOMOTIVE COMPONENTS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2014

    Quels sont les derniers dépôts pour AMK AUTOMOTIVE COMPONENTS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Déclaration de biens vacants

    1 pagesBONA

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 09 déc. 2016

    10 pages2.24B

    Avis de transition de l'administration à la dissolution le 09 déc. 2016

    10 pages2.35B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 17 juin 2016

    21 pages2.24B

    Avis d'approbation réputée des propositions

    1 pagesF2.18

    Déclaration des affaires avec le formulaire 2.14B

    15 pages2.16B

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    39 pages2.17B

    Changement d'adresse du siège social de Greengates Mill Chickenley Lane Dewsbury West Yorkshire WF12 8QD à C/O Frp Advisory Llp 110 Cannon Street London EC4N 6EU le 06 janv. 2016

    2 pagesAD01

    Nomination d'un administrateur

    1 pages2.12B

    Inscription de la charge 058355140013, créée le 23 nov. 2015

    33 pagesMR01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2014

    22 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 12 mai 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital12 mai 2015

    État du capital au 12 mai 2015

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Cessation de la nomination de Alan Griffiths en tant que directeur le 30 avr. 2015

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Simon Mark Salloway en tant qu'administrateur le 30 avr. 2015

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr John Peter Sutton en tant qu'administrateur le 30 avr. 2015

    2 pagesAP01

    Nomination de Mrs Jane Louise Spurr en tant qu'administrateur le 30 avr. 2015

    2 pagesAP01

    Inscription de la charge 058355140012, créée le 11 nov. 2014

    15 pagesMR01

    Déclaration annuelle jusqu'au 29 juin 2014 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital08 août 2014

    État du capital au 08 août 2014

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2013

    22 pagesAA

    Satisfaction de la charge 2 en totalité

    2 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    2 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 6 en totalité

    2 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 5 en totalité

    2 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 8 en totalité

    1 pagesMR04

    Qui sont les dirigeants de AMK AUTOMOTIVE COMPONENTS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SPURR, Jane Louise
    c/o Frp Advisory Llp
    110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    Secrétaire
    c/o Frp Advisory Llp
    110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    179427040001
    SALLOWAY, Simon Mark
    c/o Frp Advisory Llp
    110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    Administrateur
    c/o Frp Advisory Llp
    110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    EnglandBritishManaging Director197576600001
    SPURR, Jane Louise
    c/o Frp Advisory Llp
    110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    Administrateur
    c/o Frp Advisory Llp
    110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    EnglandBritishOperations Director197567650001
    SUTTON, John Peter
    c/o Frp Advisory Llp
    110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    Administrateur
    c/o Frp Advisory Llp
    110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    EnglandBritishFinancial Director197568050001
    KEARNS, David Thomas
    139 Trap Lane
    S11 7RF Sheffield
    Secrétaire
    139 Trap Lane
    S11 7RF Sheffield
    BritishDirector91557010003
    LUSH, Paul Andrew
    12 Park Lane
    YO8 8LW Burn
    North Yorkshire
    Secrétaire
    12 Park Lane
    YO8 8LW Burn
    North Yorkshire
    BritishAccountant83904530001
    EPS SECRETARIES LIMITED
    Lacon House
    Theobalds Road
    WC1X 8RW London
    Secrétaire désigné
    Lacon House
    Theobalds Road
    WC1X 8RW London
    900023740001
    BENJAMIN, Philip Gregory
    St Catherine Drive
    Hartford
    CW8 2FE Northwich
    19
    Cheshire
    England
    Administrateur
    St Catherine Drive
    Hartford
    CW8 2FE Northwich
    19
    Cheshire
    England
    EnglandBritishDirector51555070003
    COOK, David Edward
    Richmond Lodge
    2a Hale Road
    WA15 8RD Hale
    Cheshire
    Administrateur
    Richmond Lodge
    2a Hale Road
    WA15 8RD Hale
    Cheshire
    BritishDirector115357130001
    GREY, David
    77 Rundle Road
    Nether Edge
    S7 1NW Sheffield
    Administrateur
    77 Rundle Road
    Nether Edge
    S7 1NW Sheffield
    EnglishEnglishManaging Director48278360004
    GREY, Mathew James
    Abbeydale Park Rise
    S17 3PF Sheffield
    80
    South Yorkshire
    Uk
    Administrateur
    Abbeydale Park Rise
    S17 3PF Sheffield
    80
    South Yorkshire
    Uk
    UkEnglishSales Director176340020001
    GRIFFITHS, Alan
    Chickenley Lane
    WF12 8QD Dewsbury
    Greengates Mill
    West Yorkshire
    England
    Administrateur
    Chickenley Lane
    WF12 8QD Dewsbury
    Greengates Mill
    West Yorkshire
    England
    EnglandBritishManaging Director33807810002
    HEATON, Christopher Charles Standring
    6 Home Farm Court
    Wortley
    S35 7DT Sheffield
    South Yorkshire
    Administrateur
    6 Home Farm Court
    Wortley
    S35 7DT Sheffield
    South Yorkshire
    EnglandBritishCo Director40217900001
    KEARNS, David Thomas
    139 Trap Lane
    S11 7RF Sheffield
    Administrateur
    139 Trap Lane
    S11 7RF Sheffield
    United KingdomBritishDirector91557010003
    LUSH, Paul Andrew
    12 Park Lane
    YO8 8LW Burn
    North Yorkshire
    Administrateur
    12 Park Lane
    YO8 8LW Burn
    North Yorkshire
    United KingdomBritishAccountant83904530001
    MIKJON LIMITED
    Lacon House
    Theobalds Road
    WC1X 8RW London
    Administrateur désigné
    Lacon House
    Theobalds Road
    WC1X 8RW London
    900023730001

    AMK AUTOMOTIVE COMPONENTS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 23 nov. 2015
    Livré le 04 déc. 2015
    En cours
    Brève description
    1. by way of first legal mortgage all estates or interests in any freehold or leasehold property now owned by it. 2. to the extent that they are not the subject of a mortgage under 1 above, all estates or interests in any freehold or leasehold property. 3. by way of first fixed charge, all of its rights in respect of: any know-how, patent, trade mark, service mark, design, business name, topographical or similar right, this includes the patents and trademarks (if any); any copyright or other intellectual property monopoly right; or any interest (including by way of licence) in any of the above, in each case whether registered or not and including all applications for the same.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • 3. Borg Automotive a/S a Company Registered in Denmark and Having Its Registered Office at Bergoesvej 12, 8600 Silkeborg, Denmark
    • 2. Elstock a/S, a Company Registered in Denmark and Having Its Registered Office at Bergsoesvej 12, 8600 Silkeborg, Denmark
    • 1.Car Parts Industries UK Limited (Company Number 06586098)
    Transactions
    • 04 déc. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 11 nov. 2014
    Livré le 20 nov. 2014
    En cours
    Brève description
    All freehold, leasehold and other immovable property wherever situated now or in the future belonging to the company together with all buildings, trade and other fixtures, fittings, fixed plant and machinery of the company.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Car Parts Industries UK Limited
    Transactions
    • 20 nov. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 27 sept. 2013
    Livré le 09 oct. 2013
    En cours
    Brève description
    Notification of addition to or amendment of charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Borg Automotive a/S
    • Elstock a/S
    Transactions
    • 09 oct. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    Chattels mortgage
    Créé le 02 avr. 2010
    Livré le 09 avr. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Schedules - owner: osl automotive limited category of relevant chattels: plant & machinery brief description: 2 UP100 power press site: aldwarke terrace aldwarke road parkgate rotherham, owner: osl group limited category of relevant chattels: plant & machinery brief description: assembly hydrosure static unit site: 125 pasture road moreton wirral merseyside, owner: osl group limited category of relevant chattels: plant & machinery brief description: siemens PLC S7/200 with proface screen site: 125 pasture road moreton wirral merseyside for details of further chattels please see form MG01 see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 09 avr. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 29 nov. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 02 avr. 2010
    Livré le 09 avr. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 09 avr. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 29 nov. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    All assets debenture
    Créé le 31 mars 2010
    Livré le 03 avr. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Commercial Finance Limited
    Transactions
    • 03 avr. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 29 nov. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Assignment
    Créé le 08 sept. 2009
    Livré le 15 sept. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    The policy - insurer:scottish equitable p/no:L0192377323 christopher charles standring heaton, sum assured:£75,000 date:09/01/2009.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 15 sept. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 nov. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 06 févr. 2008
    Livré le 15 févr. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H property k/a imperial works sheffield road sheffield t/no SYK452550. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 15 févr. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 nov. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 05 juil. 2007
    Livré le 23 juil. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a unit 32 kotchkiss way binley coventry t/no WM245968. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 23 juil. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 nov. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 05 juil. 2007
    Livré le 23 juil. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H property k/a land and buildings off saltmeadows road gateshead tyne & wear t/no TY327223. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 23 juil. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 nov. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 05 juil. 2007
    Livré le 23 juil. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a greengates mill (and adjoining land) chickenley lane osset,desbury west yorkshire t/no's WYK739061,WYK642098,WYK657019 and WYK668443. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 23 juil. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 mars 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 05 juil. 2007
    Livré le 23 juil. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property land and buildings off st james road corby northamptonshire t/no NN166019. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 23 juil. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 nov. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 18 août 2006
    Livré le 26 août 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including bookdebts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 26 août 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 10 mars 2010Déclaration que tout ou partie de la propriété grevée a été libérée (MG04)
    • 29 nov. 2013Satisfaction d'une charge (MR04)

    AMK AUTOMOTIVE COMPONENTS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    18 déc. 2015Administration started
    09 déc. 2016Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Jason Daniel Baker
    110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    practitioner
    110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    Anthony John Wright
    Frp Advisory Llp 2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London
    practitioner
    Frp Advisory Llp 2nd Floor 110 Cannon Street
    EC4N 6EU London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0