KENMORE CAPITAL KNOWSLEY 2 LTD

KENMORE CAPITAL KNOWSLEY 2 LTD

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéKENMORE CAPITAL KNOWSLEY 2 LTD
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 05838224
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de KENMORE CAPITAL KNOWSLEY 2 LTD ?

    • (7011) /

    Où se situe KENMORE CAPITAL KNOWSLEY 2 LTD ?

    Adresse du siège social
    58 Davies Street
    London
    W1K 5JF
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de KENMORE CAPITAL KNOWSLEY 2 LTD ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    SOUTHLAWN LIMITED06 juin 200606 juin 2006

    Quels sont les derniers dépôts pour KENMORE CAPITAL KNOWSLEY 2 LTD ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    3 pages4.71

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 09 janv. 2011

    5 pages4.68

    Ordonnance du tribunal d'insolvabilité

    Court order INSOLVENCY:replacement of liq
    11 pagesLIQ MISC OC

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    2 pages600

    Avis de cessation d'agir en tant que liquidateur volontaire

    1 pages4.40

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 09 juil. 2010

    5 pages4.68

    Cessation de la nomination de John Kennedy en tant que directeur

    3 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Andrew White en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 09 janv. 2010

    5 pages4.68

    legacy

    1 pages288b

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 09 juil. 2009

    5 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 09 janv. 2009

    5 pages4.68

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Démission d'un liquidateur

    1 pages4.33

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 09 juil. 2008

    5 pages4.68

    legacy

    1 pages288b

    legacy

    1 pages288a

    legacy

    1 pages403a

    legacy

    1 pages403a

    legacy

    1 pages403a

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation

    LRESSP

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    legacy

    2 pages363a

    Qui sont les dirigeants de KENMORE CAPITAL KNOWSLEY 2 LTD ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BROOK, Robert William Middleton
    Ashchurch Park Villas
    W12 9SP London
    9
    Administrateur
    Ashchurch Park Villas
    W12 9SP London
    9
    United KingdomBritishChartered Surveyor59050120004
    BROWN, John Kenneth
    33 Castle Street
    EH2 3DN Edinburgh
    Midlothian
    Secrétaire
    33 Castle Street
    EH2 3DN Edinburgh
    Midlothian
    BritishChartered Accountant102727770001
    MCCALL, Peter Michael
    19 Bonaly Terrace
    EH13 0EL Edinburgh
    Midlothian
    Secrétaire
    19 Bonaly Terrace
    EH13 0EL Edinburgh
    Midlothian
    BritishSolicitor119269620001
    BRIAN REID LTD.
    5 Logie Mill Beaverbank Office Park
    Logie Green Road
    EH7 4HH Edinburgh
    Secrétaire désigné
    5 Logie Mill Beaverbank Office Park
    Logie Green Road
    EH7 4HH Edinburgh
    900018660001
    KENNEDY, John Anthony Bingham
    Newhall
    Carlops
    EH26 9LY Penicuik
    Midlothian
    Administrateur
    Newhall
    Carlops
    EH26 9LY Penicuik
    Midlothian
    ScotlandBritishChartered Surveyor71043680001
    WHITE, Andrew Edward
    Craigend
    2 Cromwell Road
    EH39 4LZ North Berwick
    East Lothian
    Administrateur
    Craigend
    2 Cromwell Road
    EH39 4LZ North Berwick
    East Lothian
    ScotlandBritishChartered Surveyor110163980001
    STEPHEN MABBOTT LTD.
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    Administrateur désigné
    14 Mitchell Lane
    G1 3NU Glasgow
    900018650001

    KENMORE CAPITAL KNOWSLEY 2 LTD a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal charge
    Créé le 30 août 2006
    Livré le 06 sept. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    L/H unit 2 puma court kings business centre kings business park knowsley liverpool. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland for Itself and as Security Trustee for Thefinance Parties
    Transactions
    • 06 sept. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 août 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 30 août 2006
    Livré le 06 sept. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    L/H unit 4 puma court kings business centre kings business park knowsley liverpool. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland for Itself and as Security Trustee for Thefinance Parties
    Transactions
    • 06 sept. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 août 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 30 août 2006
    Livré le 06 sept. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    L/H unit 5 puma court kings business centre kings business park knowsley liverpool. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland for Itself and as Security Trustee for Thefinance Parties
    Transactions
    • 06 sept. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 30 août 2006
    Livré le 06 sept. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    L/H unit 6 puma court kings business centre kings business park knowsley liverpool. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland for Itself and as Security Trustee for Thefinance Parties
    Transactions
    • 06 sept. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 août 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 30 août 2006
    Livré le 06 sept. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    L/H unit 1 puma court kings business centre kings business park knowsley liverpool. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland for Itself and as Security Trustee for Thefinance Parties
    Transactions
    • 06 sept. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 août 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 30 août 2006
    Livré le 06 sept. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland as Security Trustee for Itself and for Thefinance Parties
    Transactions
    • 06 sept. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 juil. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Floating charge
    Créé le 30 août 2006
    Livré le 02 sept. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The assets meaning the whole of the property (including the uncalled capital) and undertaking.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 02 sept. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 juil. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    KENMORE CAPITAL KNOWSLEY 2 LTD a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    10 juil. 2007Commencement of winding up
    27 août 2011Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Timothy Gerard Walsh
    Pricewaterhousecoopers
    32 Albyn Place
    AB10 1YL Aberdeen
    practitioner
    Pricewaterhousecoopers
    32 Albyn Place
    AB10 1YL Aberdeen
    Graham H Martin
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Kintyre House
    G2 2LW 209 West George Street
    Glasgow
    practitioner
    Pricewaterhousecoopers Llp
    Kintyre House
    G2 2LW 209 West George Street
    Glasgow
    Stephen Roland Browne
    32 Albyn Place
    AB10 1YL Aberdeen
    Aberdeenshire
    practitioner
    32 Albyn Place
    AB10 1YL Aberdeen
    Aberdeenshire
    John Bruce Cartwright
    Plumtree Court
    EC4A 4HT London
    practitioner
    Plumtree Court
    EC4A 4HT London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0