VENICE BIDCO 1 LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | VENICE BIDCO 1 LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 05839374 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Non |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe VENICE BIDCO 1 LIMITED ?
Adresse du siège social | The Inspire Hornbeam Square West HG2 8PA Harrogate North Yorkshire |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de VENICE BIDCO 1 LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2017 |
Quels sont les derniers dépôts pour VENICE BIDCO 1 LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 1 pages | DS01 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 058393740009 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Inscription de la charge 058393740009, créée le 10 oct. 2018 | 75 pages | MR01 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 058393740008 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 058393740007 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2017 | 21 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 07 juin 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2016 | 20 pages | AA | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 07 juin 2017 avec mises à jour | 5 pages | CS01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2015 | 20 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 07 juin 2016 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Anthony Gerrard Troy le 10 juin 2016 | 2 pages | CH01 | ||||||||||
Inscription de la charge 058393740008, créée le 01 déc. 2015 | 85 pages | MR01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2014 | 20 pages | AA | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 07 juin 2015 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomination de Mr James Alexander Burrell en tant qu'administrateur le 10 nov. 2014 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 31 déc. 2013 | 21 pages | AA | ||||||||||
Satisfaction de la charge 6 en totalité | 4 pages | MR04 | ||||||||||
Inscription de la charge 058393740007 | 90 pages | MR01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 07 juin 2014 avec liste complète des actionnaires | 5 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Satisfaction de la charge 4 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 5 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 2 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de VENICE BIDCO 1 LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BURRELL, James Alexander | Administrateur | Hornbeam Square West HG2 8PA Harrogate The Inspire North Yorkshire | United Kingdom | British | Accountant | 192486560001 | ||||
GALLAGHER, Geraldine Josephine | Administrateur | Hornbeam Square West HG2 8PA Harrogate The Inspire North Yorkshire United Kingdom | England | Irish | Finance Director | 185108770001 | ||||
HUNTER, Gail Susan | Administrateur | Hornbeam Park HG2 8PA Harrogate The Inspire North Yorkshire | United Kingdom | British | Human Resources Director | 156206540001 | ||||
TROY, Anthony Gerrard | Administrateur | Hornbeam Square West HG2 8PA Harrogate The Inspire North Yorkshire | United Kingdom | Irish | Director | 104500230001 | ||||
BENNISON, Matthew Edward | Secrétaire | Hornbeam Square West HG2 8PA Harrogate The Inspire North Yorkshire United Kingdom | 161749530001 | |||||||
DOUBLEDAY, Timothy | Secrétaire | Hornbeam Park HG2 8PA Harrogate The Inspire North Yorkshire United Kingdom | British | 156133710001 | ||||||
GALLAGHER, Geraldine Josephine | Secrétaire | Risplith House HG4 3EP Risplith North Yorkshire | Irish | Company Secretary | 185108770001 | |||||
CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED | Secrétaire désigné | 10 Upper Bank Street E14 5JJ London | 900005620001 | |||||||
BENNISON, Matthew Edward | Administrateur | Hornbeam Square West HG2 8PA Harrogate The Inspire North Yorkshire United Kingdom | England | British | Company Director | 108534390002 | ||||
BURRELL, James | Administrateur | 79 Disraeli Road SW15 2DR London | British | Investment Executive | 115775330001 | |||||
CLARKE, Martin Andrew, Dr | Administrateur | 35 The Bromptons Rose Square SW3 6RS London Uk | United Kingdom | British | Partner At Private Equity Hous | 121053560001 | ||||
DAY, Mark | Administrateur | Welton Hill Kidd Lane HU15 1PH Welton Brough North Humberside | England | British | Director | 124446000001 | ||||
DOUBLEDAY, Timothy John | Administrateur | Hornbeam Park HG2 8PA Harrogate The Inspire North Yorkshire United Kingdom | United Kingdom | British | Chief Financial Officer | 91011320001 | ||||
FLANAGAN, Sally Deborah | Administrateur | 10 Cobden Hill WD7 7JR Radlett Hertfordshire | England | British | Investment Executive | 116577710001 | ||||
LEVY, Adrian Joseph Morris | Administrateur | 2 Carlisle Gardens HA3 0JX Harrow Middlesex | United Kingdom | British | Solicitor | 147682410001 | ||||
NISBETT, Paul Sandle | Administrateur | The Grove Bletchley MK3 6BZ Milton Keynes 5 Buckinghamshire | England | British | Company Director | 132613500001 | ||||
PUDGE, David John | Administrateur désigné | 20 Herondale Avenue SW18 3JL London | British | 900028170001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur VENICE BIDCO 1 LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Venice Newco 2 Limited | 06 avr. 2016 | Hornbeam Square West HG2 8PA Harrogate The Inspire England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
VENICE BIDCO 1 LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Créé le 10 oct. 2018 Livré le 11 oct. 2018 | Totalement satisfaite | ||
La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A registered charge | Créé le 01 déc. 2015 Livré le 03 déc. 2015 | Totalement satisfaite | ||
Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A registered charge | Créé le 12 juin 2014 Livré le 18 juin 2014 | Totalement satisfaite | ||
Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
English law deed of accession | Créé le 27 févr. 2013 Livré le 01 mars 2013 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from each obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 01 déc. 2011 Livré le 10 déc. 2011 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from any obligor or chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Share charge | Créé le 05 juil. 2010 Livré le 13 juil. 2010 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from any obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Full title guarantee all of the subsidiary shares and all corresponding distribution rights (the "mortgaged property") see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Deed of accession | Créé le 23 juin 2009 Livré le 01 juil. 2009 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from any obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A share charge | Créé le 25 mai 2007 Livré le 30 mai 2007 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from any obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions All subsidiary shares and all corresponding distribution rights and floating charge all assets and undertakings. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Share charge | Créé le 08 sept. 2006 Livré le 27 sept. 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from any obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions All subsidiary shares and all corresponding distribution rights. By way of floating charge all assets and undertakings. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0