VENICE BIDCO 1 LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéVENICE BIDCO 1 LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 05839374
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de VENICE BIDCO 1 LIMITED ?

    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe VENICE BIDCO 1 LIMITED ?

    Adresse du siège social
    The Inspire
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    North Yorkshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de VENICE BIDCO 1 LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    FLIGHTCLOSE LIMITED07 juin 200607 juin 2006

    Quels sont les derniers comptes de VENICE BIDCO 1 LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2017

    Quels sont les derniers dépôts pour VENICE BIDCO 1 LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Satisfaction de la charge 058393740009 en totalité

    1 pagesMR04

    Inscription de la charge 058393740009, créée le 10 oct. 2018

    75 pagesMR01

    Satisfaction de la charge 058393740008 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 058393740007 en totalité

    1 pagesMR04

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2017

    21 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 07 juin 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2016

    20 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 07 juin 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2015

    20 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 07 juin 2016 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital10 juin 2016

    État du capital au 10 juin 2016

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Anthony Gerrard Troy le 10 juin 2016

    2 pagesCH01

    Inscription de la charge 058393740008, créée le 01 déc. 2015

    85 pagesMR01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2014

    20 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 07 juin 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital08 juin 2015

    État du capital au 08 juin 2015

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Nomination de Mr James Alexander Burrell en tant qu'administrateur le 10 nov. 2014

    2 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2013

    21 pagesAA

    Satisfaction de la charge 6 en totalité

    4 pagesMR04

    Inscription de la charge 058393740007

    90 pagesMR01

    Déclaration annuelle jusqu'au 07 juin 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital09 juin 2014

    État du capital au 09 juin 2014

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 5 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 2 en totalité

    1 pagesMR04

    Qui sont les dirigeants de VENICE BIDCO 1 LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BURRELL, James Alexander
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    Administrateur
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United KingdomBritishAccountant192486560001
    GALLAGHER, Geraldine Josephine
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandIrishFinance Director185108770001
    HUNTER, Gail Susan
    Hornbeam Park
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    Administrateur
    Hornbeam Park
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United KingdomBritishHuman Resources Director156206540001
    TROY, Anthony Gerrard
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    Administrateur
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United KingdomIrishDirector104500230001
    BENNISON, Matthew Edward
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    161749530001
    DOUBLEDAY, Timothy
    Hornbeam Park
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Hornbeam Park
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    British156133710001
    GALLAGHER, Geraldine Josephine
    Risplith House
    HG4 3EP Risplith
    North Yorkshire
    Secrétaire
    Risplith House
    HG4 3EP Risplith
    North Yorkshire
    IrishCompany Secretary185108770001
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Secrétaire désigné
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    900005620001
    BENNISON, Matthew Edward
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director108534390002
    BURRELL, James
    79 Disraeli Road
    SW15 2DR London
    Administrateur
    79 Disraeli Road
    SW15 2DR London
    BritishInvestment Executive115775330001
    CLARKE, Martin Andrew, Dr
    35 The Bromptons
    Rose Square
    SW3 6RS London
    Uk
    Administrateur
    35 The Bromptons
    Rose Square
    SW3 6RS London
    Uk
    United KingdomBritishPartner At Private Equity Hous121053560001
    DAY, Mark
    Welton Hill
    Kidd Lane
    HU15 1PH Welton Brough
    North Humberside
    Administrateur
    Welton Hill
    Kidd Lane
    HU15 1PH Welton Brough
    North Humberside
    EnglandBritishDirector124446000001
    DOUBLEDAY, Timothy John
    Hornbeam Park
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Hornbeam Park
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishChief Financial Officer91011320001
    FLANAGAN, Sally Deborah
    10 Cobden Hill
    WD7 7JR Radlett
    Hertfordshire
    Administrateur
    10 Cobden Hill
    WD7 7JR Radlett
    Hertfordshire
    EnglandBritishInvestment Executive116577710001
    LEVY, Adrian Joseph Morris
    2 Carlisle Gardens
    HA3 0JX Harrow
    Middlesex
    Administrateur
    2 Carlisle Gardens
    HA3 0JX Harrow
    Middlesex
    United KingdomBritishSolicitor147682410001
    NISBETT, Paul Sandle
    The Grove
    Bletchley
    MK3 6BZ Milton Keynes
    5
    Buckinghamshire
    Administrateur
    The Grove
    Bletchley
    MK3 6BZ Milton Keynes
    5
    Buckinghamshire
    EnglandBritishCompany Director132613500001
    PUDGE, David John
    20 Herondale Avenue
    SW18 3JL London
    Administrateur désigné
    20 Herondale Avenue
    SW18 3JL London
    British900028170001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur VENICE BIDCO 1 LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Venice Newco 2 Limited
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    England
    06 avr. 2016
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Liability Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act
    Lieu d'enregistrementEngland
    Numéro d'enregistrement05879450
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.

    VENICE BIDCO 1 LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 10 oct. 2018
    Livré le 11 oct. 2018
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Wells Fargo Bank, N.A., London Branch
    Transactions
    • 11 oct. 2018Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 09 janv. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 01 déc. 2015
    Livré le 03 déc. 2015
    Totalement satisfaite
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Cbre Loan Servicing Limited
    Transactions
    • 03 déc. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 11 oct. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 12 juin 2014
    Livré le 18 juin 2014
    Totalement satisfaite
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Cbre Loan Servicing Limited
    Transactions
    • 18 juin 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 11 oct. 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    English law deed of accession
    Créé le 27 févr. 2013
    Livré le 01 mars 2013
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Citicorp Trustee Company Limited
    Transactions
    • 01 mars 2013Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 27 juin 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 01 déc. 2011
    Livré le 10 déc. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any obligor or chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 10 déc. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 03 juin 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Share charge
    Créé le 05 juil. 2010
    Livré le 13 juil. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Full title guarantee all of the subsidiary shares and all corresponding distribution rights (the "mortgaged property") see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 13 juil. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 03 juin 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of accession
    Créé le 23 juin 2009
    Livré le 01 juil. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC (As Trustee for and on Behalf of Itself and Each of the Secured Parties (Security Agent)
    Transactions
    • 01 juil. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 juin 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    A share charge
    Créé le 25 mai 2007
    Livré le 30 mai 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All subsidiary shares and all corresponding distribution rights and floating charge all assets and undertakings. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 30 mai 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 juin 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Share charge
    Créé le 08 sept. 2006
    Livré le 27 sept. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All subsidiary shares and all corresponding distribution rights. By way of floating charge all assets and undertakings. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC, as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties(The Security Agent)
    Transactions
    • 27 sept. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 23 sept. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0