E.L.A. PROPERTY SERVICES LIMITED

E.L.A. PROPERTY SERVICES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéE.L.A. PROPERTY SERVICES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 05856516
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de E.L.A. PROPERTY SERVICES LIMITED ?

    • Achat et vente de biens immobiliers propres (68100) / Activités immobilières

    Où se situe E.L.A. PROPERTY SERVICES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    c/o BARRY COMPTON & CO
    14 Hallsland Way
    RH8 9AL Oxted
    Surrey
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de E.L.A. PROPERTY SERVICES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 juin 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour E.L.A. PROPERTY SERVICES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    11 pagesLIQ13

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 14 juil. 2017

    11 pagesLIQ03

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    2 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 15 juil. 2016

    LRESSP

    Déclaration de solvabilité

    3 pages4.70

    Comptes d'exonération totale établis au 30 juin 2016

    14 pagesAA

    Retrait de la demande de radiation de la société

    1 pagesDS02

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 23 juin 2016 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital27 juin 2016

    État du capital au 27 juin 2016

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Cessation de la nomination de Lucas Writer en tant que directeur le 30 juin 2015

    1 pagesTM01

    Comptes d'exonération totale établis au 30 juin 2015

    13 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 23 juin 2015 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital30 juin 2015

    État du capital au 30 juin 2015

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Comptes d'exonération totale établis au 30 juin 2014

    13 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 23 juin 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital05 août 2014

    État du capital au 05 août 2014

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Comptes d'exonération totale établis au 30 juin 2013

    13 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 23 juin 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital06 août 2013

    État du capital après une attribution d'actions au 06 août 2013

    SH01

    Comptes d'exonération totale établis au 30 juin 2012

    14 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 23 juin 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Adam Peter Aronow le 20 sept. 2012

    2 pagesCH01

    Comptes d'exonération totale établis au 30 juin 2011

    13 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 23 juin 2011 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Changement d'adresse du siège social de * South Barn, Crockham Park Crockham Hill Edenbridge Kent TN8 6SR* le 04 juil. 2011

    1 pagesAD01

    Comptes d'exonération totale établis au 30 juin 2010

    13 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de E.L.A. PROPERTY SERVICES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    COMPTON, Barry Charles Chittenden
    14 Hallsland Way
    Hurst Green
    RH8 9AL Oxted
    Surrey
    Secrétaire
    14 Hallsland Way
    Hurst Green
    RH8 9AL Oxted
    Surrey
    British47071100001
    ARONOW, Adam Peter
    Gwynedd Close
    Tatsfield
    TN16 2DG Westerham
    St. Mary's Barn
    Kent
    United Kingdom
    Administrateur
    Gwynedd Close
    Tatsfield
    TN16 2DG Westerham
    St. Mary's Barn
    Kent
    United Kingdom
    United KingdomBritish123283510002
    WRITER, Lucas
    8 Bourdon Road
    SE20 7SR Anerley
    London
    Administrateur
    8 Bourdon Road
    SE20 7SR Anerley
    London
    United KingdomBritish113739290001

    E.L.A. PROPERTY SERVICES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal mortgage
    Créé le 08 févr. 2008
    Livré le 12 févr. 2008
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    240 ellison road london SW16 5DJ.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank PLC
    Transactions
    • 12 févr. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    Legal mortgage
    Créé le 01 août 2007
    Livré le 18 août 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The property k/a top floor flat, 76 ellison road, london. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank PLC
    Transactions
    • 18 août 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Legal mortgage
    Créé le 09 févr. 2007
    Livré le 01 mars 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    53A babington road streatham london. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank PLC
    Transactions
    • 01 mars 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 02 févr. 2007
    Livré le 09 févr. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank PLC
    Transactions
    • 09 févr. 2007Enregistrement d'une charge (395)

    E.L.A. PROPERTY SERVICES LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    15 juil. 2016Commencement of winding up
    04 déc. 2017Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    James E Patchett
    Turpin Barker Armstrong Allen House
    1 Westmead Road
    SM1 4LA Sutton
    Surrey
    practitioner
    Turpin Barker Armstrong Allen House
    1 Westmead Road
    SM1 4LA Sutton
    Surrey
    Martin Charles Armstrong
    Turpin Barker Armstrong
    Allen House
    SM1 4LA One Westmead Road
    Sutton Surrey
    practitioner
    Turpin Barker Armstrong
    Allen House
    SM1 4LA One Westmead Road
    Sutton Surrey

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0