TARGETFOLLOW (PORTMAN FLATS) LTD

TARGETFOLLOW (PORTMAN FLATS) LTD

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéTARGETFOLLOW (PORTMAN FLATS) LTD
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 05869670
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de TARGETFOLLOW (PORTMAN FLATS) LTD ?

    • Autre location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués (68209) / Activités immobilières

    Où se situe TARGETFOLLOW (PORTMAN FLATS) LTD ?

    Adresse du siège social
    Riverside House
    11-13 Riverside Road
    NR1 1SQ Norwich
    Norfolk
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de TARGETFOLLOW (PORTMAN FLATS) LTD ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2011

    Quels sont les derniers dépôts pour TARGETFOLLOW (PORTMAN FLATS) LTD ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Période comptable actuelle prolongée du 31 mars 2012 au 30 sept. 2012

    3 pagesAA01

    Déclaration annuelle jusqu'au 07 juil. 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital13 août 2012

    État du capital au 13 août 2012

    • Capital: GBP 831,687
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Peter Allan Dawson le 16 déc. 2011

    2 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2011

    17 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 07 juil. 2011 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Paul Laurence Huberman le 29 oct. 2010

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Peter Allan Dawson le 29 oct. 2010

    2 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2010

    17 pagesAA

    legacy

    4 pagesMG02

    legacy

    4 pagesMG02

    legacy

    4 pagesMG02

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution de modification des statuts

    RES01

    Cessation de la nomination de Ardeshir Naghshineh en tant que secrétaire

    2 pagesTM02

    Nomination de Mr Peter Allan Dawson en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Shapoor Naghshineh en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Ardeshir Naghshineh en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Nomination de Mr Paul Laurence Huberman en tant qu'administrateur

    3 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Vanessa Fletcher en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 07 juil. 2010 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Cessation de la nomination de Ian Fox en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2009

    17 pagesAA

    legacy

    4 pages363a

    Qui sont les dirigeants de TARGETFOLLOW (PORTMAN FLATS) LTD ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    DAWSON, Peter Allan
    Montreal Road
    TN13 2EP Sevenoaks
    Oak Beams
    Kent
    United Kingdom
    Administrateur
    Montreal Road
    TN13 2EP Sevenoaks
    Oak Beams
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Surveyor155666140002
    HUBERMAN, Paul Laurence
    Wildwood Road
    NW11 6UL London
    15
    United Kingdom
    Administrateur
    Wildwood Road
    NW11 6UL London
    15
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Accountant3470530003
    NAGHSHINEH, Ardeshir
    Mergate Farmhouse
    Mergate Lane Bracon Ash
    NR14 8ER Norwich
    Norfolk
    Secrétaire
    Mergate Farmhouse
    Mergate Lane Bracon Ash
    NR14 8ER Norwich
    Norfolk
    British60588430004
    FLETCHER, Vanessa Anne
    Wrentham House
    86 Southwold Road, Wrentham
    NR34 7JF Beccles
    Administrateur
    Wrentham House
    86 Southwold Road, Wrentham
    NR34 7JF Beccles
    EnglandBritishChartered Accountant101139900001
    FOX, Ian Stuart
    Dove Barn
    Queen's Road Hethersett
    NR9 3DB Norwich
    Administrateur
    Dove Barn
    Queen's Road Hethersett
    NR9 3DB Norwich
    EnglandBritishProperty Developer154671930001
    NAGHSHINEH, Ardeshir
    Mergate Farmhouse
    Mergate Lane Bracon Ash
    NR14 8ER Norwich
    Norfolk
    Administrateur
    Mergate Farmhouse
    Mergate Lane Bracon Ash
    NR14 8ER Norwich
    Norfolk
    EnglandBritishProperty Consultant60588430004
    NAGHSHINEH, Shapoor
    The Old Hall
    Church Lane Barford
    NR9 4AY Norwich
    Norfolk
    Administrateur
    The Old Hall
    Church Lane Barford
    NR9 4AY Norwich
    Norfolk
    EnglandBritishDirector52621450004

    TARGETFOLLOW (PORTMAN FLATS) LTD a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 17 oct. 2007
    Livré le 01 nov. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC as Security Trustee
    Transactions
    • 01 nov. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 21 sept. 2006
    Livré le 22 sept. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    L/H flat 72 portman towers 95 george street london t/no NGL101577 and l/h car parking space numbered 21 portman towers 95 george street london t/no NGL200572 and all rights to and interest in any insurances the gross rents licence fees and other monies the goodwill all moveable plant machienry. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Dunbar Bank PLC
    Transactions
    • 22 sept. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Floating charge
    Créé le 19 juil. 2006
    Livré le 27 juil. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of a first floating charge all the undertaking and assets of the company whatsoever and wheresoever both present and future.
    Personnes ayant droit
    • Dunbar Bank PLC
    Transactions
    • 27 juil. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 19 juil. 2006
    Livré le 27 juil. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The l/h land k/a flat 86 portman towers 95 george street london t/n NGL109135 all rights to and interest in any insurances in respect of the property the gross rents licence fees and other monies receivable in respect of the property (the rental income) all interest and rights under any contracts or agreements or claims for or in respect of the sale purchase leasing mortgaging management carrying out of works to development or redevelopment of or other dealing with or ownership of the property or any part thereof the goodwill of any business and floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment now or from time to time at the property. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Dunbar Bank PLC
    Transactions
    • 27 juil. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 févr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0