LASER HOTELS ONE LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéLASER HOTELS ONE LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 05893844
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de LASER HOTELS ONE LIMITED ?

    • Activités des sièges sociaux (70100) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe LASER HOTELS ONE LIMITED ?

    Adresse du siège social
    c/o HUDSON ADVISORS UK LIMITED
    17 Dominion Street
    EC2M 2EF London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de LASER HOTELS ONE LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    MREF HOTELS ONE LIMITED07 févr. 200707 févr. 2007
    MACDONALD HOTELS ONE LIMITED20 sept. 200620 sept. 2006
    BOWLFLIP LIMITED02 août 200602 août 2006

    Quels sont les derniers comptes de LASER HOTELS ONE LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2017

    Quels sont les derniers dépôts pour LASER HOTELS ONE LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    7 pagesLIQ13

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 12 sept. 2021

    8 pagesLIQ03

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 13 sept. 2019

    LRESSP

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 12 sept. 2020

    7 pagesLIQ03

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolutions

    Company be wound up voluntarily/joint liquidators appointed 13/09/2019
    RES13

    Déclaration de solvabilité

    6 pagesLIQ01

    Cessation de la nomination de Vincent Frederic Marc Vernier en tant que directeur le 08 juil. 2019

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Vincent Vernier en tant que secrétaire le 08 juil. 2019

    1 pagesTM02

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 3 en totalité

    1 pagesMR04

    Déclaration de confirmation établie le 02 août 2019 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Nomination de Mr Timothy Selwyn Jones en tant qu'administrateur le 13 déc. 2018

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Robert Edward Gray en tant que directeur le 24 oct. 2018

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2017

    21 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 02 août 2018 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Satisfaction de la charge 058938440005 en totalité

    4 pagesMR04

    Cessation de la nomination de John Brennan en tant que directeur le 04 mai 2018

    1 pagesTM01

    Nomination de Michael Gallagher en tant qu'administrateur le 20 déc. 2017

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Darren William Guy en tant que directeur le 20 déc. 2017

    1 pagesTM01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Vincent Vernier le 13 nov. 2017

    2 pagesCH01

    Cessation de la nomination de Neal Morar en tant que secrétaire le 03 oct. 2017

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Neal Morar en tant que directeur le 03 oct. 2017

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Vincent Vernier en tant que secrétaire le 06 oct. 2017

    2 pagesAP03

    Qui sont les dirigeants de LASER HOTELS ONE LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    GALLAGHER, Michael
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    United Kingdom
    Administrateur
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    United Kingdom
    IrelandIrish243693110001
    JONES, Timothy Selwyn
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    United Kingdom
    Administrateur
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    United Kingdom
    United KingdomBritish226437520001
    FRASER, Robert Gordon
    1 Glebe Court
    KA1 3BD Kilmarnock
    Ayrshire
    Secrétaire
    1 Glebe Court
    KA1 3BD Kilmarnock
    Ayrshire
    British120322350001
    MORAR, Neal
    c/o Hudson Advisors Uk Limited
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    England
    Secrétaire
    c/o Hudson Advisors Uk Limited
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    England
    197427310001
    SANDERSON, Timothy Robin Llewelyn
    Nightingale House
    65 Curzon Street
    W1J 8PE London
    Secrétaire
    Nightingale House
    65 Curzon Street
    W1J 8PE London
    British69033180003
    VERNIER, Vincent
    c/o Hudson Advisors Uk Limited
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    Secrétaire
    c/o Hudson Advisors Uk Limited
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    239131680001
    SWIFT INCORPORATIONS LIMITED
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    Secrétaire désigné
    Church Street
    NW8 8EP London
    26
    900008300001
    BRENNAN, John
    Pembroke Road
    Ballsbridge
    146
    Dublin 4
    Ireland
    Administrateur
    Pembroke Road
    Ballsbridge
    146
    Dublin 4
    Ireland
    IrelandIrish211131530001
    EDWARDS, Nicholas William John
    Nightingale House
    65 Curzon Street
    W1J 8PE London
    Administrateur
    Nightingale House
    65 Curzon Street
    W1J 8PE London
    EnglandBritish166575000001
    FERGUSON DAVIE, Charles John
    c/o Hudson Advisors Uk Limited
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    England
    Administrateur
    c/o Hudson Advisors Uk Limited
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    England
    United KingdomBritish159387570001
    FIGGE, Heiko
    Nightingale House
    65 Curzon Street
    W1J 8PE London
    Administrateur
    Nightingale House
    65 Curzon Street
    W1J 8PE London
    United KingdomBritish183639640001
    FRASER, Robert Gordon
    1 Glebe Court
    KA1 3BD Kilmarnock
    Ayrshire
    Administrateur
    1 Glebe Court
    KA1 3BD Kilmarnock
    Ayrshire
    United KingdomBritish120322350001
    GILBARD, Marc Edward Charles
    Nightingale House
    65 Curzon Street
    W1J 8PE London
    Administrateur
    Nightingale House
    65 Curzon Street
    W1J 8PE London
    United KingdomBritish29232300002
    GRAY, Robert Edward
    c/o Hudson Advisors Uk Limited
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    England
    Administrateur
    c/o Hudson Advisors Uk Limited
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    England
    United KingdomBritish188584900001
    GUILE, David Andrew
    5 Leaheath Way
    RG10 0TY Hurst
    Berkshire
    Administrateur
    5 Leaheath Way
    RG10 0TY Hurst
    Berkshire
    United KingdomBritish100133280001
    GUY, Darren
    Pembroke Road
    Ballsbridge
    146
    Dublin 4
    Ireland
    Administrateur
    Pembroke Road
    Ballsbridge
    146
    Dublin 4
    Ireland
    IrelandIrish294582970001
    HALL, Steven
    Nightingale House
    65 Curzon Street
    W1J 8PE London
    Administrateur
    Nightingale House
    65 Curzon Street
    W1J 8PE London
    United KingdomBritish147752500001
    MORAR, Neal
    c/o Hudson Advisors Uk Limited
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    England
    Administrateur
    c/o Hudson Advisors Uk Limited
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    England
    EnglandBritish173110500001
    SIDWELL, Graham Robert
    Nightingale House
    65 Curzon Street
    W1J 8PE London
    Administrateur
    Nightingale House
    65 Curzon Street
    W1J 8PE London
    United KingdomBritish72844280004
    SMITH, Gerard Henry
    Dallarich
    Caledonian Crescent
    PH3 1NG Gleneagles
    Perthshire
    Administrateur
    Dallarich
    Caledonian Crescent
    PH3 1NG Gleneagles
    Perthshire
    United KingdomBritish40871240003
    STANLEY, Graham Bryan
    Nightingale House
    65 Curzon Street
    W1J 8PE London
    Administrateur
    Nightingale House
    65 Curzon Street
    W1J 8PE London
    United KingdomBritish46112880007
    VERNIER, Vincent Frederic Marc
    c/o Hudson Advisors Uk Limited
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    Administrateur
    c/o Hudson Advisors Uk Limited
    Dominion Street
    EC2M 2EF London
    17
    United KingdomFrench185884890003
    INSTANT COMPANIES LIMITED
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    Administrateur désigné
    Mitchell Lane
    BS1 6BU Bristol
    1
    Avon
    900008290001

    Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour LASER HOTELS ONE LIMITED ?

    Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
    Notifié leCessé leDéclaration
    02 août 2016La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société.

    LASER HOTELS ONE LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 18 févr. 2015
    Livré le 26 févr. 2015
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Wells Fargo Bank, N.A., London Branch as Trustee for Each of the Secured Parties (The "Security Agent")
    Transactions
    • 26 févr. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 21 juin 2018Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 20 août 2010
    Livré le 03 sept. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 03 sept. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 14 août 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of pledge
    Créé le 20 août 2010
    Livré le 03 sept. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Pledged and charged the existing shares and any related rights see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 03 sept. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 14 août 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 16 oct. 2006
    Livré le 25 oct. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and the Company of the Bank of Scotland as Agent and Security Trustee for Itselfand the Other Secured Parties (The Security Trustee)
    Transactions
    • 25 oct. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 févr. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 16 oct. 2006
    Livré le 25 oct. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and the Company of the Bank of Scotland as Agent and Security Trustee for Itselfand the Other Secured Parties (The Security Trus
    • The Governor and the Company of the Bank of Scotland as Agent and Security Trustee for Itselftee)
    • The Governor and the Company of the Bank of Scotland as Agent and Security Trustee for Itselfand the Other Secured Parties (The Security Trustee)
    Transactions
    • 25 oct. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 08 févr. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    LASER HOTELS ONE LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    2
    DateType
    13 sept. 2019Commencement of winding up
    27 avr. 2022Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Emma Cray
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    practitioner
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Steven Sherry
    Pricewaterhousecoopers Llp, 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    practitioner
    Pricewaterhousecoopers Llp, 7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0