GRS PUB INVESTMENTS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéGRS PUB INVESTMENTS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 05895613
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de GRS PUB INVESTMENTS LIMITED ?

    • Développement de projets de construction (41100) / Construction
    • Administration de biens immobiliers pour compte de tiers (68320) / Activités immobilières

    Où se situe GRS PUB INVESTMENTS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Central Square
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    West Yorkshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de GRS PUB INVESTMENTS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    INN INVESTMENT LIMITED16 oct. 200616 oct. 2006
    MISLEX (504) LIMITED03 août 200603 août 2006

    Quels sont les derniers comptes de GRS PUB INVESTMENTS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au28 déc. 2014

    Quels sont les derniers dépôts pour GRS PUB INVESTMENTS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    18 pagesLIQ14

    Cessation de la nomination de Robert Keith Finlay Thomson en tant que directeur le 01 avr. 2018

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Samual Edward Kennedy en tant que directeur le 01 avr. 2018

    2 pagesTM01

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 10 août 2017

    32 pagesLIQ03

    Déclaration des affaires avec le formulaire 4.19 attaché

    5 pages4.20

    Changement d'adresse du siège social de 31 Haverscroft Industrial Estate New Road Attleborough Norfolk NR17 1YE à Central Square 29 Wellington Street Leeds West Yorkshire LS1 4DL le 14 sept. 2016

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution extraordinaire pour la liquidation au 11 août 2016

    LRESEX

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 nov. 2015 avec liste complète des actionnaires

    14 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital13 janv. 2016

    État du capital au 13 janv. 2016

    • Capital: GBP 13,889,684
    SH01

    Comptes annuels établis au 28 déc. 2014

    19 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 nov. 2014 avec liste complète des actionnaires

    13 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital03 janv. 2015

    État du capital au 03 janv. 2015

    • Capital: GBP 8,405,766
    SH01

    Comptes annuels établis au 29 déc. 2013

    19 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 nov. 2013 avec liste complète des actionnaires

    14 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital03 déc. 2013

    État du capital au 03 déc. 2013

    • Capital: GBP 8,405,766
    SH01

    Comptes annuels établis au 30 déc. 2012

    16 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 05 nov. 2012 avec liste complète des actionnaires

    14 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 25 déc. 2011

    16 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 18 oct. 2011 avec liste complète des actionnaires

    14 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 26 déc. 2010

    16 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 18 oct. 2010

    14 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 27 déc. 2009

    16 pagesAA

    Cessation de la nomination de Alastair Ferguson en tant que secrétaire

    2 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Russell Cawtheray en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Ian Robinson en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de William Buchanan en tant que directeur

    2 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de GRS PUB INVESTMENTS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    FERGUSON, Alastair William
    Haverscroft Industrial Estate
    New Road
    NR17 1YE Attleborough
    31
    Norfolk
    Secrétaire
    Haverscroft Industrial Estate
    New Road
    NR17 1YE Attleborough
    31
    Norfolk
    British146760250001
    LELLO, Graham
    91a Haverhill Road
    Balham
    SW12 0HE London
    Secrétaire
    91a Haverhill Road
    Balham
    SW12 0HE London
    South African97505870001
    THORNTON, Howard
    3 Kestrel Court
    Reedham
    NR13 3UH Norwich
    Norfolk
    Secrétaire
    3 Kestrel Court
    Reedham
    NR13 3UH Norwich
    Norfolk
    British149837760001
    WESTLEX REGISTRARS LIMITED
    Summit House 12 Red Lion Square
    WC1R 4QD London
    Secrétaire désigné
    Summit House 12 Red Lion Square
    WC1R 4QD London
    900030650001
    BUCHANAN, William Arthur Neil
    3 Westerton Court
    Clarkston
    G76 8NG Glasgow
    Lanarkshire
    Administrateur
    3 Westerton Court
    Clarkston
    G76 8NG Glasgow
    Lanarkshire
    United KingdomBritish67066450003
    CAWTHERAY, Russell
    8 Shears Crescent
    CO5 8AR West Mersea
    Essex
    Administrateur
    8 Shears Crescent
    CO5 8AR West Mersea
    Essex
    British124176180001
    CROWTHER, Mark
    Randwick House
    5 Bridge Street
    NN14 3ET Brigstock
    Northamptonshire
    Administrateur
    Randwick House
    5 Bridge Street
    NN14 3ET Brigstock
    Northamptonshire
    British104967480001
    GUNDRY, Richard
    Holgate Farm 29 The Street
    Bunwell
    NR16 1NA Norwich
    Norfolk
    Administrateur
    Holgate Farm 29 The Street
    Bunwell
    NR16 1NA Norwich
    Norfolk
    British107010490001
    KENNEDY, Samual Edward
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square
    West Yorkshire
    Administrateur
    29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    Central Square
    West Yorkshire
    EnglandBritish149343140001
    ROBINSON, Ian George
    74 Brookmans Avenue
    Brookmans Park
    AL9 7QQ Hatfield
    Hertfordshire
    Administrateur
    74 Brookmans Avenue
    Brookmans Park
    AL9 7QQ Hatfield
    Hertfordshire
    EnglandBritish57975730001
    THOMSON, Robert Keith Finlay
    92 Tebworth Road
    LU7 9QH Wingfield
    Hill Copse
    Administrateur
    92 Tebworth Road
    LU7 9QH Wingfield
    Hill Copse
    United KingdomBritish51167890002
    THORNTON, Howard
    3 Kestrel Court
    Reedham
    NR13 3UH Norwich
    Norfolk
    Administrateur
    3 Kestrel Court
    Reedham
    NR13 3UH Norwich
    Norfolk
    EnglandBritish149837760001
    WILSON, Andrew Stephen
    5 Court Lane Gardens
    Dulwich
    SE21 7DZ London
    Administrateur
    5 Court Lane Gardens
    Dulwich
    SE21 7DZ London
    United KingdomBritish82667700001
    WESTLEX NOMINEES LIMITED
    Summit House
    12 Red Lion Square
    WC1R 4QD London
    Administrateur
    Summit House
    12 Red Lion Square
    WC1R 4QD London
    111785270001

    GRS PUB INVESTMENTS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Supplemental legal charge
    Créé le 11 août 2009
    Livré le 20 août 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any obligor to the finance parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Its right title and interest in and to the legally mortgaged property wheatsheaf inn church road tattingstone ipswich t/n SK95910.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation Limited
    Transactions
    • 20 août 2009Enregistrement d'une charge (395)
    Supplemental legal charge
    Créé le 03 sept. 2007
    Livré le 18 sept. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any obligor to the finance parties (or ny of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    L/H property k/a mermaid delamore road handforth wilmslow t/no CH424877. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC, Acting Through Its London Branch as Security Agent for Itselfand the Other Finance Parties (The Security Agent)
    Transactions
    • 18 sept. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Deed of charge over shares
    Créé le 13 avr. 2007
    Livré le 30 avr. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    First fixed legal charge all of its present and future rights,title and interest in and to the scheduled securities. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC
    Transactions
    • 30 avr. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Supplemental legal charge
    Créé le 13 avr. 2007
    Livré le 30 avr. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H angel west yorkshire t/no WYK520493,f/h barristers west yorkshire t/no WYK501088,f/h bridge tavern hampshire t/no HP543335 (for details of further properties charged please refer to form 395). see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC (The "Security Agent")
    Transactions
    • 30 avr. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Supplemental legal charge
    Créé le 19 mars 2007
    Livré le 29 mars 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due by any obligor to the finance parties (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Bird in hand main road westhay glastonbury f/h t/n ST163193. The fox inn fox lane souldern bicester f/h t/n ON248144. New harp inn hoarwithy hereford t/h t/n HW171880. For further details of property charged please refer to form 395.. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC as Security Agent for Itself and the Other Finance Parties
    Transactions
    • 29 mars 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Supplemental legal charge
    Créé le 21 déc. 2006
    Livré le 28 déc. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H albert hotel 75 buxton road disley stockport t/no CH359630,f/h alma george street newcastle under lyme t/no SF407098,f/h anchor inn burton road streethay lichfield staffs t/no SF344977 (for details of further properties charged please refer to form 395). see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC (The "Security Agent")
    Transactions
    • 28 déc. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Assignation of rental income created 5TH january 2007 and
    Créé le 19 déc. 2006
    Livré le 10 janv. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any obligor to the finance parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The right title and interest present and future in and to the rent and all other monies.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC as Security Agent and Trustee for the Finance Parties (Thesecurity Agent)
    Transactions
    • 10 janv. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Assignation of rental income created 5TH january 2007 and
    Créé le 19 déc. 2006
    Livré le 10 janv. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any obligor to the finance parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The right title and interest present and future in and to the rent and all other monies.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC as Security Agent and Trustee for the Finance Parties (Thesecurity Agent)
    Transactions
    • 10 janv. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 22 december 2006 and
    Créé le 19 déc. 2006
    Livré le 05 janv. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any obligor to the finance parties or any of them on any account under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The inn, 18 shawton road, chapelton, strathaven.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC as Security Agent and Trustee for the Finance Parties (Thesecurity Agent)
    Transactions
    • 05 janv. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Standard security which was presented for registration in scotland on 22 december 2006 and
    Créé le 19 déc. 2006
    Livré le 05 janv. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any obligor to the finance parties or any of them on any account under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The swan inn, 62 lochinvar road cumbernauld.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC as Security Agent and Trustee for the Finance Parties (Thesecurity Agent)
    Transactions
    • 05 janv. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 30 nov. 2006
    Livré le 06 déc. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any obligor to the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Anchor inn fore street chudleigh knighton f/h t/n DN318739 bell inn 180 drew street brixham f/h t/n DN313236 cheddar valley inn tusker street wells f/h t/n ST89453. For further details of property charged please refer to form 395. the security assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC (The "Security Agent")
    Transactions
    • 06 déc. 2006Enregistrement d'une charge (395)

    GRS PUB INVESTMENTS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    19 sept. 2018Dissolved on
    11 août 2016Commencement of winding up
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    David Christian Chubb
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    practitioner
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Lyn L Vardy
    Central Square 8th Floor, 29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    practitioner
    Central Square 8th Floor, 29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0