SOUTHERN CROSS OPCO LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | SOUTHERN CROSS OPCO LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 05895851 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Oui |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe SOUTHERN CROSS OPCO LIMITED ?
Adresse du siège social | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de SOUTHERN CROSS OPCO LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 30 sept. 2010 |
Quels sont les derniers dépôts pour SOUTHERN CROSS OPCO LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Francis Declan Finbar Tempany Mccormack en tant que secrétaire le 09 oct. 2012 | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Avis d'achèvement de l'accord volontaire | 6 pages | 1.4 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Timothy James Bolot en tant que directeur le 17 août 2012 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 03 août 2012 avec liste complète des actionnaires | 4 pages | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Avis au registre des sociétés de l'accord volontaire prenant effet | 4 pages | 1.1 | ||||||||||
legacy | 3 pages | MG02 | ||||||||||
legacy | 5 pages | MG04 | ||||||||||
legacy | 4 pages | MG04 | ||||||||||
Cessation de la nomination de William James Buchan en tant que directeur le 15 nov. 2011 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de David Andrew Smith en tant que directeur le 01 nov. 2011 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Stephen Jonathan Taylor en tant qu'administrateur le 26 oct. 2011 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr Timothy James Bolot en tant qu'administrateur le 26 oct. 2011 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 03 août 2011 avec liste complète des actionnaires | 3 pages | AR01 | ||||||||||
legacy | 8 pages | MG01 | ||||||||||
legacy | 7 pages | MG01 | ||||||||||
Nomination de Mr Francis Declan Finbar Tempany Mccormack en tant que secrétaire | 1 pages | AP03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de William Mcleish en tant que secrétaire | 1 pages | TM02 | ||||||||||
Comptes annuels établis au 30 sept. 2010 | 28 pages | AA | ||||||||||
Cessation de la nomination de Richard Midmer en tant que directeur | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr David Andrew Smith en tant qu'administrateur | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 03 août 2010 avec liste complète des actionnaires | 3 pages | AR01 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 3 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
|
Qui sont les dirigeants de SOUTHERN CROSS OPCO LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAYLOR, Stephen Jonathan | Administrateur | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | Director | 163496070001 | ||||
MCCORMACK, Francis Declan Finbar Tempany | Secrétaire | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | 158661380001 | |||||||
MCLEISH, William David | Secrétaire | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | British | 168970640001 | ||||||
BOLOT, Timothy James | Administrateur | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | Director | 107837080002 | ||||
BUCHAN, William James | Administrateur | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | England | British | Director | 79917240001 | ||||
COLVIN, William | Administrateur | Senang Pyrford Woods Road GU22 8QR West Byfleet Surrey | United Kingdom | British | Director | 51697890003 | ||||
FARMER, Nicholas John | Administrateur | 62 Freshwater Close Great Sankey WA5 3PU Warrington Cheshire | United Kingdom | British | Director | 124228290001 | ||||
FINNIS, Pam | Administrateur | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | Director | 133719530001 | ||||
FOULKES, Kamma | Administrateur | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | Director | 111188390002 | ||||
GEE, Andrew Anthony Edward | Administrateur | 83a Sutherland Avenue TN16 3HG Biggin Hill Kent | England | British | Director | 93592160001 | ||||
HEAPS, Ann | Administrateur | 8 Oakwood Close BL8 1DD Bury Lancashire | British | Director | 124068050001 | |||||
LOCK, Jason David | Administrateur | 32 Monkton Rise TS14 6BG Guisborough Chessington House | England | British | Director | 144822040001 | ||||
MACINTOSH, Michael | Administrateur | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | Director | 137864880001 | ||||
MALHAM, Janette | Administrateur | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | Director | 91088900004 | ||||
MCKEEVER, Pauline Ann | Administrateur | 40 Pine Place G5 0BX Glasgow | Britain | British | Director | 91521130001 | ||||
MIDMER, Richard Neil | Administrateur | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | England | British | Director | 110640170001 | ||||
MURPHY, John | Administrateur | 4 Lochend Road KA10 6JJ Troon | United Kingdom | British | Director | 26177180004 | ||||
POYNTON, Ellen | Administrateur | Whiteoaks 10 St Richards Close, Wychbold WR9 7PP Droitwich | United Kingdom | British | Director | 89071020004 | ||||
PRESTON, Mary | Administrateur | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | Director | 124068010001 | ||||
RUTTER, Christopher | Administrateur | 15 The Dell DL14 7HJ Bishop Auckland County Durham | British | Director | 103588940001 | |||||
SCOTT, Philip Henry | Administrateur | The Old Vicarage Newgate DL12 8NW Barnard Castle County Durham | England | British | Director | 174231320001 | ||||
SIZER, Graham Kevin | Administrateur | Old Salutation Barn Low Street Little Fencote DL7 9LR Northallerton | England | British | Director | 77274540003 | ||||
SMITH, David Andrew, Mr. | Administrateur | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | United Kingdom | British | Director | 147997950001 | ||||
WHITAKER, Philip Alan | Administrateur | Southgate House, Archer Street Darlington DL3 6AH County Durham | England | British | Director | 123906000001 |
SOUTHERN CROSS OPCO LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
Standard security executed on 6 may 2011 | Créé le 16 mai 2011 Livré le 27 mai 2011 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from each obligor to all or any of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions The security subjects being the subjects k/a and forming westerfield care home high calside paisley t/n REN125643. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Supplemental legal mortgage | Créé le 06 mai 2011 Livré le 20 mai 2011 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions 1-6 (inclusive,8,9 and 11-14 (inclusive) yohden hall bungalows hesleden road blackhall t/no DU303802 see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Standard security | Créé le 24 déc. 2009 Livré le 25 janv. 2010 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from each obligor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions The lease in respect of 6 sea road methil leven t/n FFE92154 see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Standard security | Créé le 11 déc. 2008 Livré le 19 déc. 2008 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions The lease between dolphin properties (scotland) limited, southern cross opco limited and southern cross healthcare group limited t/no PTH33157 see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Deed of accession and charge | Créé le 21 août 2008 Livré le 02 sept. 2008 | En cours | Montant garanti All monies due or to become due from each obligor to all or any of the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
SOUTHERN CROSS OPCO LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Corporate voluntary arrangement (CVA) |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0