EAST POINT NOMINEES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéEAST POINT NOMINEES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 05901302
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de EAST POINT NOMINEES LIMITED ?

    • Société non marchande non marchande (74990) / Activités spécialisées, scientifiques et techniques

    Où se situe EAST POINT NOMINEES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    4th Floor
    7-10 Chandos Street
    W1G 9DQ London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de EAST POINT NOMINEES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    PAVF SECOND NOMINEES 6 LIMITED09 août 200609 août 2006

    Quels sont les derniers comptes de EAST POINT NOMINEES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 août 2014

    Quels sont les derniers dépôts pour EAST POINT NOMINEES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Cessation de la nomination de James Jonathan Good en tant que directeur le 10 juil. 2013

    1 pagesTM01

    Satisfaction de la charge 059013020015 en totalité

    4 pagesMR04

    Déclaration annuelle jusqu'au 09 août 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital21 août 2015

    État du capital au 21 août 2015

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Inscription de la charge 059013020015, créée le 04 juin 2015

    21 pagesMR01
    Annotations
    DateAnnotation
    03 juil. 2015Other The certified copy instrument associated with this transaction contains some elements which are in colour and/or larger than A4. At present, Companies House does not provide colour or larger images through our output services; therefore some elements may be illegible. If you would like to view a copy of the instrument, please call 02920 381367.

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 août 2014

    5 pagesAA

    Nomination de Mr Rupert Charles Thomas Sheldon en tant qu'administrateur le 01 juin 2015

    2 pagesAP01

    Déclaration annuelle jusqu'au 09 août 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital26 sept. 2014

    État du capital au 26 sept. 2014

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 août 2013

    8 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 09 août 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital27 sept. 2013

    État du capital au 27 sept. 2013

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Nomination de Mr James Jonathan Good en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr James Jonathan Good en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Changement d'adresse du siège social de * 7-10 Chandos Street London W1G 9DQ United Kingdom* le 21 mai 2013

    1 pagesAD01

    Inscription de la charge 059013020014

    14 pagesMR01
    Annotations
    DateAnnotation
    29 avr. 2013This document has been informally corrected in accordance with instructions under section 1075 of the Companies Act 2006

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 août 2012

    5 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 09 août 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 août 2011

    5 pagesAA

    Cessation de la nomination de Rupert Sheldon en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Cessation de la nomination de Rupert Sheldon en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Alexander Price en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Changement d'adresse du siège social de * Time & Life Building 1 Bruton Street London W1J 6TL* le 30 sept. 2011

    1 pagesAD01

    Certificat de changement de nom

    Company name changed pavf second nominees 6 LIMITED\certificate issued on 27/09/11
    3 pagesCERTNM
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    change-of-name27 sept. 2011

    Résolution de changement de nom

    RES15
    change-of-name27 sept. 2011

    Changement de nom" par résolution

    NM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 09 août 2011 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    Qui sont les dirigeants de EAST POINT NOMINEES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    DIGBY-BELL, Christopher Harvey
    Hurst Mill Cottage
    Ram Lane
    TN25 4LT Ashford
    Kent
    Administrateur
    Hurst Mill Cottage
    Ram Lane
    TN25 4LT Ashford
    Kent
    EnglandBritish75286240029
    GOOD, James Jonathan
    Bruton Street
    W1J 6TL Mayfair
    Time & Life Building 1
    London
    United Kingdom
    Administrateur
    Bruton Street
    W1J 6TL Mayfair
    Time & Life Building 1
    London
    United Kingdom
    United KingdomBritish99624020002
    PALMER, Raymond John Stewart, Mr.
    3 Palace Gardens Terrace
    W8 4SA London
    Administrateur
    3 Palace Gardens Terrace
    W8 4SA London
    United KingdomBritish75286170005
    SHELDON, Rupert Charles Thomas
    1 Bruton Street 6th Floor
    W1J 6TL London
    Time & Life Building
    United Kingdom
    Administrateur
    1 Bruton Street 6th Floor
    W1J 6TL London
    Time & Life Building
    United Kingdom
    United KingdomBritish110093600003
    SHELDON, Rupert Charles Thomas
    Grandison Road
    SW11 6LN London
    104
    Secrétaire
    Grandison Road
    SW11 6LN London
    104
    British110093600002
    GOOD, James Jonathan
    Bruton Street
    W1J 6TL Mayfair
    Time & Life Building 1
    London
    United Kingdom
    Administrateur
    Bruton Street
    W1J 6TL Mayfair
    Time & Life Building 1
    London
    United Kingdom
    United KingdomBritish99624020002
    PRICE, Alexander David William
    52a Wimbledon Park Road
    SW18 5SH London
    Administrateur
    52a Wimbledon Park Road
    SW18 5SH London
    United KingdomBritish76405270003
    SHELDON, Rupert Charles Thomas
    Grandison Road
    SW11 6LN London
    104
    Administrateur
    Grandison Road
    SW11 6LN London
    104
    United KingdomBritish110093600003

    EAST POINT NOMINEES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 04 juin 2015
    Livré le 25 juin 2015
    Totalement satisfaite
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Aew UK Reit PLC
    Transactions
    • 25 juin 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 09 déc. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 09 avr. 2013
    Livré le 29 avr. 2013
    En cours
    Brève description
    Notification of addition to or amendment of charge.
    Débiteur agissant en tant que fiduciaire nu: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 29 avr. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    Amendment agreement(legal charge)
    Créé le 20 déc. 2006
    Livré le 23 déc. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the trustee to the chargee for themselves and in their capacity as trustees and for the beneficiaries of any kind on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All that f/h land on the south side of sandy lane west littlemore t/n ON83713 all fixtures and fittings, plant machinery, furniture furnishings, goodwill. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 23 déc. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Amendment agreement(debenture)
    Créé le 20 déc. 2006
    Livré le 23 déc. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the trustee to the chargee for itself and in its capacity as trustees and for the beneficiaries of any kind on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 23 déc. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Amendment agreement(charge of deposit)
    Créé le 20 déc. 2006
    Livré le 23 déc. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the depositor to the chargee for themselves and in their capacity as trustees and for the beneficiaries of any kind on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All deposits credited to account number 11271505,. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 23 déc. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Amendment agreement(legal charge)
    Créé le 20 déc. 2006
    Livré le 23 déc. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the trustee to the chargee for themselves and in their capacity as trustees and for the beneficiaries of any kind on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All that f/h land on the south side of sandy lane west littlemore (also known as) meridien house oxford technology centre peters way sandy lane west oxford t/n ON119934 all fixtures and fittings, plant machinery, furniture furnishings, goodwill,. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 23 déc. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Amendment agreement(legal charge)
    Créé le 20 déc. 2006
    Livré le 23 déc. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the trustee to the chargee for themselves and in their capacity as trustees and for the beneficiaries of any kind on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All that f/h land being sandford gate sandylane west littlemore oxford t/n ON168644, all fixtures and fittings, plant machinery, furniture furnishings, goodwill,. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 23 déc. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Amendment agreement(legal charge)
    Créé le 20 déc. 2006
    Livré le 23 déc. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the trustee to the chargee for themselves and in their capacity as trustees and for the beneficiaries of any kind on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All that f/h land being orion house oxford technology centre peter's way sandy lane west oxford t/n ON122460, all fixtures and fittings, plant machinery, furniture furnishings, goodwill,. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 23 déc. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 20 déc. 2006
    Livré le 22 déc. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the trustee to the chargee for themselves and in their capacity as trustees and for the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H land and buildings on the south side of eastern by-pass road, littlemore (also k/a heritage gate, sandy lane west, oxford) t/no ON43833, by way of fixed charge all plant, machinery, fixtures, fittings, furniture, equipment, implements & utensils. The goodwill of any business carried on at the property & the proceeds of any insurance affecting the property or assets. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 22 déc. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Charge of deposit
    Créé le 10 nov. 2006
    Livré le 23 nov. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and frontier estates (oxford) limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Assigns the deposit. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 23 nov. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 10 nov. 2006
    Livré le 23 nov. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and frontier estates (oxford) limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H land on the south side of sandy lane west littlemore (also k/a meridian house oxford technology centre peter's way sandy lane west oxford t/no ON119934. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 23 nov. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 26 sept. 2006
    Livré le 04 oct. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the trustee to the chargee for itself and in its capacity as trustees and for the beneficiaries of any kind on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All that f/h land being sandford gate sandy lane west littlemore oxford t/n ON168644. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 04 oct. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 26 sept. 2006
    Livré le 04 oct. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the trustee to the chargee for itself and in its capacity as trustees and for the beneficiaries of any kind on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All that f/h land being beaumont house oxford technology centre sandy lane t/n ON83713. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 04 oct. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Legal charge
    Créé le 26 sept. 2006
    Livré le 04 oct. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the trustee to the chargee for itself and in its capacity as trustees and for the beneficiaries of any kind on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All that f/h land being orion house oxford technology centre peter's way sandy lane west oxford t/n ON122460. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 04 oct. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 25 sept. 2006
    Livré le 04 oct. 2006
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the trustee to the chargee for itself and in its capacity as trustees and for the beneficiaries of any kind on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Beaumont house oxford technology centre sandy lane t/n ON132384, land and building on the south side of sandy lane west littlemore t/n ON83713, orion house oxford technology centre peters way sandy lane west oxford t/n ON122460, sandford gate sandy lane west littemore oxford, t/n ON168644,. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 04 oct. 2006Enregistrement d'une charge (395)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0