STM PACKAGING GROUP LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéSTM PACKAGING GROUP LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 05919785
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de STM PACKAGING GROUP LIMITED ?

    • services de pré-presse et de pré-média (18130) / Industries manufacturières

    Où se situe STM PACKAGING GROUP LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Anglia House 6 Central Avenue St Andrews Business Park
    Thorpe St Andrews
    NR7 0HR Norwich
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de STM PACKAGING GROUP LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    STM POLYTHENE LIMITED25 oct. 200625 oct. 2006
    PF NEWCO LIMITED11 oct. 200611 oct. 2006
    DE FACTO 1414 LIMITED30 août 200630 août 2006

    Quels sont les derniers comptes de STM PACKAGING GROUP LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mai 2017

    Quels sont les derniers dépôts pour STM PACKAGING GROUP LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    12 pagesLIQ14

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 15 mars 2023

    13 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 15 mars 2022

    12 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 15 mars 2021

    17 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 15 mars 2020

    13 pagesLIQ03

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Avis de transition de l'administration à la liquidation volontaire des créanciers

    22 pagesAM22

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    20 pagesAM10

    Cessation de la nomination de Mark Lawrence en tant que directeur le 11 janv. 2019

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Clare Marie Dutton en tant que directeur le 11 janv. 2019

    1 pagesTM01

    Résultat de la réunion des créanciers

    7 pagesAM07

    Déclaration des affaires avec le formulaire AM02SOA

    8 pagesAM02

    Déclaration des affaires avec le formulaire AM02SOC

    6 pagesAM02

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    45 pagesAM03

    Changement d'adresse du siège social de 21-23 Concorde Road Norwich Norfolk NR6 6BJ à Anglia House 6 Central Avenue St Andrews Business Park Thorpe St Andrews Norwich NR7 0HR le 29 août 2018

    2 pagesAD01

    Nomination d'un administrateur

    3 pagesAM01

    Cessation de la nomination de Graham Edward Hough en tant que directeur le 16 juil. 2018

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Graham Edward Hough en tant que secrétaire le 16 juil. 2018

    1 pagesTM02

    Nomination de Mrs Clare Marie Dutton en tant qu'administrateur le 08 janv. 2018

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Mark Lawrence en tant qu'administrateur le 08 janv. 2018

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Timothy Simon Gregory en tant que directeur le 08 janv. 2018

    1 pagesTM01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 mai 2017

    14 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 07 août 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 mai 2016

    9 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de STM PACKAGING GROUP LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    EVANS, Esther Katharine
    St Andrews Business Park
    Thorpe St Andrews
    NR7 0HR Norwich
    Anglia House 6 Central Avenue
    Administrateur
    St Andrews Business Park
    Thorpe St Andrews
    NR7 0HR Norwich
    Anglia House 6 Central Avenue
    EnglandBritishCompany Director119251810003
    BIDDULPH, Michael
    Flat 5
    73 Randolph Avenue
    W9 1DW London
    Secrétaire
    Flat 5
    73 Randolph Avenue
    W9 1DW London
    BritishDirector111572090001
    BROWN, Deborah Kathleen Susan
    21-23 Concorde Road
    Norwich
    NR6 6BJ Norfolk
    Secrétaire
    21-23 Concorde Road
    Norwich
    NR6 6BJ Norfolk
    British165434750001
    DICKS, Mark David
    Castle Rising Road
    South Wootton
    PE30 3JA King's Lynn
    45b
    Norfolk
    England
    Secrétaire
    Castle Rising Road
    South Wootton
    PE30 3JA King's Lynn
    45b
    Norfolk
    England
    BritishAccountant51355010004
    HOUGH, Graham Edward
    21-23 Concorde Road
    Norwich
    NR6 6BJ Norfolk
    Secrétaire
    21-23 Concorde Road
    Norwich
    NR6 6BJ Norfolk
    167813710001
    TRAVERS SMITH SECRETARIES LIMITED
    10 Snow Hill
    EC1A 2AL London
    Secrétaire
    10 Snow Hill
    EC1A 2AL London
    38590450001
    BIDDULPH, Michael Thomas
    21-23 Concorde Road
    Norwich
    NR6 6BJ Norfolk
    Administrateur
    21-23 Concorde Road
    Norwich
    NR6 6BJ Norfolk
    EnglandBritishCompany Director186302070001
    BIDDULPH, Michael
    Flat 5
    73 Randolph Avenue
    W9 1DW London
    Administrateur
    Flat 5
    73 Randolph Avenue
    W9 1DW London
    United KingdomBritishDirector111572090001
    DUTTON, Clare
    St Andrews Business Park
    Thorpe St Andrews
    NR7 0HR Norwich
    Anglia House 6 Central Avenue
    Administrateur
    St Andrews Business Park
    Thorpe St Andrews
    NR7 0HR Norwich
    Anglia House 6 Central Avenue
    EnglandBritishDirector244255780001
    GREGORY, Timothy Simon
    21-23 Concorde Road
    Norwich
    NR6 6BJ Norfolk
    Administrateur
    21-23 Concorde Road
    Norwich
    NR6 6BJ Norfolk
    EnglandBritishDirector195106060001
    HOUGH, Graham Edward
    21-23 Concorde Road
    Norwich
    NR6 6BJ Norfolk
    Administrateur
    21-23 Concorde Road
    Norwich
    NR6 6BJ Norfolk
    EnglandBritishAccountant167813680002
    HOWARD, Paul
    56 Roseworth Avenue
    Orrell Park
    L9 8HF Liverpool
    Merseyside
    Administrateur
    56 Roseworth Avenue
    Orrell Park
    L9 8HF Liverpool
    Merseyside
    BritishCompany Director116466360001
    LAWRENCE, Mark
    St Andrews Business Park
    Thorpe St Andrews
    NR7 0HR Norwich
    Anglia House 6 Central Avenue
    Administrateur
    St Andrews Business Park
    Thorpe St Andrews
    NR7 0HR Norwich
    Anglia House 6 Central Avenue
    EnglandBritishDirector244255550001
    MCKINLAY, Sebastian Mark Sinclair
    31 Wincanton Road
    SW18 5TZ London
    Administrateur
    31 Wincanton Road
    SW18 5TZ London
    EnglandBritishFund Manager105432940001
    NEWMAN, John Joseph
    26 Floral Wood
    L17 7HR Liverpool
    Merseyside
    Administrateur
    26 Floral Wood
    L17 7HR Liverpool
    Merseyside
    BritishCompany Director33123260002
    OPPERMAN, Peter Adam Ernest
    Nether Doyley
    Hurstbourne Tarrant
    SP11 0DW Andover
    Hampshire
    Administrateur
    Nether Doyley
    Hurstbourne Tarrant
    SP11 0DW Andover
    Hampshire
    EnglandBritishDirector56715640005
    WILSON, Paul
    Tubbs Hole
    Coldharbour Road
    TN11 8EX Penshurst
    Kent
    Administrateur
    Tubbs Hole
    Coldharbour Road
    TN11 8EX Penshurst
    Kent
    EnglandBritishBusinessman100144280001
    TRAVERS SMITH LIMITED
    10 Snow Hill
    EC1A 2AL London
    Administrateur
    10 Snow Hill
    EC1A 2AL London
    47670880001
    TRAVERS SMITH SECRETARIES LIMITED
    10 Snow Hill
    EC1A 2AL London
    Administrateur
    10 Snow Hill
    EC1A 2AL London
    38590450001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur STM PACKAGING GROUP LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Estigra Limited
    Concorde Road
    NR6 6BJ Norwich
    21-23 Concorde Road
    England
    06 avr. 2016
    Concorde Road
    NR6 6BJ Norwich
    21-23 Concorde Road
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act 2016
    Lieu d'enregistrementCompanies House - England & Wales
    Numéro d'enregistrement09374640
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    STM PACKAGING GROUP LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 21 nov. 2011
    Livré le 07 déc. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Wendy Dodge
    Transactions
    • 07 déc. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 22 déc. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 21 nov. 2011
    Livré le 07 déc. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Nicholas Robin Cansdale and Mark Stephen Dodge
    Transactions
    • 07 déc. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 22 déc. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 21 nov. 2011
    Livré le 25 nov. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Nether Doyley Limited, Michael Biddulph, Paul Wilson, Tylan Bahcheli and Esther Evans
    Transactions
    • 25 nov. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 22 déc. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 30 nov. 2009
    Livré le 03 déc. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Nether Doyley Limited
    Transactions
    • 03 déc. 2009Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 22 déc. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal assignment
    Créé le 29 sept. 2009
    Livré le 01 oct. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any credit balance due to the company under condition 13 of the agreement for the purchase of debts between the company and the bank.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 01 oct. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    Floating charge (all assets)
    Créé le 28 août 2008
    Livré le 30 août 2008
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of floating charge all the undertaking of the company and all assets whatsoever and wheresoever including stock in trade and uncalled capital but excluding any debts and associated rights relating thereto.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Invoice Finance (UK) LTD ("the Security Holder")
    Transactions
    • 30 août 2008Enregistrement d'une charge (395)
    Fixed charge on purchased debts which fail to vest
    Créé le 28 août 2008
    Livré le 30 août 2008
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of fixed equitable charge all debts purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to an agreement for the purchase of debts between the security holder and the company (including associated rights relating thereto) which fail to vest effectively or absolutely in the security holder for any reason.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Invoice Finance (UK) LTD ("the Security Holder")
    Transactions
    • 30 août 2008Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 06 juil. 2007
    Livré le 11 juil. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 11 juil. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Rent deposit deed
    Créé le 30 mars 2007
    Livré le 13 avr. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    £7,500.00 and any sums from time to time deposited in a separate interest earning deposit account including any interest earned thereon and retained in the account.
    Personnes ayant droit
    • Gmv Three Limited
    Transactions
    • 13 avr. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 déc. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Rent deposit deed
    Créé le 30 mars 2007
    Livré le 13 avr. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    £7,500.00 and any sums from time to time deposited in a separate interest earning deposit account including any interest earned thereon and retained in the account.
    Personnes ayant droit
    • Gmv Three Limited
    Transactions
    • 13 avr. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 déc. 2014Satisfaction d'une charge (MR04)

    STM PACKAGING GROUP LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    13 juil. 2018Administration started
    16 mars 2019Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Matthew Robert Howard
    Anglia House 6 Central Avenue St Andrews Business Park
    Thorpe St Andrew
    NR7 0HR Norwich
    practitioner
    Anglia House 6 Central Avenue St Andrews Business Park
    Thorpe St Andrew
    NR7 0HR Norwich
    Stuart Morton
    Anglia House 6 Central Avenue St Andrews Business Park
    Thorpe St Andrew
    NR7 0HR Norwich
    practitioner
    Anglia House 6 Central Avenue St Andrews Business Park
    Thorpe St Andrew
    NR7 0HR Norwich
    2
    DateType
    02 nov. 2023Due to be dissolved on
    16 mars 2019Commencement of winding up
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Stuart Morton
    Anglia House 6 Central Avenue St Andrews Business Park
    Thorpe St Andrew
    NR7 0HR Norwich
    practitioner
    Anglia House 6 Central Avenue St Andrews Business Park
    Thorpe St Andrew
    NR7 0HR Norwich
    Matthew Robert Howard
    Anglia House 6 Central Avenue St Andrews Business Park
    Thorpe St Andrew
    NR7 0HR Norwich
    practitioner
    Anglia House 6 Central Avenue St Andrews Business Park
    Thorpe St Andrew
    NR7 0HR Norwich

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0