OSPREY PUBS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéOSPREY PUBS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 05949910
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de OSPREY PUBS LIMITED ?

    • Restaurants avec licence (56101) / Hébergement et restauration
    • Débits de boissons et bars (56302) / Hébergement et restauration

    Où se situe OSPREY PUBS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de OSPREY PUBS LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    INHOCO 4169 LIMITED28 sept. 200628 sept. 2006

    Quels sont les derniers comptes de OSPREY PUBS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au28 mai 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour OSPREY PUBS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 29 mai 2018

    9 pagesLIQ03

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    12 pagesLIQ13

    L'adresse d'inspection du registre a été modifiée de Milton Gate 60 Chiswell Street London EC1Y 4AG United Kingdom à C/O Admiral Taverns (Chester) Limited Milton Gate 60 Chiswell Street London EC1Y 4AG

    2 pagesAD02

    Changement d'adresse du siège social de 150 Aldersgate Street London EC1A 4EJ à 1 More London Place London SE1 2AF le 14 juil. 2017

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Déclaration de solvabilité

    5 pagesLIQ01

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 30 mai 2017

    LRESSP

    État du capital après une attribution d'actions au 22 mai 2017

    • Capital: GBP 8,046,398.00
    4 pagesSH01

    Satisfaction de la charge 7 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 10 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 059499100019 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 059499100018 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 059499100017 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 8 en totalité

    4 pagesMR04

    Résolutions

    Resolutions
    3 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution d'attribution de valeurs mobilières

    RES10
    capital

    Résolution de suppression des droits de préemption

    RES11
    resolution

    Résolution de capitalisation ou d'émission d'actions gratuites

    Sum of £6045398 is capitalised 22/05/2017
    RES14

    legacy

    2 pagesSH20

    État du capital au 30 mai 2017

    • Capital: GBP 1
    3 pagesSH19

    legacy

    2 pagesCAP-SS

    Résolutions

    Resolutions
    2 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    capital

    Résolution de réduction du capital social émis

    RES06

    Comptes annuels établis au 28 mai 2016

    22 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 28 sept. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes annuels établis au 30 mai 2015

    19 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 sept. 2015 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital05 oct. 2015

    État du capital au 05 oct. 2015

    • Capital: GBP 2,000,001
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 mai 2014

    19 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de OSPREY PUBS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    A G SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Secrétaire
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    90084920001
    CLIFFORD, Andrew Francis James
    Steam Mill Business Centre
    Steam Mill Street
    CH3 5AN Chester
    Suite H3
    United Kingdom
    Administrateur
    Steam Mill Business Centre
    Steam Mill Street
    CH3 5AN Chester
    Suite H3
    United Kingdom
    EnglandBritishProperty Director119327230001
    GEORGEL, Kevin Roger
    Steam Mill Street
    CH3 5AN Chester
    Suite 3 Steam Mill Business Centre
    Administrateur
    Steam Mill Street
    CH3 5AN Chester
    Suite 3 Steam Mill Business Centre
    United KingdomBritishManaging Director153480970001
    PEARSON, Glenn
    Steam Mill Business Centre
    Steam Mill Street
    CH3 5AN Chester
    Suite H3
    United Kingdom
    Administrateur
    Steam Mill Business Centre
    Steam Mill Street
    CH3 5AN Chester
    Suite H3
    United Kingdom
    United KingdomBritishAccountant Cfo123243570001
    D'ARCY, Lynne
    5 Winwick Park Avenue
    WA2 8XB Warrington
    Cheshire
    Administrateur
    5 Winwick Park Avenue
    WA2 8XB Warrington
    Cheshire
    United KingdomBritishCompany Director106840540001
    LANDESBERG, Alan
    Allingham Court
    44 The Bishops Avenue Hampstead
    N2 OBA London
    Flat 3,
    Administrateur
    Allingham Court
    44 The Bishops Avenue Hampstead
    N2 OBA London
    Flat 3,
    EnglandBritishCompany Director142883260001
    LANDESBERG, Gary Mitchell
    122 Wigmore Street
    W1U 3RX London
    Administrateur
    122 Wigmore Street
    W1U 3RX London
    United KingdomBritishDirector54137480002
    PAVELEY, Jonathan David, Dr
    Steam Mill Street
    CH3 5AN Chester
    Suite H3 Steam Mill Business Centre
    Administrateur
    Steam Mill Street
    CH3 5AN Chester
    Suite H3 Steam Mill Business Centre
    United KingdomBritishCompany Director100582600002
    PERCY, Andrew Graeme
    5 Carlton Avenue
    SK9 4EP Wilmslow
    Cheshire
    Administrateur
    5 Carlton Avenue
    SK9 4EP Wilmslow
    Cheshire
    BritishCompany Director53017070002
    ROSENBERG, David
    Green Verges
    Priory Drive
    HA7 3HL Stanmore
    Middlesex
    Administrateur
    Green Verges
    Priory Drive
    HA7 3HL Stanmore
    Middlesex
    EnglandBritishCompany Director2541410004
    ROSENBERG, Elliot Simon
    Brooklands 33 Linksway
    HA6 2XA Northwood
    Middlesex
    Administrateur
    Brooklands 33 Linksway
    HA6 2XA Northwood
    Middlesex
    EnglandBritishCompany Director2541420006
    INHOCO FORMATIONS LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Administrateur désigné
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    900006560001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur OSPREY PUBS LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Aldersgate Street
    EC1A 4EJ London
    150
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Aldersgate Street
    EC1A 4EJ London
    150
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légaleCompanies Act 2006
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement05949908
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.

    OSPREY PUBS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 09 oct. 2014
    Livré le 16 oct. 2014
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • U.S. Bank Trustees Limited (As Security Agent for the Beneficiaries)
    Transactions
    • 16 oct. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 07 juin 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 27 juin 2013
    Livré le 12 juil. 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Crown t/no ON233642. Kings head t/no SK142807. Tipperary t/no NGL675739. Wheatsheaf t/no WT105776. Notification of addition to or amendment of charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Admiral Taverns Bidco Limited
    Transactions
    • 12 juil. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 11 juil. 2014Satisfaction partielle d'une charge (MR04)
    • 11 juil. 2014Satisfaction partielle d'une charge (MR04)
    • 07 juin 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 27 juin 2013
    Livré le 09 juil. 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Notification of addition to or amendment of charge.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • U.S. Bank Trustees Limited (As Security Agent and Trustee for the Beneficiaries)
    Transactions
    • 09 juil. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 07 juin 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Supplemental legal mortgage, supplemental to a debenture dated 17 november 2009 and
    Créé le 22 avr. 2010
    Livré le 29 avr. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Tipperary 66 fleet street london t/n NGL675739.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC in Its Capacity as Security Trustee
    Transactions
    • 29 avr. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 27 déc. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Supplemental legal mortgage, supplemental to an inter-group debenture dated 17 november 2009 and
    Créé le 22 avr. 2010
    Livré le 29 avr. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Tipperary 66 fleet street london t/n NGL675739.
    Personnes ayant droit
    • Admiral Taverns Bidco Limited
    Transactions
    • 29 avr. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 27 déc. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    A supplemental legal mortgage
    Créé le 22 avr. 2010
    Livré le 29 avr. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Property k/a pitcher and piano 19 upper king street norwich t/no. NK241125 with full title guarantee all the right, title and interest, present and future in and to the relevant secured asset see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC in Its Capacity as Security Trustee
    Transactions
    • 29 avr. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 18 déc. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    A supplemental legal mortgage
    Créé le 22 avr. 2010
    Livré le 29 avr. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Property k/a pitcher and piano 19 upper king street norwich t/no. NK241125 with full title guarantee all the right, title and interest, present and future in and to the relevant secured asset see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Admiral Taverns Bidco Limited
    Transactions
    • 29 avr. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 03 nov. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 18 déc. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 17 nov. 2009
    Livré le 02 déc. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the secured parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H the admiral owen 8 high street sndwich t/no K713792, f/h the albert inn 162 darnall road sheffield t/no SYK314574, f/h the ipswich arms station hill bury st edmunds t/no SK124029, for details of further properties charged please refer to the form MG01 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC in Its Capacity as Security Trustee
    Transactions
    • 02 déc. 2009Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 11 août 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 11 août 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 11 août 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 11 août 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 11 août 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 11 août 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 11 août 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 11 août 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 11 août 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 07 sept. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 07 sept. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 07 sept. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 15 janv. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 15 janv. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 15 janv. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 15 janv. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 12 août 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 12 août 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 12 août 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 12 août 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 12 août 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 12 août 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 12 août 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 12 août 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 03 nov. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 03 nov. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 14 juil. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 14 juil. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 14 juil. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 17 juil. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 17 juil. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 17 juil. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 17 juil. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 17 juil. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 18 déc. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 18 déc. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 19 déc. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 19 déc. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 19 déc. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 19 déc. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 27 déc. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 17 nov. 2009
    Livré le 02 déc. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of first legal mortgage the original property: (for details of original property please refer to document image) and all estates or interests in f/h, l/h or commonhold property and which is owned by the chargor as at the date of the debenture, and in each case, all premises and fixtures on such property for the time being. By way of fixed charge all other estates or interests in f/h, l/h or commonhold property: the proceeds of sale of its secured property and all licences to enter on or use any secured property see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Admiral Taverns Bidco Limited
    Transactions
    • 02 déc. 2009Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 29 juil. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 29 juil. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 11 août 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 11 août 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 11 août 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 11 août 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 11 août 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 11 août 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 11 août 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 11 août 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 11 août 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 07 sept. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 07 sept. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 07 sept. 2010Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 15 janv. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 15 janv. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 15 janv. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 15 janv. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 12 août 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 12 août 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 12 août 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 12 août 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 12 août 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 12 août 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 12 août 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 12 août 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 03 nov. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 14 juil. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 14 juil. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 14 juil. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 17 juil. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 17 juil. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 17 juil. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 17 juil. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 17 juil. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 18 déc. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 18 déc. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 19 déc. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 19 déc. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 19 déc. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 19 déc. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    • 27 déc. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Rent deposit deed
    Créé le 08 avr. 2009
    Livré le 16 avr. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £50,000.00 due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    The company's interest in the deposit balance and all money from time to time withdrawn from the deposit balance in accordance with the rent deposit deed see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Mayor and Commonalty and Citizens of the City of London
    Transactions
    • 16 avr. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 juin 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 30 janv. 2009
    Livré le 07 févr. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 07 févr. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 02 déc. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Rent deposit deed
    Créé le 29 août 2008
    Livré le 03 sept. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The sum of £37,500 to be held on deposit see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Guy Wallis Morton, Peter Joseph Jeffcote, Christopher Alan Morris and Timothy William Jones
    Transactions
    • 03 sept. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 juin 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Rent deposit deed
    Créé le 21 déc. 2007
    Livré le 29 déc. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    £47,000.00 due or to become due
    Brèves mentions
    Charges its interest in the deposit account and all money from time to time withdrawn from the deposit account.
    Personnes ayant droit
    • Equity Partnerships (Osprey) Limited
    Transactions
    • 29 déc. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 juin 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 24 juil. 2007
    Livré le 04 août 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Irish Nationwide Building Society
    Transactions
    • 04 août 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 oct. 2008Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 02 déc. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 24 juil. 2007
    Livré le 04 août 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H admiral owen 8 high street sandwich t/n K713792 l/h jar bar whitehill way swindon t/n WT90133 l/h 19 upper king street norwich t/n NK241125 for further details of the properties charged please refer to form 395 any monies received or to be received. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Irish Nationwide Building Society
    Transactions
    • 04 août 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 oct. 2008Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 02 déc. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 24 juil. 2007
    Livré le 02 août 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital buildings fixtures plant and machinery for details of properties charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 02 août 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 oct. 2008Déclaration que tout ou partie de la propriété d'une charge flottante a été libérée (403b)
    • 02 déc. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 01 déc. 2006
    Livré le 14 déc. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 14 déc. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 sept. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 01 déc. 2006
    Livré le 07 déc. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Admiral owen - sandwich tenancy K713792, albert inn - darnell tenancy SYK314574, barlow mow - bedford tenancy BD177550 for details of further properties charged please refer to form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Irish Nationwide Building Society
    Transactions
    • 07 déc. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 sept. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 18 nov. 2006
    Livré le 24 nov. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Irish Nationwide Building Society
    Transactions
    • 24 nov. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 sept. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    OSPREY PUBS LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    30 mai 2017Commencement of winding up
    04 déc. 2018Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Derek Hyslop
    10 George Street
    EH2 2DZ Edinburgh
    practitioner
    10 George Street
    EH2 2DZ Edinburgh
    Colin Peter Dempster
    Ten George Street
    EH2 2DZ Edinburgh
    practitioner
    Ten George Street
    EH2 2DZ Edinburgh

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0