HANNOVER CAPITAL LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéHANNOVER CAPITAL LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 05949915
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de HANNOVER CAPITAL LIMITED ?

    • Hôtels et hébergement similaire (55100) / Hébergement et restauration
    • Débits de boissons et bars (56302) / Hébergement et restauration

    Où se situe HANNOVER CAPITAL LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Milton Gate
    60 Chiswell Street
    EC1Y 4AG London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de HANNOVER CAPITAL LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    INHOCO 4165 LIMITED28 sept. 200628 sept. 2006

    Quels sont les derniers comptes de HANNOVER CAPITAL LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 nov. 2014

    Quels sont les derniers dépôts pour HANNOVER CAPITAL LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 28 sept. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 sept. 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital28 sept. 2015

    État du capital au 28 sept. 2015

    • Capital: GBP 4
    SH01

    Comptes d'exonération totale établis au 30 nov. 2014

    10 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 sept. 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital01 oct. 2014

    État du capital au 01 oct. 2014

    • Capital: GBP 4
    SH01

    Comptes d'exonération totale établis au 30 nov. 2013

    11 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 sept. 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital01 oct. 2013

    État du capital au 01 oct. 2013

    • Capital: GBP 4
    SH01

    Comptes d'exonération totale établis au 30 nov. 2012

    12 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 sept. 2012 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01

    Cessation de la nomination de Alan Landesberg en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 30 nov. 2011

    13 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 sept. 2011 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Elliot Simon Rosenberg le 17 août 2011

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr David Rosenberg le 17 août 2011

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Alan Landesberg le 12 août 2011

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Alan Landesberg le 11 août 2011

    2 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 30 nov. 2010

    15 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 sept. 2010 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    Période comptable actuelle prolongée du 31 mai 2010 au 30 nov. 2010

    1 pagesAA01

    Comptes annuels établis au 31 mai 2009

    14 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 28 sept. 2009 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 mai 2008

    14 pagesAA

    Démission de l'auditeur

    1 pagesAUD

    Qui sont les dirigeants de HANNOVER CAPITAL LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    A G SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Secrétaire
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    90084920001
    LANDESBERG, Gary Mitchell
    122 Wigmore Street
    W1U 3RX London
    Administrateur
    122 Wigmore Street
    W1U 3RX London
    United KingdomBritishDirector54137480002
    ROSENBERG, David
    Wigmore Street
    W1U 3RX London
    122
    United Kingdom
    Administrateur
    Wigmore Street
    W1U 3RX London
    122
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director2541410004
    ROSENBERG, Elliot Simon
    Wigmore Street
    W1U 3RX London
    122
    United Kingdom
    Administrateur
    Wigmore Street
    W1U 3RX London
    122
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director2541420006
    LANDESBERG, Alan
    Wigmore Street
    W1U 3RX London
    122
    United Kingdom
    Administrateur
    Wigmore Street
    W1U 3RX London
    122
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director142883260002
    INHOCO FORMATIONS LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Administrateur désigné
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    900006560001

    Quelles sont les dernières déclarations sur les personnes ayant un contrôle significatif pour HANNOVER CAPITAL LIMITED ?

    Déclarations des personnes ayant un contrôle significatif
    Notifié leCessé leDéclaration
    28 sept. 2016La société sait ou a des raisons de croire qu'aucune personne enregistrable ou entité juridique pertinente enregistrable n'est liée à la société.

    HANNOVER CAPITAL LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Amendment agreement to the security assignment agreement of insurance claims
    Créé le 31 août 2007
    Livré le 18 sept. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Assigns the rights and claims under the pro seniore insurance policies. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Irish Nationwide Building Society
    Transactions
    • 18 sept. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Amendment agreement to the security assignment agreement of claims under the lease agreement
    Créé le 31 août 2007
    Livré le 18 sept. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Assigns the rights and claims under the pro seniore lease agreements. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Irish Nationwide Building Society
    Transactions
    • 18 sept. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Amendment agreement to the security assignment agreement of claims under the sale and purchase agreement
    Créé le 31 août 2007
    Livré le 18 sept. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Assigns the rights and claims under the. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Irish Nationwide Building Society
    Transactions
    • 18 sept. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Security purpose agreement
    Créé le 31 août 2007
    Livré le 18 sept. 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The certificated land charge (briefgrundschuld) in an amount of euro 92,700,000.00 plus interest and additional benefits (nebenleistungen) pursuant to the notorial deed no. JB279/2007 dated july 20 2007 of the notary jens bock, rankestrasse 21, 10789 berlin, by which the company has created the land charge in favour of the society over bad nenndorf real estate and pro seniors real estate. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Irish Nationwide Building Society
    Transactions
    • 18 sept. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Land charge executed outside the united kingdom over property situated there
    Créé le 20 juil. 2007
    Livré le 17 août 2007
    En cours
    Montant garanti
    92,700,000.00 euros and all other monies due or to become due
    Brèves mentions
    The property entered in the land register of heilbronn local court page 19692, serial no 4 card no 6111VN 1989/4 subplot 1149 kaiser friedrich platz 9 3,097 square meters,. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Irish Nationwide Building Society
    Transactions
    • 17 août 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Security purpose agreement
    Créé le 22 févr. 2007
    Livré le 03 mars 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Certificated land charge (briefgrundschuld) plus interest and additional benefits (nebenleistung) pursuant to the notarial deed no. Jb 21/2007 dated january 25 2007 of the notary jens bock rankestrasse 21, 10789 berlin by which the company has created the land charge over the real estate being the real estate indicated in the notarial deed and registered in the land register of the district court (amtsgericht) of stadthagen land register (grundbuch) of bad nenndorf page 3706 NO1 of the index section. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Irish Nationwide Building Society
    Transactions
    • 03 mars 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Security assignment of claims under sale and purchase agreements
    Créé le 22 févr. 2007
    Livré le 03 mars 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All of its present, future, conditional and unconditional claims, rights, title and interest under and in connection with the sale and purchase agreement. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Irish Nationwide Building Society
    Transactions
    • 03 mars 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Security assignment of claims under lease agreements
    Créé le 22 févr. 2007
    Livré le 03 mars 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All of its present, future, conditional and unconditional claims, rights, title and interest under and in connection with the following lease agreements set out in the schedule of from 395. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Irish Nationwide Building Society
    Transactions
    • 03 mars 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Security assignment of insurance claims
    Créé le 22 févr. 2007
    Livré le 03 mars 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All of its present, future, conditional and unconditional claims, rights, title and interest under and in connection with the following insurance policies set out in the schedule of from 395. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Irish Nationwide Building Society
    Transactions
    • 03 mars 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 22 févr. 2007
    Livré le 03 mars 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Irish Nationwide Building Society
    Transactions
    • 03 mars 2007Enregistrement d'une charge (395)
    Land charge
    Créé le 07 févr. 2007
    Livré le 23 févr. 2007
    En cours
    Montant garanti
    29,700,000.00 euros and all other monies due or to become due
    Brèves mentions
    The pledged land at bad nenndorf, land register page 3706,. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Irish Nationwide Building Society
    Transactions
    • 23 févr. 2007Enregistrement d'une charge (395)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0