USE (WATFORD) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéUSE (WATFORD) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 05969853
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de USE (WATFORD) LIMITED ?

    • Achat et vente de biens immobiliers propres (68100) / Activités immobilières

    Où se situe USE (WATFORD) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    82 St John Street
    EC1M 4JN London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de USE (WATFORD) LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    USE (WOKINGHAM) LIMITED17 oct. 200617 oct. 2006

    Quels sont les derniers comptes de USE (WATFORD) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au28 févr. 2014

    Quels sont les derniers dépôts pour USE (WATFORD) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    15 pagesLIQ13

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 19 nov. 2020

    12 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 19 nov. 2019

    11 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 19 nov. 2018

    12 pagesLIQ03

    Déclaration de solvabilité

    pages4.70

    Changement d'adresse du siège social de Europa House 20 Esplanade Scarborough North Yorkshire YO11 2AQ à 82 st John Street London EC1M 4JN le 07 août 2018

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Restauration par ordonnance du tribunal - précédemment en liquidation volontaire des membres

    2 pagesREST-MVL

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    5 pages4.71

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 20 nov. 2015

    LRESSP

    Déclaration de solvabilité

    pages4.70

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    2 pages600

    Déclaration de solvabilité

    9 pages4.70

    Déclaration annuelle jusqu'au 17 oct. 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital04 nov. 2015

    État du capital au 04 nov. 2015

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 1 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 2 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 3 en totalité

    4 pagesMR04

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Simon Charles Mccabe le 06 mars 2015

    2 pagesCH01

    Déclaration annuelle jusqu'au 17 oct. 2014 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital03 nov. 2014

    État du capital au 03 nov. 2014

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Comptes annuels établis au 28 févr. 2014

    15 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 17 oct. 2013 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital06 nov. 2013

    État du capital au 06 nov. 2013

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Simon Charles Mccabe le 16 sept. 2013

    3 pagesCH01

    Qui sont les dirigeants de USE (WATFORD) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ESPLANADE SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrement6133270
    123430250001
    MCCABE, Scott Richard
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    Administrateur
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    EnglandBritish151895310001
    MCCABE, Simon Charles
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    Administrateur
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    EnglandBritish154915110001
    ESPLANADE DIRECTOR LIMITED
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    Administrateur
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    Europa House
    North Yorkshire
    Type d'identificationSociété à responsabilité limitée du Royaume-Uni
    Numéro d'enregistrement6133267
    123430390001
    DUNCAN, David Walter
    5 Portland Court
    54 Trinity Court
    SE1 4JZ London
    Secrétaire
    5 Portland Court
    54 Trinity Court
    SE1 4JZ London
    British115440520001
    TEESLAND SECRETARIAL SERVICES LIMITED
    93 George Street
    EH2 3ES Edinburgh
    Secrétaire
    93 George Street
    EH2 3ES Edinburgh
    90707230001
    BIRCH, Trevor Nigel
    Cherry Street
    S2 4SU Sheffield
    Bramall Lane
    Administrateur
    Cherry Street
    S2 4SU Sheffield
    Bramall Lane
    United KingdomBritish136579440001
    CAPPER, Simon
    Bramall Lane
    S2 4SU Sheffield
    Administrateur
    Bramall Lane
    S2 4SU Sheffield
    United KingdomBritish118147580002
    DUNCAN, David Walter
    5 Portland Court
    54 Trinity Court
    SE1 4JZ London
    Administrateur
    5 Portland Court
    54 Trinity Court
    SE1 4JZ London
    British115440520001
    EWLES, Laura Jane
    100 Finsbury Park Road
    N4 2JT London
    Greater London
    Administrateur
    100 Finsbury Park Road
    N4 2JT London
    Greater London
    British119694120001
    FENOUGHTY, Mark Thomas
    108 Totley Brook Road
    S17 3QU Sheffield
    South Yorkshire
    Administrateur
    108 Totley Brook Road
    S17 3QU Sheffield
    South Yorkshire
    British91397360003
    HARROP, David Anthony
    Cherry Street
    S2 4SU Sheffield
    Bramall Lane
    South Yorkshire
    Administrateur
    Cherry Street
    S2 4SU Sheffield
    Bramall Lane
    South Yorkshire
    EnglandBritish160187290001
    ROBINSON, Terence James
    The Long Barn
    Holly Mount Lane Tottington
    BL8 4HP Bury
    Administrateur
    The Long Barn
    Holly Mount Lane Tottington
    BL8 4HP Bury
    EnglandBritish107314140001
    ROCKETT, Jason
    Bramall Lane
    Cherry Street
    S2 4SU Sheffield
    Administrateur
    Bramall Lane
    Cherry Street
    S2 4SU Sheffield
    United KingdomBritish111427410006
    TANDY, Didier Michel
    Europa House
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    North Yorkshire
    Administrateur
    Europa House
    20 Esplanade
    YO11 2AQ Scarborough
    North Yorkshire
    EnglandBritish69909950001

    USE (WATFORD) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 20 mai 2011
    Livré le 25 mai 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each guarantor and the company to the refinancing fee beneficiary on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Arliss court, 24 clarendon road, watford, t/no: HD158049 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Refinancing Fee Beneficiary
    Transactions
    • 25 mai 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 16 juin 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 20 mai 2011
    Livré le 25 mai 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor and the company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Arliss court, 24 clarendon road, watford, t/no: HD158049 fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC as Security Trustee for the Finance Parties
    Transactions
    • 25 mai 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 16 juin 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 08 févr. 2007
    Livré le 23 févr. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 23 févr. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 juin 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 08 févr. 2007
    Livré le 23 févr. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Arliss court 24 clarendon road watford t/n HD158049. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 23 févr. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 juin 2015Satisfaction d'une charge (MR04)

    USE (WATFORD) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    20 nov. 2015Commencement of winding up
    09 déc. 2021Dissolved on
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Andrew James Pear
    82 St John Street
    EC1M 4JN London
    practitioner
    82 St John Street
    EC1M 4JN London
    Michael Stephen Elliot Solomons
    82 St John Street
    EC1M 4JN London
    practitioner
    82 St John Street
    EC1M 4JN London
    Karen Lesley Dukes
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    practitioner
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Emma Cray
    Benson House
    33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds
    practitioner
    Benson House
    33 Wellington Street
    LS1 4JP Leeds

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0