BRANDSPACE GROUP LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBRANDSPACE GROUP LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 05973040
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BRANDSPACE GROUP LIMITED ?

    • Autres activités de services n.c.a. (96090) / Autres activités de services

    Où se situe BRANDSPACE GROUP LIMITED ?

    Adresse du siège social
    150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de BRANDSPACE GROUP LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    PROMOTION SPACE GROUP LIMITED24 avr. 200724 avr. 2007
    COBCO 810 LIMITED20 oct. 200620 oct. 2006

    Quels sont les derniers comptes de BRANDSPACE GROUP LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2011

    Quels sont les derniers dépôts pour BRANDSPACE GROUP LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    17 pagesLIQ14

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 27 mars 2018

    15 pagesLIQ03

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 27 mars 2017

    11 pages4.68

    Satisfaction de la charge 9 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 8 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 6 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 10 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 12 en totalité

    4 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 7 en totalité

    4 pagesMR04

    Cessation de la nomination de Jane Elizabeth Vinson en tant que directeur le 28 sept. 2016

    2 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Sebastien Canderle en tant que directeur le 02 juin 2016

    2 pagesTM01

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 27 mars 2016

    13 pages4.68

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 27 mars 2015

    13 pages4.68

    Dépôt d'insolvabilité

    Insolvency:secretary of state release of liquidator
    1 pagesLIQ MISC

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Ordonnance du tribunal d'insolvabilité

    Court order insolvency:block transfer order - replacement of liquidator
    47 pagesLIQ MISC OC

    Avis de cessation d'agir en tant que liquidateur volontaire

    1 pages4.40

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 28 mars 2014

    14 pages2.24B

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Avis de transition de l'administration à la liquidation volontaire des créanciers

    1 pages2.34B

    Rapport d'avancement de l'administrateur jusqu'à 04 oct. 2013

    14 pages2.24B

    Avis d'approbation réputée des propositions

    1 pagesF2.18

    Déclaration des affaires avec le formulaire 2.14B

    6 pages2.16B

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    31 pages2.17B

    Qui sont les dirigeants de BRANDSPACE GROUP LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    DE YOUNG, Michelle Anna-Lisa
    Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    150
    Administrateur
    Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    150
    EnglandBritish140102770001
    LORD, Julian
    32 Fletcher Drive
    Disley
    SK12 2ND Stockport
    Cheshire
    Secrétaire
    32 Fletcher Drive
    Disley
    SK12 2ND Stockport
    Cheshire
    British102300760001
    COBBETTS (SECRETARIAL) LIMITED
    Ship Canal House
    King Street
    M2 4WB Manchester
    Secrétaire
    Ship Canal House
    King Street
    M2 4WB Manchester
    86546820001
    ALLNER, Christopher Charles
    Woodrow
    HP7 0QQ Amersham
    Childs Farm
    Administrateur
    Woodrow
    HP7 0QQ Amersham
    Childs Farm
    EnglandBritish78206300001
    BERGIN, Joseph Damien
    Springwood House
    Davey Lane
    SK9 7NZ Alderley Edge
    Cheshire
    Administrateur
    Springwood House
    Davey Lane
    SK9 7NZ Alderley Edge
    Cheshire
    United KingdomBritish113935400001
    CANDERLE, Sebastien
    Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    150
    Administrateur
    Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    150
    EnglandFrench124282690001
    FAY, Sean Ernan
    7th Floor South
    11-19 Artillery Row
    SW1P 1RT London
    Artillery House
    England
    Administrateur
    7th Floor South
    11-19 Artillery Row
    SW1P 1RT London
    Artillery House
    England
    United KingdomIrish84925400001
    HUGHES, Stephan Michael
    492 Hempshaw Lane
    SK2 5TL Stockport
    Cheshire
    Administrateur
    492 Hempshaw Lane
    SK2 5TL Stockport
    Cheshire
    United KingdomBritish95176800002
    JAQUES, Richard Charles
    Glenbank
    Kershaw Grove
    SK11 8TN Macclesfield
    Cheshire
    Administrateur
    Glenbank
    Kershaw Grove
    SK11 8TN Macclesfield
    Cheshire
    United KingdomBritish56356980006
    JONES, Neil Henry
    Richmond Hill Court
    TW10 6BG Richmond
    98
    Surrey
    Administrateur
    Richmond Hill Court
    TW10 6BG Richmond
    98
    Surrey
    United KingdomBritish139632430001
    KEILLER, Andrew James
    Harlands Road
    RH16 1LZ Haywards Heath
    95
    West Sussex
    Administrateur
    Harlands Road
    RH16 1LZ Haywards Heath
    95
    West Sussex
    United KingdomBritish172132420001
    LANE, Damien John Patrick
    Old Bailey
    EC4M 7AN London
    20
    England
    Administrateur
    Old Bailey
    EC4M 7AN London
    20
    England
    EnglandEnglish158036110001
    LORD, Julian
    32 Fletcher Drive
    Disley
    SK12 2ND Stockport
    Cheshire
    Administrateur
    32 Fletcher Drive
    Disley
    SK12 2ND Stockport
    Cheshire
    EnglandBritish102300760001
    RAVILIOUS, Greg William Frederick
    Furzefield Avenue
    TN3 0LD Speldhurst
    Ridge House
    Kent
    Administrateur
    Furzefield Avenue
    TN3 0LD Speldhurst
    Ridge House
    Kent
    United KingdomBritish130854210001
    SOANES, Paul Henry
    Sparrow Row
    GU24 8TA Chobham
    Woodside
    Surrey
    Administrateur
    Sparrow Row
    GU24 8TA Chobham
    Woodside
    Surrey
    EnglandBritish68377030007
    SOAR, Guy Jason
    Lime Grove
    Timperley
    WA15 6PJ Altrincham
    27
    Cheshire
    Administrateur
    Lime Grove
    Timperley
    WA15 6PJ Altrincham
    27
    Cheshire
    United KingdomBritish96671300002
    SPOONER, Julian Robert Archer
    Kings Road
    KT2 5JJ Kingston Upon Thames
    301
    Surrey
    Administrateur
    Kings Road
    KT2 5JJ Kingston Upon Thames
    301
    Surrey
    EnglandBritish117770880001
    TAYLOR, Richard David
    Lyndon Cottage
    York Road
    LS25 5JW Burton Salmon
    North Yorkshire
    Administrateur
    Lyndon Cottage
    York Road
    LS25 5JW Burton Salmon
    North Yorkshire
    United KingdomBritish123754500001
    VINSON, Jane Elizabeth
    Old Bailey
    EC4M 7AN London
    20
    United Kingdom
    Administrateur
    Old Bailey
    EC4M 7AN London
    20
    United Kingdom
    EnglandBritish146632890001
    WADE, Roy
    Newman Grove
    College Farm
    FY5 2WT Thornton Cleveleys
    6
    Lancashire
    Administrateur
    Newman Grove
    College Farm
    FY5 2WT Thornton Cleveleys
    6
    Lancashire
    British131852890001
    WRIGHT, Richard Alan
    9 Belsize Mews
    Hampstead
    NW3 5AT London
    Administrateur
    9 Belsize Mews
    Hampstead
    NW3 5AT London
    United KingdomBritish80470950001
    COBBETTS (DIRECTOR) LIMITED
    Ship Canal House
    King Street
    M2 4WB Manchester
    Administrateur
    Ship Canal House
    King Street
    M2 4WB Manchester
    107196800001

    BRANDSPACE GROUP LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 30 juin 2010
    Livré le 08 juil. 2010
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any member of the group to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Octopus Capital for Enterprise Fund L.P.
    Transactions
    • 08 juil. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    Deed of admission to an omnibus guarantee and set-off agreement
    Créé le 02 nov. 2009
    Livré le 13 nov. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Any sum standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 13 nov. 2009Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 17 nov. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Composite guarantee and debentures
    Créé le 14 juil. 2009
    Livré le 31 juil. 2009
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the beneficiaries or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Octopus Investments Limited
    Transactions
    • 31 juil. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    Mortgage of a life policy
    Créé le 12 août 2008
    Livré le 14 août 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Brèves mentions
    P/No L0198163613, argon scottish equitable, life cover £500,000, date 31/07/08, life assured paul soanes see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 14 août 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 nov. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage of a life policy to secure own liabilities
    Créé le 30 avr. 2008
    Livré le 07 mai 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Life assured stephan hughes zurich assurance limited policy number 1827-62L-dhs lifestyle benefit: £1,000,000 life cover: £2,000,000 all bonuses all rights and interests see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 07 mai 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 nov. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage of a life policy to secure own liabilities
    Créé le 30 avr. 2008
    Livré le 07 mai 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Life assured guy soar zurich assurance limited policy number 1845-62L-dhs lifestyle benefit: £500,000 life cover: £1,000,000 all bonuses all rights and interests see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 07 mai 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 nov. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Créé le 30 avr. 2008
    Livré le 07 mai 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any sums or sums standing to the credit of any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 07 mai 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 nov. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 30 avr. 2008
    Livré le 07 mai 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 07 mai 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 17 nov. 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Guarantee & debenture
    Créé le 30 avr. 2008
    Livré le 07 mai 2008
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee and the beneficiaries or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Octopus Investments Limited as Security Trustee
    Transactions
    • 07 mai 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 12 mai 2008
    Debenture
    Créé le 28 nov. 2007
    Livré le 11 déc. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank PLC (Trading as Yorkshire Bank)
    Transactions
    • 11 déc. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 mai 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage of policy
    Créé le 28 nov. 2007
    Livré le 11 déc. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The policy being dated 1 july 2007 p/no 1845-62L-dhs with zurich assurance limited on the life of guy jason soar in the sum of £1,000,000. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank PLC (Trading as Yorkshire Bank)
    Transactions
    • 11 déc. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 mai 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Mortgage of policy
    Créé le 28 nov. 2007
    Livré le 11 déc. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The policy dated 1 july 2007 p/no 1827-62L-dhs with zurich assurance limited on the life of stephen michael hughes in the sum of £2,000,000. see the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank PLC (Trading as Yorkshire Bank)
    Transactions
    • 11 déc. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 mai 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Guarantee & debenture
    Créé le 30 avr. 2007
    Livré le 11 mai 2007
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the beneficiaries or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Octopus Investments Limited (The Security Trustee)
    Transactions
    • 11 mai 2007Enregistrement d'une charge (395)

    BRANDSPACE GROUP LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    05 avr. 2013Administration started
    28 mars 2014Administration ended
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Jeremy Mark Willmont
    Moore Stephens Llp 150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    practitioner
    Moore Stephens Llp 150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Phillip Rodney Sykes
    150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    practitioner
    150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    2
    DateType
    28 mars 2014Commencement of winding up
    16 janv. 2019Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Jeremy Mark Willmont
    Moore Stephens Llp 150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    proposed liquidator
    Moore Stephens Llp 150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Phillip Rodney Sykes
    150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    proposed liquidator
    150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Jeremy Mark Willmont
    Moore Stephens Llp 150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    practitioner
    Moore Stephens Llp 150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Phillip Rodney Sykes
    150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    practitioner
    150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    Neville Side
    150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London
    practitioner
    150 Aldersgate Street
    EC1A 4AB London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0