WELDSPARES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéWELDSPARES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 06003671
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de WELDSPARES LIMITED ?

    • Commerce de gros non spécialisé (46900) / Commerce de gros et de détail ; réparation de véhicules automobiles et de motocycles

    Où se situe WELDSPARES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    C/O Frp Advisory Llp
    Derby House, 12 Winckley Square
    PR1 3JJ Preston
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de WELDSPARES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au30 nov. 2017

    Quels sont les derniers dépôts pour WELDSPARES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    16 pagesLIQ14

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 03 janv. 2021

    18 pagesLIQ03

    Cessation de la nomination de Mark Philip Underwood en tant que directeur le 28 mai 2020

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Alan Ralph Underwood en tant que directeur le 07 mai 2020

    1 pagesTM01

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 03 janv. 2020

    21 pagesLIQ03

    Changement d'adresse du siège social de 8 Winmarleigh Street Warrington Cheshire WA1 1JW England à C/O Frp Advisory Llp Derby House, 12 Winckley Square Preston PR1 3JJ le 25 janv. 2019

    2 pagesAD01

    Déclaration des affaires

    12 pagesLIQ02

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution extraordinaire pour la liquidation au 04 janv. 2019

    LRESEX

    Comptes pour une petite entreprise établis au 30 nov. 2017

    12 pagesAA

    Période comptable précédente raccourcie du 31 déc. 2017 au 30 nov. 2017

    1 pagesAA01

    Nomination de Mr Steven Antony Swinden en tant que secrétaire le 19 sept. 2017

    2 pagesAP03

    Notification de Flamefast Holdings Ltd en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 19 sept. 2017

    2 pagesPSC02

    Déclaration de confirmation établie le 20 nov. 2017 avec mises à jour

    4 pagesCS01

    Cessation de Futuris Group Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 19 sept. 2017

    1 pagesPSC07

    Nomination de Mrs Colleen Swinden en tant qu'administrateur le 19 sept. 2017

    2 pagesAP01

    Nomination de Mrs Jane Warburton en tant qu'administrateur le 19 sept. 2017

    2 pagesAP01

    Satisfaction de la charge 2 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 3 en totalité

    1 pagesMR04

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2016

    13 pagesAA

    Inscription de la charge 060036710006, créée le 19 sept. 2017

    27 pagesMR01

    Satisfaction de la charge 1 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    1 pagesMR04

    Cessation de la nomination de Steven Keith Underwood en tant que directeur le 19 sept. 2017

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de WELDSPARES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SWINDEN, Steven Antony
    Risley Road
    Birchwood
    WA3 6QU Warrington
    1 Heaton Court
    Cheshire
    England
    Secrétaire
    Risley Road
    Birchwood
    WA3 6QU Warrington
    1 Heaton Court
    Cheshire
    England
    249138720001
    SWINDEN, Colleen
    Risley Road
    Birchwood
    WA3 6QU Warrington
    1 Heaton Court
    Cheshire
    England
    Administrateur
    Risley Road
    Birchwood
    WA3 6QU Warrington
    1 Heaton Court
    Cheshire
    England
    United KingdomBritishDirector174341860001
    SWINDEN, Steven Antony
    Derby House, 12 Winckley Square
    PR1 3JJ Preston
    C/O Frp Advisory Llp
    Administrateur
    Derby House, 12 Winckley Square
    PR1 3JJ Preston
    C/O Frp Advisory Llp
    EnglandBritishDirector223751200001
    WARBURTON, Jane
    Risley Road
    Birchwood
    WA3 6QU Warrington
    1 Heaton Court
    Cheshire
    England
    Administrateur
    Risley Road
    Birchwood
    WA3 6QU Warrington
    1 Heaton Court
    Cheshire
    England
    United KingdomBritishDirector81638870001
    DUGGAN, Julie Michelle
    33 Deanwater Close
    Locking Stumps
    WA3 6ER Warrington
    Cheshire
    Secrétaire
    33 Deanwater Close
    Locking Stumps
    WA3 6ER Warrington
    Cheshire
    British98338110001
    FOXFORD, Michael John
    5 Cambridge Road
    Hale
    WA15 9SY Altrincham
    Cheshire
    Secrétaire
    5 Cambridge Road
    Hale
    WA15 9SY Altrincham
    Cheshire
    British104303490001
    COCKAYNE, Michael
    Hardwick Grange
    Woolston
    WA1 4RZ Warrington
    Unit 50, Melford Court
    Cheshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Hardwick Grange
    Woolston
    WA1 4RZ Warrington
    Unit 50, Melford Court
    Cheshire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector210343410001
    COVENEY, Jonathan Frank
    36 Woodford Avenue
    WA3 2PS Lowton
    Cheshire
    Administrateur
    36 Woodford Avenue
    WA3 2PS Lowton
    Cheshire
    EnglandBritishSales Manager325690470001
    DUGGAN, Julie Michelle
    Hardwick Grange
    Woolston
    WA1 4RZ Warrington
    Unit 50, Melford Court
    Cheshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Hardwick Grange
    Woolston
    WA1 4RZ Warrington
    Unit 50, Melford Court
    Cheshire
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector210343980001
    ENGLAND, Forbes Barry
    1 Wilding Close
    GL20 8PD Tewkesbury
    Gloucestershire
    Administrateur
    1 Wilding Close
    GL20 8PD Tewkesbury
    Gloucestershire
    BritishSales Manager121598630001
    FITZPATRICK, Eric
    7 Beaumont Grove
    Beaumont
    IRISH Dublin
    Republic Of Ireland
    Administrateur
    7 Beaumont Grove
    Beaumont
    IRISH Dublin
    Republic Of Ireland
    IrishSales Manager121598650001
    MCDONALD, John Joseph
    Wigan Road
    Golborne
    WA3 3TZ Warrington
    17
    Cheshire
    Administrateur
    Wigan Road
    Golborne
    WA3 3TZ Warrington
    17
    Cheshire
    BritishSales Manager121598770003
    SWINDEN, Stuart Antony
    22 Beechways
    Appleton
    WA4 5ER Warrington
    Administrateur
    22 Beechways
    Appleton
    WA4 5ER Warrington
    BritishCompany Director10896130001
    TAYLOR, Janet
    Berkshire Drive
    M44 5YA Cadishead
    21
    Greater Manchester
    England
    Administrateur
    Berkshire Drive
    M44 5YA Cadishead
    21
    Greater Manchester
    England
    EnglandBritishDirector156332380001
    THOMAS, Mark
    Megson Way
    Walkington
    HU17 8YA Beverley
    77
    Yorkshire
    England
    Administrateur
    Megson Way
    Walkington
    HU17 8YA Beverley
    77
    Yorkshire
    England
    EnglandBritishDirector138073900001
    UNDERWOOD, Alan Ralph
    58 Winnipeg Quay
    Salford Quays
    M50 3TY Salford
    Lancashire
    Administrateur
    58 Winnipeg Quay
    Salford Quays
    M50 3TY Salford
    Lancashire
    EnglandBritishI T Manager121598700002
    UNDERWOOD, Mark Philip
    8 Sandringham Drive
    Brinscall
    PR6 8SU Chorley
    Lancashire
    Administrateur
    8 Sandringham Drive
    Brinscall
    PR6 8SU Chorley
    Lancashire
    United KingdomBritishManaging Director24752850001
    UNDERWOOD, Steven Keith
    2 Woodside
    Turton Hollow Road
    BB4 8AY Rossendale
    Lancashire
    Administrateur
    2 Woodside
    Turton Hollow Road
    BB4 8AY Rossendale
    Lancashire
    United KingdomBritishCo Director120416810001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur WELDSPARES LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Flamefast Holdings Ltd
    WA1 1JW Warrington
    8 Winmarleigh Street
    Cheshire
    England
    19 sept. 2017
    WA1 1JW Warrington
    8 Winmarleigh Street
    Cheshire
    England
    Non
    Forme juridiqueLimited Company
    Pays d'enregistrementEngland And Wales
    Autorité légaleCompanies Act
    Lieu d'enregistrementEngland & Wales
    Numéro d'enregistrement05398978
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    Futuris Group Limited
    Melford Court, Hardwick Grange
    Woolston
    WA1 4RZ Warrington
    Unit 50
    England
    06 avr. 2016
    Melford Court, Hardwick Grange
    Woolston
    WA1 4RZ Warrington
    Unit 50
    England
    Oui
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementEngland
    Autorité légale2006 Companies Act
    Lieu d'enregistrementEngland & Wales
    Numéro d'enregistrement06003706
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    WELDSPARES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 19 sept. 2017
    Livré le 21 sept. 2017
    En cours
    Brève description
    The company with full title guarantee in accordance with the law of property (miscellaneous provisions) act 1994 charges in favour of praetura commercial finance limited as continuing security for the payment and discharge of the secured obligations:. 4.1.1 by way of legal mortgage, the real property, the details of which are set out in part 1 of the schedule (if any);. 4.1.2 by way of fixed charge, any real property now or at any time after the date of this deed belonging to the company (other than property charged under clause 3.1.1);. real property means:. (A) as defined in the finance agreement (including the property specified in part 1 of schedule 2 (if any)); and. (B) any buildings, erections, fixtures or fittings from time to time situated on or forming part of such property (including any trade fixtures and fittings); and. (C) all related rights;. 4.1.7 by way of fixed charge, all present and future intellectual property rights owned by it. Intellectual property rights means:. (A) all present and future patents, trademarks, service marks, designs, business names, copyrights, design rights, moral rights, inventions, confidential information, knowhow and other intellectual property rights and interests, whether registered or unregistered (and specifically including those set out in part 3 of schedule 2);. (b) the benefit of all applications and rights to use such assets; and. (C) all related rights;.
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Praetura Commercial Finance Limited
    Transactions
    • 21 sept. 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 10 juin 2015
    Livré le 16 juin 2015
    En cours
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • North West Mezzanine Loans LP Acting by Fw Development Capital (North West) Gp Limited as the General Partner of North West Mezzanine Loans LP Acting by Fw Capital Limited
    Transactions
    • 16 juin 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    Legal assignment
    Créé le 17 août 2009
    Livré le 22 août 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Any credit balance due to the company under condition 13 of the agreement for the purchase of debts and any discounting allowance due under the contract the benefit of all the other provisions of the contract and all securities in respect of that credit balance.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 22 août 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 sept. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Floating charge (all assets)
    Créé le 15 janv. 2007
    Livré le 17 janv. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of floating charge all the undertaking of the company and all assets whatsoever and wheresoever including stock in trade and uncalled capital but excluding any debts and associated rights relating thereto.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Invoice Finance (UK) LTD (the Security Holder)
    Transactions
    • 17 janv. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 oct. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Fixed charge on purchased debts which fail to vest
    Créé le 15 janv. 2007
    Livré le 17 janv. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of fixed equitable charge all debts purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to an agreement for the purchase of debts which fail to vest effectively or absolutely in the security holder for any reason.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Invoice Finance (UK) LTD (the Security Holder)
    Transactions
    • 17 janv. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 04 oct. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 05 déc. 2006
    Livré le 16 déc. 2006
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 16 déc. 2006Enregistrement d'une charge (395)
    • 20 sept. 2017Satisfaction d'une charge (MR04)

    WELDSPARES LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    04 janv. 2019Commencement of winding up
    05 oct. 2021Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Ben Woolrych
    4th Floor Abbey House
    32 Booth Street
    M2 4AB Manchester
    practitioner
    4th Floor Abbey House
    32 Booth Street
    M2 4AB Manchester
    Lila Thomas
    Derby House 12 Winckley Square
    PR1 3JJ Preston
    Lancashire
    practitioner
    Derby House 12 Winckley Square
    PR1 3JJ Preston
    Lancashire

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0