WELDSPARES LIMITED
Vue d'ensemble
Nom de la société | WELDSPARES LIMITED |
---|---|
Statut de la société | Dissoute |
Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
Numéro de société | 06003671 |
Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
Date de création | |
Date de cessation d'activité |
Résumé
A des PSCs super sécurisés | Non |
---|---|
A des charges | Oui |
A un historique d'insolvabilité | Oui |
Le siège social est contesté | Non |
Où se situe WELDSPARES LIMITED ?
Adresse du siège social | C/O Frp Advisory Llp Derby House, 12 Winckley Square PR1 3JJ Preston |
---|---|
Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de WELDSPARES LIMITED ?
Derniers comptes | |
---|---|
Derniers comptes arrêtés au | 30 nov. 2017 |
Quels sont les derniers dépôts pour WELDSPARES LIMITED ?
Date | Description | Document | Type | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers | 16 pages | LIQ14 | ||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 03 janv. 2021 | 18 pages | LIQ03 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Mark Philip Underwood en tant que directeur le 28 mai 2020 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Alan Ralph Underwood en tant que directeur le 07 mai 2020 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 03 janv. 2020 | 21 pages | LIQ03 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 8 Winmarleigh Street Warrington Cheshire WA1 1JW England à C/O Frp Advisory Llp Derby House, 12 Winckley Square Preston PR1 3JJ le 25 janv. 2019 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration des affaires | 12 pages | LIQ02 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 3 pages | 600 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une petite entreprise établis au 30 nov. 2017 | 12 pages | AA | ||||||||||
Période comptable précédente raccourcie du 31 déc. 2017 au 30 nov. 2017 | 1 pages | AA01 | ||||||||||
Nomination de Mr Steven Antony Swinden en tant que secrétaire le 19 sept. 2017 | 2 pages | AP03 | ||||||||||
Notification de Flamefast Holdings Ltd en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 19 sept. 2017 | 2 pages | PSC02 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 20 nov. 2017 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de Futuris Group Limited en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 19 sept. 2017 | 1 pages | PSC07 | ||||||||||
Nomination de Mrs Colleen Swinden en tant qu'administrateur le 19 sept. 2017 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mrs Jane Warburton en tant qu'administrateur le 19 sept. 2017 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 2 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 3 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2016 | 13 pages | AA | ||||||||||
Inscription de la charge 060036710006, créée le 19 sept. 2017 | 27 pages | MR01 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 1 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Satisfaction de la charge 4 en totalité | 1 pages | MR04 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Steven Keith Underwood en tant que directeur le 19 sept. 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de WELDSPARES LIMITED ?
Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWINDEN, Steven Antony | Secrétaire | Risley Road Birchwood WA3 6QU Warrington 1 Heaton Court Cheshire England | 249138720001 | |||||||
SWINDEN, Colleen | Administrateur | Risley Road Birchwood WA3 6QU Warrington 1 Heaton Court Cheshire England | United Kingdom | British | Director | 174341860001 | ||||
SWINDEN, Steven Antony | Administrateur | Derby House, 12 Winckley Square PR1 3JJ Preston C/O Frp Advisory Llp | England | British | Director | 223751200001 | ||||
WARBURTON, Jane | Administrateur | Risley Road Birchwood WA3 6QU Warrington 1 Heaton Court Cheshire England | United Kingdom | British | Director | 81638870001 | ||||
DUGGAN, Julie Michelle | Secrétaire | 33 Deanwater Close Locking Stumps WA3 6ER Warrington Cheshire | British | 98338110001 | ||||||
FOXFORD, Michael John | Secrétaire | 5 Cambridge Road Hale WA15 9SY Altrincham Cheshire | British | 104303490001 | ||||||
COCKAYNE, Michael | Administrateur | Hardwick Grange Woolston WA1 4RZ Warrington Unit 50, Melford Court Cheshire United Kingdom | England | British | Director | 210343410001 | ||||
COVENEY, Jonathan Frank | Administrateur | 36 Woodford Avenue WA3 2PS Lowton Cheshire | England | British | Sales Manager | 325690470001 | ||||
DUGGAN, Julie Michelle | Administrateur | Hardwick Grange Woolston WA1 4RZ Warrington Unit 50, Melford Court Cheshire United Kingdom | England | British | Director | 210343980001 | ||||
ENGLAND, Forbes Barry | Administrateur | 1 Wilding Close GL20 8PD Tewkesbury Gloucestershire | British | Sales Manager | 121598630001 | |||||
FITZPATRICK, Eric | Administrateur | 7 Beaumont Grove Beaumont IRISH Dublin Republic Of Ireland | Irish | Sales Manager | 121598650001 | |||||
MCDONALD, John Joseph | Administrateur | Wigan Road Golborne WA3 3TZ Warrington 17 Cheshire | British | Sales Manager | 121598770003 | |||||
SWINDEN, Stuart Antony | Administrateur | 22 Beechways Appleton WA4 5ER Warrington | British | Company Director | 10896130001 | |||||
TAYLOR, Janet | Administrateur | Berkshire Drive M44 5YA Cadishead 21 Greater Manchester England | England | British | Director | 156332380001 | ||||
THOMAS, Mark | Administrateur | Megson Way Walkington HU17 8YA Beverley 77 Yorkshire England | England | British | Director | 138073900001 | ||||
UNDERWOOD, Alan Ralph | Administrateur | 58 Winnipeg Quay Salford Quays M50 3TY Salford Lancashire | England | British | I T Manager | 121598700002 | ||||
UNDERWOOD, Mark Philip | Administrateur | 8 Sandringham Drive Brinscall PR6 8SU Chorley Lancashire | United Kingdom | British | Managing Director | 24752850001 | ||||
UNDERWOOD, Steven Keith | Administrateur | 2 Woodside Turton Hollow Road BB4 8AY Rossendale Lancashire | United Kingdom | British | Co Director | 120416810001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur WELDSPARES LIMITED ?
Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Flamefast Holdings Ltd | 19 sept. 2017 | WA1 1JW Warrington 8 Winmarleigh Street Cheshire England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Futuris Group Limited | 06 avr. 2016 | Melford Court, Hardwick Grange Woolston WA1 4RZ Warrington Unit 50 England | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
|
WELDSPARES LIMITED a-t-elle des charges ?
Classification | Dates | Statut | Détails | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Créé le 19 sept. 2017 Livré le 21 sept. 2017 | En cours | ||
Brève description The company with full title guarantee in accordance with the law of property (miscellaneous provisions) act 1994 charges in favour of praetura commercial finance limited as continuing security for the payment and discharge of the secured obligations:. 4.1.1 by way of legal mortgage, the real property, the details of which are set out in part 1 of the schedule (if any);. 4.1.2 by way of fixed charge, any real property now or at any time after the date of this deed belonging to the company (other than property charged under clause 3.1.1);. real property means:. (A) as defined in the finance agreement (including the property specified in part 1 of schedule 2 (if any)); and. (B) any buildings, erections, fixtures or fittings from time to time situated on or forming part of such property (including any trade fixtures and fittings); and. (C) all related rights;. 4.1.7 by way of fixed charge, all present and future intellectual property rights owned by it. Intellectual property rights means:. (A) all present and future patents, trademarks, service marks, designs, business names, copyrights, design rights, moral rights, inventions, confidential information, knowhow and other intellectual property rights and interests, whether registered or unregistered (and specifically including those set out in part 3 of schedule 2);. (b) the benefit of all applications and rights to use such assets; and. (C) all related rights;. La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
A registered charge | Créé le 10 juin 2015 Livré le 16 juin 2015 | En cours | ||
Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Legal assignment | Créé le 17 août 2009 Livré le 22 août 2009 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Any credit balance due to the company under condition 13 of the agreement for the purchase of debts and any discounting allowance due under the contract the benefit of all the other provisions of the contract and all securities in respect of that credit balance. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Floating charge (all assets) | Créé le 15 janv. 2007 Livré le 17 janv. 2007 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions By way of floating charge all the undertaking of the company and all assets whatsoever and wheresoever including stock in trade and uncalled capital but excluding any debts and associated rights relating thereto. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Fixed charge on purchased debts which fail to vest | Créé le 15 janv. 2007 Livré le 17 janv. 2007 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions By way of fixed equitable charge all debts purchased or purported to be purchased by the security holder pursuant to an agreement for the purchase of debts which fail to vest effectively or absolutely in the security holder for any reason. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Debenture | Créé le 05 déc. 2006 Livré le 16 déc. 2006 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
|
WELDSPARES LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Creditors voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0