CHASE COMMERCIAL (STRATFORD) LIMITED

CHASE COMMERCIAL (STRATFORD) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéCHASE COMMERCIAL (STRATFORD) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 06007769
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de CHASE COMMERCIAL (STRATFORD) LIMITED ?

    • Développement de projets de construction (41100) / Construction

    Où se situe CHASE COMMERCIAL (STRATFORD) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    2 The Courtyard
    Timothy's Bridge Road
    CV37 9NP Stratford Upon Avon
    Warwickshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de CHASE COMMERCIAL (STRATFORD) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour CHASE COMMERCIAL (STRATFORD) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    1 pagesDS01

    Déclaration de confirmation établie le 23 nov. 2017 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Cessation de la nomination de Julian Ronald Meredith en tant que directeur le 26 juil. 2017

    1 pagesTM01

    Nomination de Mrs Gail Janette Ackrill en tant qu'administrateur le 26 juil. 2017

    2 pagesAP01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2016

    7 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 23 nov. 2016 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2015

    8 pagesAA

    Satisfaction de la charge 060077690011 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 060077690010 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 060077690012 en totalité

    1 pagesMR04

    Cessation de la nomination de Timothy Guy Haslam en tant que directeur le 31 déc. 2015

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 23 nov. 2015 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital16 déc. 2015

    État du capital au 16 déc. 2015

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2014

    8 pagesAA

    Inscription de la charge 060077690012, créée le 20 avr. 2015

    32 pagesMR01

    Déclaration annuelle jusqu'au 23 nov. 2014 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital04 déc. 2014

    État du capital au 04 déc. 2014

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Inscription de la charge 060077690011, créée le 29 sept. 2014

    36 pagesMR01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2013

    8 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 23 nov. 2013 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital17 déc. 2013

    État du capital au 17 déc. 2013

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2012

    8 pagesAA

    Inscription de la charge 060077690010

    46 pagesMR01
    Annotations
    DateAnnotation
    27 juin 2013This document has been informally corrected in accordance with instructions under section 1075 of the Companies Act 2006
    27 juin 2013The certified copy instrument associated with this transaction contains some elements which are in colour. Unfortunately, at present, Companies House does not provide colour images through our output services. If you would like to view a copy of the instrument in colour, please call 02920 381367.

    Démission de l'auditeur

    1 pagesAUD

    Démission de l'auditeur

    1 pagesAUD

    Divers

    Section 519 companies act 2006
    1 pagesMISC

    Qui sont les dirigeants de CHASE COMMERCIAL (STRATFORD) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    ACKRILL, Gail Janette
    The Courtyard
    Timothy's Bridge Road
    CV37 9NP Stratford Upon Avon
    2
    Warwickshire
    Administrateur
    The Courtyard
    Timothy's Bridge Road
    CV37 9NP Stratford Upon Avon
    2
    Warwickshire
    United KingdomBritishDirector141047020002
    MILLER, Jane
    4 Poplar Rise
    Wappenham
    NN12 8RR Towcester
    Northamptonshire
    Secrétaire
    4 Poplar Rise
    Wappenham
    NN12 8RR Towcester
    Northamptonshire
    British89678850001
    ALLKINS, Stephen Philip
    Badgers House
    Stourton
    CV36 5HG Shipston On Stour
    Warwickshire
    Administrateur
    Badgers House
    Stourton
    CV36 5HG Shipston On Stour
    Warwickshire
    EnglandBritishDirector56899810002
    HASLAM, Timothy Guy
    The Courtyard
    Timothy's Bridge Road
    CV37 9NP Stratford Upon Avon
    2
    Warwickshire
    Administrateur
    The Courtyard
    Timothy's Bridge Road
    CV37 9NP Stratford Upon Avon
    2
    Warwickshire
    EnglandBritishChartered Surveyor54650230002
    MEREDITH, Julian Ronald
    The Courtyard
    Timothy's Bridge Road
    CV37 9NP Stratford Upon Avon
    2
    Warwickshire
    Administrateur
    The Courtyard
    Timothy's Bridge Road
    CV37 9NP Stratford Upon Avon
    2
    Warwickshire
    United KingdomBritishDirector108679210001
    MILLER, Jane
    4 Poplar Rise
    Wappenham
    NN12 8RR Towcester
    Northamptonshire
    Administrateur
    4 Poplar Rise
    Wappenham
    NN12 8RR Towcester
    Northamptonshire
    BritishChartetered Accountant89678850001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur CHASE COMMERCIAL (STRATFORD) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Ms Gail Janette Ackrill
    The Courtyard
    Timothy's Bridge Road
    CV37 9NP Stratford Upon Avon
    2
    Warwickshire
    30 juin 2016
    The Courtyard
    Timothy's Bridge Road
    CV37 9NP Stratford Upon Avon
    2
    Warwickshire
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: United Kingdom
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.

    CHASE COMMERCIAL (STRATFORD) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 20 avr. 2015
    Livré le 23 avr. 2015
    Totalement satisfaite
    Brève description
    F/H property k/a ratio point davies road evesham t/no WR116277.
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 23 avr. 2015Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 08 mars 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 29 sept. 2014
    Livré le 02 oct. 2014
    Totalement satisfaite
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Bank PLC
    Transactions
    • 02 oct. 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 08 mars 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    A registered charge
    Créé le 12 juin 2013
    Livré le 26 juin 2013
    Totalement satisfaite
    Brève description
    Units 2 and 3 budbrooke point, budbrooke road, warwick, t/no: WK314947 (part). Notification of addition to or amendment of charge.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC (As Security Agent)
    Transactions
    • 26 juin 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    • 08 mars 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal mortgage
    Créé le 27 janv. 2011
    Livré le 29 janv. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee (trading as yorkshire bank) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    251 birmingham road stratford upon avon t/no. WV443750 assigns the goodwill of all businesses, from time to time carried on at the property, with the benefit of all authorisations, permits, registration certificates or licences of any kind, also by way of fixed charge the equipment & goods (if any) & all other fixtures, fittings, plant & machinery & by way of floating charge on other moveable plant, machinery, furniture, equipment, goods & other effects which are from time to time on the property.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank PLC
    Transactions
    • 29 janv. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 06 juil. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 25 janv. 2011
    Livré le 27 janv. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee (trading as yorkshire bank) on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Personnes ayant droit
    • Clydesdale Bank PLC
    Transactions
    • 27 janv. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 06 juil. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 29 janv. 2009
    Livré le 05 févr. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Chase Midland PLC (In Administration)
    Transactions
    • 05 févr. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 avr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Charge over construction contract
    Créé le 10 sept. 2008
    Livré le 12 sept. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed legal charge all of the company's present and future rights title and interest in and to the contract dated 23 april 2008 made between the company and anglo-holt construction limited.
    Personnes ayant droit
    • Dunbar Bank PLC
    Transactions
    • 12 sept. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 avr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Floating charge
    Créé le 18 mars 2008
    Livré le 22 mars 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of first floating charge all the undertaking and assets of the company whatsoever and wheresoever both present and future see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Dunbar Bank PLC
    Transactions
    • 22 mars 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 avr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Deed of assignment of rental income
    Créé le 18 mars 2008
    Livré le 22 mars 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All payments reserved as rent under any lease see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Dunbar Bank PLC
    Transactions
    • 22 mars 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 avr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge over agreement for lease
    Créé le 18 mars 2008
    Livré le 22 mars 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All the interest under an agreement for lease dated 22 december 2006 made between the mortgagor (1) and travelodge hotels limited (2) and in the buildings now or hereafter in the course of construction on the property k/a land at birmingham road stratford-upon-avon see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Dunbar Bank PLC
    Transactions
    • 22 mars 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 avr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 18 mars 2008
    Livré le 22 mars 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land on the south west side of birmingham road, stratford-upon-avon, warwickshire part of t/no WK359132 see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Dunbar Bank PLC
    Transactions
    • 22 mars 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 31 mars 2008
    • 28 avr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 18 mars 2008
    Livré le 22 mars 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land at birmingham road straford upon avon warwickshire t/no WK359132 the fixtures and fittings and plant and machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Trustees of the Jg Whateley 2002 Accumulation and Maintenance Settlement for the Benefit of the Grandchildren
    Transactions
    • 22 mars 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 28 avr. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0