LIGHTHOUSE UKCO 2 LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | LIGHTHOUSE UKCO 2 LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 06025306 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe LIGHTHOUSE UKCO 2 LIMITED ?
| Adresse du siège social | Wilkin Chapman Llp, Cartergate House 26 Chantry Lane DN31 2LJ Grimsby North East Lincolnshire England |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de LIGHTHOUSE UKCO 2 LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 30 sept. 2018 |
Quels sont les derniers dépôts pour LIGHTHOUSE UKCO 2 LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire | 1 pages | GAZ2(A) | ||||||||||||||||||
Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire | 1 pages | GAZ1(A) | ||||||||||||||||||
Demande de radiation de la société du registre du commerce | 3 pages | DS01 | ||||||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 11 déc. 2019 avec mises à jour | 4 pages | CS01 | ||||||||||||||||||
Cessation de la nomination de William John Showalter en tant que directeur le 11 nov. 2019 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||||||
Nomination de Mr John Philip Madden en tant qu'administrateur le 08 nov. 2019 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Wilkin Chapman Llp, Cartergate House 26 Chantry Lane Grimsby North East Lincolnshire DN31 2LJ England à Wilkin Chapman Llp, Cartergate House 26 Chantry Lane Grimsby North East Lincolnshire DN31 2LJ le 08 nov. 2019 | 1 pages | AD01 | ||||||||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Ross House Wickham Road Grimsby North East Lincolnshire DN31 3SW England à Wilkin Chapman Llp, Cartergate House 26 Chantry Lane Grimsby North East Lincolnshire DN31 2LJ le 08 nov. 2019 | 1 pages | AD01 | ||||||||||||||||||
Comptes annuels établis au 30 sept. 2018 | 18 pages | AA | ||||||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 10 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
État du capital après une attribution d'actions au 03 juil. 2019
| 4 pages | SH01 | ||||||||||||||||||
Satisfaction de la charge 060253060004 en totalité | 4 pages | MR04 | ||||||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 11 déc. 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||||||
Comptes annuels établis au 30 sept. 2017 | 17 pages | AA | ||||||||||||||||||
Modification des coordonnées du secrétaire Wilchap Company Secretaries Limited le 02 janv. 2017 | 1 pages | CH04 | ||||||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 11 déc. 2017 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||||||||||
Comptes annuels établis au 30 sept. 2016 | 17 pages | AA | ||||||||||||||||||
Cessation de la nomination de Karen Jeanette Noakes en tant que directeur le 01 févr. 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 11 déc. 2016 avec mises à jour | 6 pages | CS01 | ||||||||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de Wickham Road Grimsby North East Lincolnshire DN31 2SW à Ross House Wickham Road Grimsby North East Lincolnshire DN31 3SW le 21 déc. 2016 | 1 pages | AD01 | ||||||||||||||||||
Comptes annuels établis au 30 sept. 2015 | 17 pages | AA | ||||||||||||||||||
Cessation de la nomination de Guy Nicholas Anthony Faller en tant que directeur le 29 févr. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||||||
Nomination de Karen Jeanette Noakes en tant qu'administrateur le 29 févr. 2016 | 2 pages | AP01 | ||||||||||||||||||
Cessation de la nomination de Christopher Frank Parker en tant que directeur le 31 janv. 2016 | 1 pages | TM01 | ||||||||||||||||||
Déclaration annuelle jusqu'au 11 déc. 2015 avec liste complète des actionnaires | 6 pages | AR01 | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
Qui sont les dirigeants de LIGHTHOUSE UKCO 2 LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WILCHAP COMPANY SECRETARIES LIMITED | Secrétaire | 26 Chantry Lane DN31 2LJ Grimsby Cartergate House N.E. Lincolshire United Kingdom |
| 129180060002 | ||||||||||
| MADDEN, John Philip | Administrateur | 26 Chantry Lane DN31 2LJ Grimsby Wilkin Chapman Llp, Cartergate House North East Lincolnshire England | England | British | 264245380001 | |||||||||
| HACKWOOD SECRETARIES LIMITED | Secrétaire désigné | One Silk Street EC2Y 8HQ London | 900004790001 | |||||||||||
| BRITTON, Christopher Paul | Administrateur | Park Grange Main Street LS22 4AP Sicklinghall West Yorkshire | United Kingdom | British | 127835580001 | |||||||||
| CAMPBELL, Christopher | Administrateur | 74 Coleherne Court Little Boltons SW5 0EF London | American | 109921890001 | ||||||||||
| CANE, James Robert | Administrateur | Chapel House Brigg Road LN7 6PQ South Kelsey Lincolnshire | United Kingdom | British | 104635350001 | |||||||||
| FALLER, Guy Nicholas Anthony | Administrateur | Wickham Road Grimsby DN31 2SW North East Lincolnshire | United Kingdom | British | 108529830002 | |||||||||
| FITZPATRICK, Seamus Philip | Administrateur | Flat 1 1 Onslow Gardens SW7 3LX London | United Kingdom | Irish | 65991000003 | |||||||||
| FORBES, Hamish Drummond | Administrateur | Wickham Road Grimsby DN31 2SW North East Lincolnshire | England | British | 66295550001 | |||||||||
| HARKJAER, Per | Administrateur | Oakridge House 6 Montrose Gardens Oxshott KT22 0UU Leatherhead Surrey | England | Danish | 127032620001 | |||||||||
| LEADBEATER, Stephen Paul | Administrateur | Allt Nam Breac Mill Lane, Legbourne LN11 8LT Louth Lincolnshire | England | British | 84487230001 | |||||||||
| NOAKES, Karen Jeanette | Administrateur | Wickham Road DN31 3SW Grimsby Ross House North East Lincolnshire England | England | British | 134379900001 | |||||||||
| PARKER, Christopher Frank | Administrateur | Wickham Road Grimsby DN31 2SW North East Lincolnshire | United Kingdom | British | 66681550001 | |||||||||
| PARKER, Michael | Administrateur | Humber Lodge Old Post Office Lane South Ferriby DN18 6HH Barton Upon Humber N E Lincolnshire | United Kingdom | British | 2785890001 | |||||||||
| SHOWALTER, William John | Administrateur | 26 Chantry Lane DN31 2LJ Grimsby Wilkin Chapman Llp, Cartergate House North East Lincolnshire England | England | American | 178622380001 | |||||||||
| SHURE, Randl Louis | Administrateur | 2575 Ridge Road IRISH Charlottesville Virginia Va 22901 United States | Usa | 142036190001 | ||||||||||
| HACKWOOD DIRECTORS LIMITED | Administrateur désigné | One Silk Street EC2Y 8HQ London | 900004840001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur LIGHTHOUSE UKCO 2 LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lighthouse Ukco 1 Limited | 06 avr. 2016 | Wickham Road DN31 3SW Grimsby Ross House North East Lincolnshire England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
LIGHTHOUSE UKCO 2 LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Créé le 02 nov. 2015 Livré le 09 nov. 2015 | Totalement satisfaite | ||
Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A registered charge | Créé le 19 juil. 2013 Livré le 25 juil. 2013 | Totalement satisfaite | ||
Brève description Notification of addition to or amendment of charge. La charge flottante couvre tout: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 23 oct. 2008 Livré le 01 nov. 2008 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 21 mars 2007 Livré le 31 mars 2007 | Totalement satisfaite | Montant garanti All monies due or to become due from the company or any other obligors to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions First fixed charge all the subsidiary shares and investments and all corresponding distribution rights,all book debts and all rights and claims,all debts and monetary claims. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0