ST GILES RESIDENTIAL DEVELOPMENTS LIMITED

ST GILES RESIDENTIAL DEVELOPMENTS LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéST GILES RESIDENTIAL DEVELOPMENTS LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 06031903
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de ST GILES RESIDENTIAL DEVELOPMENTS LIMITED ?

    • Développement de projets de construction (41100) / Construction

    Où se situe ST GILES RESIDENTIAL DEVELOPMENTS LIMITED ?

    Adresse du siège social
    Henry Wood House
    2 Riding House Street
    W1W 7FA London
    United Kingdom
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de ST GILES RESIDENTIAL DEVELOPMENTS LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2014

    Quels sont les derniers dépôts pour ST GILES RESIDENTIAL DEVELOPMENTS LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Changement d'adresse du siège social de One Southampton Street London WC2R 0LR à Henry Wood House 2 Riding House Street London W1W 7FA le 15 mars 2016

    1 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Stephen William Peters en tant que directeur le 11 mars 2016

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 18 déc. 2015 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital07 janv. 2016

    État du capital au 07 janv. 2016

    • Capital: GBP 1,000
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Kevin Barry Duggan le 01 déc. 2015

    2 pagesCH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2014

    14 pagesAA

    Nomination de Stephen William Peters en tant qu'administrateur le 02 févr. 2015

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Jeffrey William Adams en tant que directeur le 02 févr. 2015

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Nicholas Stonley en tant que directeur le 02 févr. 2015

    1 pagesTM01

    Changement d'adresse du siège social de United House, Goldsel Road Swanley Kent BR8 8EX à One Southampton Street London WC2R 0LR le 13 févr. 2015

    1 pagesAD01

    Déclaration annuelle jusqu'au 18 déc. 2014 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital05 janv. 2015

    État du capital au 05 janv. 2015

    • Capital: GBP 1,000
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2013

    16 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 18 déc. 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital03 janv. 2014

    État du capital au 03 janv. 2014

    • Capital: GBP 1,000
    SH01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2012

    7 pagesAA

    Modification des coordonnées de l'administrateur Jeffrey William Adams le 31 mai 2013

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Nicholas Stonley le 01 juil. 2013

    2 pagesCH01

    Cessation de la nomination de Simon Jones en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Déclaration annuelle jusqu'au 18 déc. 2012 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    legacy

    3 pagesMG02

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2011

    7 pagesAA

    Cessation de la nomination de Andrew Mickleburgh en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de ST GILES RESIDENTIAL DEVELOPMENTS LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    DUGGAN, Kevin Barry
    2 Riding House Street
    W1W 7FA London
    Henry Wood House
    United Kingdom
    Administrateur
    2 Riding House Street
    W1W 7FA London
    Henry Wood House
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Accountant5330260003
    DRIVER, Elaine Anne
    134 Lennard Road
    BR3 1QP Beckenham
    Kent
    Secrétaire
    134 Lennard Road
    BR3 1QP Beckenham
    Kent
    British97041650002
    ADAMS, Jeffrey William
    WC2R 0LR London
    One Southampton Street
    United Kingdom
    Administrateur
    WC2R 0LR London
    One Southampton Street
    United Kingdom
    United KingdomBritishGroup Chief Executive3480850002
    BARNETT, David Melvyn
    Chepstow Villas
    W11 2QX London
    54
    Administrateur
    Chepstow Villas
    W11 2QX London
    54
    United KingdomBritishDirector39132210004
    BERG, Simon Mark
    12 Adelaide Close
    HA7 3EL Stanmore
    Middlesex
    Administrateur
    12 Adelaide Close
    HA7 3EL Stanmore
    Middlesex
    EnglandBritishDirector66989000001
    DUGGAN, Kevin Barry
    United House, Goldsel Road
    Swanley
    BR8 8EX Kent
    Administrateur
    United House, Goldsel Road
    Swanley
    BR8 8EX Kent
    EnglandBritishCompany Director5330260003
    DUGGAN, Kevin Barry
    1 Ash Tree Court
    Ash Tree Drive
    TN15 6LT West Kingsdown
    Kent
    Administrateur
    1 Ash Tree Court
    Ash Tree Drive
    TN15 6LT West Kingsdown
    Kent
    EnglandBritishManagement Accountant5330260003
    HINDLE, John David
    The Orchard
    Penshurst Road, Speldhurst
    TN3 0PJ Tunbridge Wells
    Kent
    Administrateur
    The Orchard
    Penshurst Road, Speldhurst
    TN3 0PJ Tunbridge Wells
    Kent
    United KingdomBritishChartered Engineer8481880003
    JONES, Simon David Ainslie
    United House, Goldsel Road
    Swanley
    BR8 8EX Kent
    Administrateur
    United House, Goldsel Road
    Swanley
    BR8 8EX Kent
    United KingdomBritishCompany Director156250090001
    MICKLEBURGH, Andrew Simon
    United House, Goldsel Road
    Swanley
    BR8 8EX Kent
    Administrateur
    United House, Goldsel Road
    Swanley
    BR8 8EX Kent
    EnglandBritishDirector61711010004
    MICKLEBURGH, Andrew Simon
    United House, Goldsel Road
    Swanley
    BR8 8EX Kent
    Administrateur
    United House, Goldsel Road
    Swanley
    BR8 8EX Kent
    EnglandBritishCompany Director61711010004
    PETERS, Stephen William
    WC2R 0LR London
    One Southampton Street
    United Kingdom
    Administrateur
    WC2R 0LR London
    One Southampton Street
    United Kingdom
    United KingdomBritishDevelopment Director65745290001
    PHILLIPS, Christopher Robin Leslie
    17 Greenfield Drive
    Fortes Green
    N2 9AF London
    Administrateur
    17 Greenfield Drive
    Fortes Green
    N2 9AF London
    EnglandBritishDirector46176700002
    STONLEY, Nicholas
    WC2R 0LR London
    One Southampton Street
    United Kingdom
    Administrateur
    WC2R 0LR London
    One Southampton Street
    United Kingdom
    EnglandBritishDirector129775190003

    ST GILES RESIDENTIAL DEVELOPMENTS LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Legal mortgage
    Créé le 08 févr. 2011
    Livré le 10 févr. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The mortgage property being as demised pursuant to the lease dated 17 september 2010 and being private residential accommodation at central saint giles london and the basement storage area at central saint giles london, any buildings, fixtures, fittings, fixed plant and machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Central Saint Giles Limited Partnership
    Transactions
    • 10 févr. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 05 déc. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 24 juin 2010
    Livré le 06 juil. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Right title and interest in the agreement being the sale and development agreement dated 24 may 2007 see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Central Saint Giles Limited Partnership
    Transactions
    • 06 juil. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 05 déc. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Debenture
    Créé le 10 mai 2007
    Livré le 26 mai 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to any noteholder on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Modern City Living Limited and London & Newcastle (St Giles) Limited
    Transactions
    • 26 mai 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 05 déc. 2012Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0