MORTGAGE SUPPORT SERVICES LTD
Vue d'ensemble
| Nom de la société | MORTGAGE SUPPORT SERVICES LTD |
|---|---|
| Statut de la société | Active |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 06055271 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Non |
| A un historique d'insolvabilité | Non |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe MORTGAGE SUPPORT SERVICES LTD ?
| Adresse du siège social | Suites 7&9 Regency House Miles Gray Road SS14 3FR Basildon England |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de MORTGAGE SUPPORT SERVICES LTD ?
| En retard | Non |
|---|---|
| Prochains comptes | |
| Fin de la prochaine période comptable le | 31 mars 2026 |
| Date d'échéance des prochains comptes | 31 déc. 2026 |
| Derniers comptes | |
| Derniers comptes arrêtés au | 31 mars 2025 |
Quel est le statut de la dernière déclaration de confirmation pour MORTGAGE SUPPORT SERVICES LTD ?
| Dernière déclaration de confirmation établie jusqu'au | 21 mai 2026 |
|---|---|
| Date d'échéance de la prochaine déclaration de confirmation | 04 juin 2026 |
| Dernière déclaration de confirmation | |
| Prochaine déclaration de confirmation établie jusqu'au | 21 mai 2025 |
| En retard | Non |
Quels sont les derniers dépôts pour MORTGAGE SUPPORT SERVICES LTD ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comptes consolidés établis au 31 mars 2025 | 63 pages | AA | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Statuts | 63 pages | MA | ||||||||||||||
État du capital après une attribution d'actions au 16 juil. 2025
| 7 pages | SH01 | ||||||||||||||
Inscription de la charge 060552710007, créée le 26 juin 2025 | 42 pages | MR01 | ||||||||||||||
Certificat de changement de nom Company name changed mortgage and surveying services LIMITED\certificate issued on 27/06/25 | 3 pages | CERTNM | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 21 mai 2025 avec mises à jour | 7 pages | CS01 | ||||||||||||||
État du capital après une attribution d'actions au 30 avr. 2025
| 6 pages | SH01 | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Statuts | 61 pages | MA | ||||||||||||||
Statuts | 61 pages | MA | ||||||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Comptes consolidés établis au 31 mars 2024 | 60 pages | AA | ||||||||||||||
Annulation d'actions. État du capital au 29 oct. 2024
| 9 pages | SH06 | ||||||||||||||
Rachat d'actions propres. | 4 pages | SH03 | ||||||||||||||
Changement de nom ou de désignation de la catégorie d'actions | 2 pages | SH08 | ||||||||||||||
Nomination de Mr Heath Lee Walker en tant que secrétaire le 17 sept. 2024 | 2 pages | AP03 | ||||||||||||||
Cessation de la nomination de Sarah Kate Tuck en tant que secrétaire le 17 sept. 2024 | 1 pages | TM02 | ||||||||||||||
Changement d'adresse du siège social de 3-4 Regan Way Chetwynd Business Park Chilwell Nottingham NG9 6RZ à Suites 7&9 Regency House Miles Gray Road Basildon SS14 3FR le 10 juil. 2024 | 1 pages | AD01 | ||||||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 21 mai 2024 avec mises à jour | 11 pages | CS01 | ||||||||||||||
Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Robert Martin Clifford le 03 mai 2024 | 2 pages | CH01 | ||||||||||||||
Comptes consolidés établis au 31 mars 2023 | 62 pages | AA | ||||||||||||||
Inscription de la charge 060552710006, créée le 14 sept. 2023 | 43 pages | MR01 | ||||||||||||||
Annulation d'actions. État du capital au 02 août 2023
| 12 pages | SH06 | ||||||||||||||
Rachat d'actions propres. | 4 pages | SH03 | ||||||||||||||
Qui sont les dirigeants de MORTGAGE SUPPORT SERVICES LTD ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WALKER, Heath Lee | Secrétaire | Miles Gray Road SS14 3FR Basildon Suites 7&9 Regency House England | 327283920001 | |||||||
| BREWSTER, George Pattullo | Administrateur | Regan Way Chetwynd Business Park Chilwell NG9 6RZ Nottingham 3-4 | Scotland | British | 67967330002 | |||||
| CLIFFORD, Robert Martin | Administrateur | Regan Way Chetwynd Business Park Chilwell NG9 6RZ Nottingham 3-4 | England | British | 177347450003 | |||||
| FERGUSSON, Ian James | Administrateur | Regan Way Chetwynd Business Park Chilwell NG9 6RZ Nottingham 3-4 | Scotland | British | 121573070001 | |||||
| GRATTON, Elizabeth Anne | Administrateur | Regan Way Chetwynd Business Park Chilwell NG9 6RZ Nottingham 3-4 | England | British | 124053200003 | |||||
| GRATTON, Paul Robert | Administrateur | Regan Way Chetwynd Business Park Chilwell NG9 6RZ Nottingham 3-4 | England | British | 47117090005 | |||||
| HICKLING, Christopher Charles | Administrateur | Regan Way Chetwynd Business Park Chilwell NG9 6RZ Nottingham 3-4 | England | British | 193578840001 | |||||
| HICKLING, Julia Ann | Administrateur | Regan Way Chetwynd Business Park Chilwell NG9 6RZ Nottingham 3-4 | England | British | 2439880001 | |||||
| JACKSON, Simon Paul | Administrateur | Miles Gray Road SS14 3FR Basildon Suites 7&9 Regency House England | England | British | 128766890001 | |||||
| WALKER, Heath Lee | Administrateur | Miles Gray Road SS14 3FR Basildon Suites 7&9 Regency House England | England | British | 174700320001 | |||||
| WARRINER, Stuart Neil | Administrateur | Miles Gray Road SS14 3FR Basildon Suites 7&9 Regency House England | England | British | 312196370001 | |||||
| WILLIAMS, Jill Caroline | Administrateur | Miles Gray Road SS14 3FR Basildon Suites 7&9 Regency House England | England | British | 248918880002 | |||||
| STALEY, Catherine Sara | Secrétaire | Regan Way Chetwynd Business Park Chilwell NG9 6RZ Nottingham 3-4 | British | 73310800002 | ||||||
| TUCK, Sarah Kate | Secrétaire | Miles Gray Road SS14 3FR Basildon Suites 7&9 Regency House England | 296461780001 | |||||||
| TUCK, Sarah Kate | Secrétaire | Regan Way Chetwynd Business Park Chilwell NG9 6RZ Nottingham 3-4 | 245962390001 | |||||||
| WALDRON, Karen | Secrétaire | Regan Way Chetwynd Business Park Chilwell NG9 6RZ Nottingham 3-4 | 295372000001 | |||||||
| CASTLEGATE SECRETARIES LIMITED | Secrétaire | Castle Gate NG1 7BJ Nottingham 44 Nottinghamshire | 128872830001 | |||||||
| ANDERTON, Colin James | Administrateur | Regan Way Chetwynd Business Park Chilwell NG9 6RZ Nottingham 3-4 | England | British | 183725480001 | |||||
| BLOOMER, Jonathan William | Administrateur | Regan Way Chetwynd Business Park Chilwell NG9 6RZ Nottingham 3-4 | England | British | 115487540001 | |||||
| DOWNING, Ian | Administrateur | c/o Business Growth Fund Plc Palmer Street SW1H 0AD London 21 United Kingdom | England | British | 285024490001 | |||||
| FERGUSSON, Ian James | Administrateur | 29 Park Terrace FK8 2JS Stirling Stirlingshire | Scotland | British | 121573070001 | |||||
| HICKLING, Christopher Charles | Administrateur | Wollaton House Wollaton NG8 2AH Nottingham | England | British | 2439890001 | |||||
| SINGH, Matthew | Administrateur | Regan Way Chetwynd Business Park Chilwell NG9 6RZ Nottingham 3-4 | England | British | 294957230001 | |||||
| SUNNER, Gurinder | Administrateur | Regan Way Chetwynd Business Park Chilwell NG9 6RZ Nottingham 3-4 | England | British | 278764020001 | |||||
| TAMPLIN, Nigel Vernon | Administrateur | Regan Way Chetwynd Business Park Chilwell NG9 6RZ Nottingham 3-4 | United Kingdom | British | 188794210001 | |||||
| WALL, Catherine Alison | Administrateur | Regan Way Chetwynd Business Park Chilwell NG9 6RZ Nottingham 3-4 | England | British | 37354000004 | |||||
| CASTLEGATE DIRECTORS LIMITED | Administrateur | Castle Gate NG1 7BJ Nottingham 44 Nottinghamshire | 128874440001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur MORTGAGE SUPPORT SERVICES LTD ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bgf Investment Management Limited | 01 mai 2023 | York Buildings WC2N 6JU London 13-15 England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Bgf Gp Limited | 01 oct. 2017 | York Buildings WC2N 6JU London 13-15 England | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| Business Growth Fund Plc | 06 avr. 2016 | York Buildings WC2N 6JU London 13-15 York Buildings England | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
| J&E Nominees Limited | 06 avr. 2016 | Albert Square, Meadowside DD1 1XA Dundee 13 Scotland | Oui | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0