LDC (HOLLOWAY ROAD) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéLDC (HOLLOWAY ROAD) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 06086612
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de LDC (HOLLOWAY ROAD) LIMITED ?

    • Autre location et exploitation de biens immobiliers propres ou loués (68209) / Activités immobilières

    Où se situe LDC (HOLLOWAY ROAD) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    The Core
    40 St. Thomas Street
    BS1 6JX Bristol
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de LDC (HOLLOWAY ROAD) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2014

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour LDC (HOLLOWAY ROAD) LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour LDC (HOLLOWAY ROAD) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Christopher Robert Szpojnarowicz le 09 sept. 2015

    2 pagesCH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Christopher Robert Szpojnarowicz le 02 janv. 2014

    2 pagesCH01

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Modification des coordonnées du secrétaire Mr Christopher Robert Szpojnarowicz le 09 sept. 2015

    1 pagesCH03

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2014

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 06 févr. 2015 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital27 févr. 2015

    État du capital au 27 févr. 2015

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2013

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 06 févr. 2014 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital07 mars 2014

    État du capital au 07 mars 2014

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2012

    3 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 06 févr. 2013 avec liste complète des actionnaires

    7 pagesAR01

    Cessation de la nomination de Andrew Reid en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Christopher Robert Szpojnarowicz en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Nomination de Mr Christopher Robert Szpojnarowicz en tant que secrétaire

    2 pagesAP03

    Cessation de la nomination de Andrew Reid en tant que secrétaire

    1 pagesTM02

    Déclaration annuelle jusqu'au 06 févr. 2012 avec liste complète des actionnaires

    8 pagesAR01

    Cessation de la nomination de Michael Bennett en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Mark Christopher Allan le 12 oct. 2012

    2 pagesCH01

    Comptes d'exonération totale pour petite entreprise établis au 31 déc. 2011

    4 pagesAA

    Cessation de la nomination de Michael Bennett en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de John Tonkiss en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2010

    12 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 06 févr. 2011 avec liste complète des actionnaires

    9 pagesAR01

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2009

    14 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de LDC (HOLLOWAY ROAD) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    SZPOJNAROWICZ, Christopher Robert
    40 St. Thomas Street
    BS1 6JX Bristol
    The Core
    Secrétaire
    40 St. Thomas Street
    BS1 6JX Bristol
    The Core
    British175753180001
    ALLAN, Mark Christopher
    West End
    Wickwar
    GL12 8JZ Wotton-Under-Edge
    7
    Gloucestershire
    England
    Administrateur
    West End
    Wickwar
    GL12 8JZ Wotton-Under-Edge
    7
    Gloucestershire
    England
    EnglandBritish74371010007
    LISTER, Joseph Julian
    Cooles Farmhouse
    Minety
    SN16 9QA Malmesbury
    Wiltshire
    Administrateur
    Cooles Farmhouse
    Minety
    SN16 9QA Malmesbury
    Wiltshire
    United KingdomBritish124180960001
    RICHARDS, Nicholas Guy
    Charterhouse Close
    Nailsea
    BS48 4PU Bristol
    6
    North Somerset
    Administrateur
    Charterhouse Close
    Nailsea
    BS48 4PU Bristol
    6
    North Somerset
    EnglandBritish122256380002
    SZPOJNAROWICZ, Christopher Robert
    40 St. Thomas Street
    BS1 6JX Bristol
    The Core
    Administrateur
    40 St. Thomas Street
    BS1 6JX Bristol
    The Core
    United KingdomBritish175753180001
    REID, Andrew Donald
    15 Cranbrook Road
    Redland
    BS6 7BJ Bristol
    Secrétaire
    15 Cranbrook Road
    Redland
    BS6 7BJ Bristol
    British67884910002
    BENNETT, Michael Peter
    45 Drakes Way
    Portishead
    BS20 6LD Bristol
    Administrateur
    45 Drakes Way
    Portishead
    BS20 6LD Bristol
    EnglandBritish86546430001
    GRANGER, James Winston Edward
    Southdale
    48 Greenway Lane
    BA2 4LW Bath
    Administrateur
    Southdale
    48 Greenway Lane
    BA2 4LW Bath
    EnglandBritish119802100001
    GRANGER, James Winston Edward
    Southdale
    48 Greenway Lane
    BA2 4LW Bath
    Administrateur
    Southdale
    48 Greenway Lane
    BA2 4LW Bath
    EnglandBritish119802100001
    MCDONALD, David Andrew
    Cherith
    Church Lane Chew Stoke
    BS40 8TU Bristol
    Avon
    Administrateur
    Cherith
    Church Lane Chew Stoke
    BS40 8TU Bristol
    Avon
    EnglandBritish67201010001
    RATCHFORD, Martin James
    Station Road
    Smeeth
    TN25 6SY Ashford
    The Mill House
    Kent
    United Kingdom
    Administrateur
    Station Road
    Smeeth
    TN25 6SY Ashford
    The Mill House
    Kent
    United Kingdom
    EnglandBritish255563630001
    REID, Andrew Donald
    15 Cranbrook Road
    Redland
    BS6 7BJ Bristol
    Administrateur
    15 Cranbrook Road
    Redland
    BS6 7BJ Bristol
    United KingdomBritish67884910002
    TONKISS, John Michael
    The Corner House
    16 The Glade
    B74 3NR Sutton Coldfield
    West Midlands
    Administrateur
    The Corner House
    16 The Glade
    B74 3NR Sutton Coldfield
    West Midlands
    EnglandBritish118537820001

    LDC (HOLLOWAY ROAD) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Debenture
    Créé le 24 mars 2009
    Livré le 03 avr. 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee and each of the finance parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The "Security Trustee")
    Transactions
    • 03 avr. 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 09 oct. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 01 oct. 2007
    Livré le 11 oct. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and the borrowers to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H 301 holloway road london t/no NGL861556 the rental income any present and future insurances. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Postbank Ag London Branch as Trustee for the Finance Parties (The Agent)
    Transactions
    • 11 oct. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 juil. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 28 sept. 2007
    Livré le 11 oct. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company and the borrowers to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H 301 holloway road london t/no NGL861. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Deutsche Postbank Ag London Branch as Trustee for the Finance Parties (The Agent)
    Transactions
    • 11 oct. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 juil. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 27 mars 2007
    Livré le 03 avr. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to the finance parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H property k/a 301 holloway road londo. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsh Nordbank Ag, London Branch as Trustees for the Finance Parties (The Agent)
    Transactions
    • 03 avr. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 16 févr. 2009Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0