BALTIC CONTAINER SHIPPING (UK) LIMITED

BALTIC CONTAINER SHIPPING (UK) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBALTIC CONTAINER SHIPPING (UK) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 06132793
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BALTIC CONTAINER SHIPPING (UK) LIMITED ?

    • Autres activités de soutien aux entreprises n.c.a. (82990) / Activités administratives et de soutien

    Où se situe BALTIC CONTAINER SHIPPING (UK) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    C/O FRP ADVISORY TRADING LIMITED
    Derby House 12 Winckley Square
    PR1 3JJ Preston
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de BALTIC CONTAINER SHIPPING (UK) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2021

    Quels sont les derniers dépôts pour BALTIC CONTAINER SHIPPING (UK) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    11 pagesLIQ13

    Changement d'adresse du siège social de 7 Wakehurst Road London SW11 6DB England à Derby House 12 Winckley Square Preston PR1 3JJ le 26 mai 2022

    2 pagesAD01

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 19 mai 2022

    LRESSP

    Déclaration de solvabilité

    5 pagesLIQ01

    Comptes d'exonération totale établis au 31 déc. 2021

    19 pagesAA

    Satisfaction de la charge 2 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 8 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 1 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 5 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 3 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 6 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 7 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 10 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 9 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 15 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 13 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 11 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 14 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 12 en totalité

    1 pagesMR04

    Modification des détails de Charta Leasing 3 Bv en tant que personne disposant d'un contrôle significatif le 09 mars 2022

    2 pagesPSC05

    Cessation de la nomination de Robbert-Jan Vrugt en tant que directeur le 09 mars 2022

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Ernst-Jan Van't Zelfde en tant que directeur le 09 mars 2022

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de BALTIC CONTAINER SHIPPING (UK) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BROOD, Maarten
    Herikerbergweg 238
    Amsterdam
    Tmf
    Netherlands
    Administrateur
    Herikerbergweg 238
    Amsterdam
    Tmf
    Netherlands
    NetherlandsDutchCompany Director293315800001
    SPREEUWERS, Djonie
    Herikerbergweg 238
    Amsterdam
    Tmf
    Netherlands
    Administrateur
    Herikerbergweg 238
    Amsterdam
    Tmf
    Netherlands
    NetherlandsDutchCompany Director293315720001
    CONROY, Michael John
    Mill Street
    East Malling
    ME19 6DA West Malling
    27
    Kent
    Secrétaire
    Mill Street
    East Malling
    ME19 6DA West Malling
    27
    Kent
    British110764870001
    CORNHILL SERVICES LIMITED
    Floor
    52-54 Gracechurch Street
    EC3V 0EH London
    6th
    United Kingdom
    Secrétaire
    Floor
    52-54 Gracechurch Street
    EC3V 0EH London
    6th
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement03706433
    62398320002
    CABLE, Alan Ronald Oliver
    Alpha Villas
    5 Durham Road
    DA14 6LH Sidcup
    Kent
    Administrateur
    Alpha Villas
    5 Durham Road
    DA14 6LH Sidcup
    Kent
    United KingdomBritishDirector39631140002
    HAWKINS, Darren John
    7 Wakehurst Road
    SW11 6DB London
    Administrateur
    7 Wakehurst Road
    SW11 6DB London
    EnglandEnglishDirector107766560001
    KING, Robert
    10 Stephens Lodge
    Woodside Lane
    N12 8QH London
    Administrateur
    10 Stephens Lodge
    Woodside Lane
    N12 8QH London
    BritishFinance Analyst119581820001
    VAN'T ZELFDE, Ernst-Jan
    40 Blaak
    Rotterdam
    3011ta
    Netherlands
    Administrateur
    40 Blaak
    Rotterdam
    3011ta
    Netherlands
    NetherlandsDutchCompany Director179893750001
    VRUGT, Robbert-Jan
    40 Blaak
    Rotterdam
    3011ta
    Netherlands
    Administrateur
    40 Blaak
    Rotterdam
    3011ta
    Netherlands
    NetherlandsDutchCompany Director179894030001
    CORNHILL DIRECTORS LIMITED
    Floor
    52-54 Gracechurch Street
    EC3V 0EH London
    6th
    United Kingdom
    Administrateur
    Floor
    52-54 Gracechurch Street
    EC3V 0EH London
    6th
    United Kingdom
    Type d'identificationEEE
    Numéro d'enregistrement03703864
    62398310003

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur BALTIC CONTAINER SHIPPING (UK) LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Charta Leasing 3 Bv
    Herikerbergweg 238
    Amsterdam
    Tmf
    Netherlands
    15 déc. 2016
    Herikerbergweg 238
    Amsterdam
    Tmf
    Netherlands
    Non
    Forme juridiqueCompany
    Pays d'enregistrementNetherlands
    Autorité légaleNetherlands Companies Law
    Lieu d'enregistrementNetherlands Chamber Of Commerce
    Numéro d'enregistrement58166440
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.

    BALTIC CONTAINER SHIPPING (UK) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Deed of pledge
    Créé le 25 sept. 2007
    Livré le 12 oct. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Baltic pledges to the security trustee and agrees to register and deliver to the security trustee the deeds of mortgage. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsh Nordbank Ag and Nordea Bank Ab (Publ)
    Transactions
    • 12 oct. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 avr. 2022Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of pledge
    Créé le 25 sept. 2007
    Acquis le 25 sept. 2007
    Livré le 16 oct. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Euro 52,000,000 euro 5,833,333 due or to become
    Brèves mentions
    Baltic pledges to the security trustee and agrees to register and deliver to the security trustee the deeds of mortgage. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Nsh Nordbank Ag and Nordea Bank Ab (Publ)
    Transactions
    • 16 oct. 2007Enregistrement d'une acquisition (400)
    • 19 avr. 2022Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of pledge
    Créé le 25 sept. 2007
    Acquis le 25 sept. 2007
    Livré le 16 oct. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Euro 52,000,000 and euro 5,833,333 due or to become due
    Brèves mentions
    Baltic pledges to the security trustee and agrees to register and deliver to the security trustee the deeds of mortgage. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Nsh Nordbank Ag and Nordea Bank Ab (Publ)
    Transactions
    • 16 oct. 2007Enregistrement d'une acquisition (400)
    • 19 avr. 2022Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of pledge
    Créé le 25 sept. 2007
    Acquis le 25 sept. 2007
    Livré le 16 oct. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Euro 52,000,000 and euro 5,833,333 due or to become due
    Brèves mentions
    Baltic pledges to the security trustee and agrees to register and deliver to the security trustee the deeds of mortgage. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Nsh Nordbank Ag and Nordea Bank Ab (Publ)
    Transactions
    • 16 oct. 2007Enregistrement d'une acquisition (400)
    • 19 avr. 2022Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of assignment
    Créé le 25 sept. 2007
    Livré le 12 oct. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All the owner's right title and interest present and future in and to the assigned property. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Baltic Container Shipping Limited
    Transactions
    • 12 oct. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 avr. 2022Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of assignment
    Créé le 25 sept. 2007
    Livré le 12 oct. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All the owner's right title and interest present and future in and to the assigned property. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Baltic Container Shipping Limited
    Transactions
    • 12 oct. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 avr. 2022Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of assignment
    Créé le 25 sept. 2007
    Livré le 12 oct. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All the owner's right title and interest present and future in and to the assigned property. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Baltic Container Shipping Limited
    Transactions
    • 12 oct. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 avr. 2022Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of pledge
    Créé le 25 sept. 2007
    Livré le 12 oct. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The lessee pledges to the security trustee agrees to register and deliver the deeds of mortgage. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsh Nordbank Ag and Nordea Bank Ab (Publ)
    Transactions
    • 12 oct. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 avr. 2022Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of pledge
    Créé le 25 sept. 2007
    Livré le 12 oct. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    To register and deliver the deeds of mortgage. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsh Nordbank Ag and Nordea Bank Ab (Publ)
    Transactions
    • 12 oct. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 19 avr. 2022Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of pledge
    Créé le 18 avr. 2007
    Acquis le 25 sept. 2007
    Livré le 15 oct. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Euro 5,833,333 due or to become due
    Brèves mentions
    The mortgage deed, being the second priority swedish ship mortgage deed with journal number 1825 registered against the vessel and as a second priority pledge the first mortgage deed. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Nordea Bank Ab (Publ)
    Transactions
    • 15 oct. 2007Enregistrement d'une acquisition (400)
    • 19 avr. 2022Satisfaction d'une charge (MR04)
    First priority deed of pledge
    Créé le 18 avr. 2007
    Acquis le 25 sept. 2007
    Livré le 15 oct. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Euro 52,000,000 due or to become due
    Brèves mentions
    First priority swedish ship mortgage deed with journal number 1824 registered against M.V. transtimber. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsh Nordbank Ag
    Transactions
    • 15 oct. 2007Enregistrement d'une acquisition (400)
    • 19 avr. 2022Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of pledge
    Créé le 08 déc. 2006
    Acquis le 25 sept. 2007
    Livré le 15 oct. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Euro 5,833,333 due or to become due
    Brèves mentions
    The mortgage deed, being the second priority swedish ship mortgage deed with journal number 5409 registered against the vessel and as a second priority pledge the first mortgage deed. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Nordea Bank Ab (Publ)
    Transactions
    • 15 oct. 2007Enregistrement d'une acquisition (400)
    • 19 avr. 2022Satisfaction d'une charge (MR04)
    First priority deed of pledge
    Créé le 08 déc. 2006
    Acquis le 25 sept. 2007
    Livré le 15 oct. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Euro 52,000,000 due or to become due
    Brèves mentions
    First priority swedish ship mortgage deed with journal number 5408 registered against M.V. transpulp. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsh Nordbank Ag
    Transactions
    • 15 oct. 2007Enregistrement d'une acquisition (400)
    • 19 avr. 2022Satisfaction d'une charge (MR04)
    Deed of pledge
    Créé le 18 août 2006
    Acquis le 25 sept. 2007
    Livré le 15 oct. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Euro 5,833,333 due or to become due
    Brèves mentions
    The mortgage deed, being the second priority swedish ship mortgage deed with journal number 3385 registered against the vessel and as a second priority pledge the first mortgage deed. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Nordea Bank Ab (Publ)
    Transactions
    • 15 oct. 2007Enregistrement d'une acquisition (400)
    • 19 avr. 2022Satisfaction d'une charge (MR04)
    First priority deed of pledge
    Créé le 18 août 2006
    Acquis le 25 sept. 2007
    Livré le 15 oct. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    Euro 52,000,000 due or to become due
    Brèves mentions
    First priority swedish ship mortgage deed with journal number 3384 registered against M.V. transpaper. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsh Nordbank Ag
    Transactions
    • 15 oct. 2007Enregistrement d'une acquisition (400)
    • 19 avr. 2022Satisfaction d'une charge (MR04)

    BALTIC CONTAINER SHIPPING (UK) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    17 mai 2023Due to be dissolved on
    19 mai 2022Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    David Robert Acland
    Derby House 12 Winckley Square
    PR1 3JJ Preston
    practitioner
    Derby House 12 Winckley Square
    PR1 3JJ Preston
    Lila Thomas
    Derby House 12 Winckley Square
    PR1 3JJ Preston
    Lancashire
    practitioner
    Derby House 12 Winckley Square
    PR1 3JJ Preston
    Lancashire

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0