LISSETT AIRFIELD (HOLDINGS) LIMITED
Vue d'ensemble
| Nom de la société | LISSETT AIRFIELD (HOLDINGS) LIMITED |
|---|---|
| Statut de la société | Dissoute |
| Forme juridique | Société à responsabilité limitée |
| Numéro de société | 06137133 |
| Juridiction | Angleterre/Pays de Galles |
| Date de création | |
| Date de cessation d'activité |
Résumé
| A des PSCs super sécurisés | Non |
|---|---|
| A des charges | Oui |
| A un historique d'insolvabilité | Oui |
| Le siège social est contesté | Non |
Où se situe LISSETT AIRFIELD (HOLDINGS) LIMITED ?
| Adresse du siège social | 1 More London Place SE1 2AF London |
|---|---|
| Adresse du siège social non livrable | Non |
Quels sont les derniers comptes de LISSETT AIRFIELD (HOLDINGS) LIMITED ?
| Derniers comptes | |
|---|---|
| Derniers comptes arrêtés au | 31 déc. 2017 |
Quels sont les derniers dépôts pour LISSETT AIRFIELD (HOLDINGS) LIMITED ?
| Date | Description | Document | Type | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation | 1 pages | GAZ2 | ||||||||||
Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres | 12 pages | LIQ13 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2019 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Les registres ont été transférés au lieu d'inspection enregistré 16 st Martin's Le Grand St Martins House London EC1A 4EN | 2 pages | AD03 | ||||||||||
L'adresse d'inspection du registre a été modifiée à 16 st Martin's Le Grand St Martins House London EC1A 4EN | 2 pages | AD02 | ||||||||||
Changement d'adresse du siège social de C/O Morton Fraser Llp St Martins House 16 st Martins Le Grand London EC1A 4EN à 1 More London Place London SE1 2AF le 08 janv. 2020 | 2 pages | AD01 | ||||||||||
Déclaration de solvabilité | 7 pages | LIQ01 | ||||||||||
Nomination d'un liquidateur volontaire | 3 pages | 600 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 1 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Cessation de la nomination de David Mel Zuydam en tant que directeur le 01 janv. 2020 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Période comptable précédente prolongée du 31 déc. 2018 au 30 juin 2019 | 1 pages | AA01 | ||||||||||
Nomination de Mr David Mel Zuydam en tant qu'administrateur le 11 juil. 2019 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Katerina Brown en tant que directeur le 04 juil. 2019 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Scott Leitch Mackenzie en tant que directeur le 30 janv. 2019 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Déclaration de confirmation établie le 31 déc. 2018 sans mise à jour | 3 pages | CS01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Andrew William Lee en tant que directeur le 05 déc. 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Mark Alan Walters en tant que directeur le 05 déc. 2018 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 13 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Comptes pour une société dormante établis au 31 déc. 2017 | 1 pages | AA | ||||||||||
Résolutions Resolutions | 14 pages | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Nomination de Mark Alan Walters en tant qu'administrateur | 3 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mark Alan Walters en tant qu'administrateur le 14 déc. 2017 | 2 pages | AP01 | ||||||||||
Cessation de la nomination de Michael Nagle en tant que directeur le 14 déc. 2017 | 1 pages | TM01 | ||||||||||
Nomination de Mr Andrew William Lee en tant qu'administrateur le 14 déc. 2017 | 3 pages | AP01 | ||||||||||
Nomination de Mr David Huw Griffiths en tant qu'administrateur le 14 déc. 2017 | 3 pages | AP01 | ||||||||||
Qui sont les dirigeants de LISSETT AIRFIELD (HOLDINGS) LIMITED ?
| Nom | Nommé le | Date de démission | Rôle | Adresse | Identification de la société | Pays de résidence | Nationalité | Date de naissance | Profession | Numéro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MORTON FRASER SECRETARIES LIMITED | Secrétaire | 2 Lister Square Quartermile Two EH3 9GL Edinburgh 5th Floor Scotland |
| 95512800001 | ||||||||||
| GRIFFITHS, David Huw | Administrateur | c/o Morton Fraser Llp 16 St. Martin's Le Grand EC1A 4EN London St Martins House | United Kingdom | British | 177733400003 | |||||||||
| ATTERBURY, Karen Lorraine | Secrétaire | Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor, 500 Pavilion Drive England | 201246720001 | |||||||||||
| BISSET, Graham Ferguson | Secrétaire | Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor 500 Pavilion Drive Northamptonshire United Kingdom | 194566850001 | |||||||||||
| CALDER, Samantha Jane | Secrétaire | 500 Pavilion Drive Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor | British | 75830790003 | ||||||||||
| HULLEY, Christine Wyn | Secrétaire | 18 Knights Meadow CW7 2DL Winsford Cheshire | British | 35745290002 | ||||||||||
| LONG, Jacqueline | Secrétaire | Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor 500 Pavilion Drive United Kingdom | 204213410001 | |||||||||||
| OLDROYD, Elizabeth Alexandra | Secrétaire | 19 Middle Stoke Limpley Stoke BA2 7GF Bath | British | 98205520001 | ||||||||||
| AIKMAN, Elizabeth Jane | Administrateur | 500 Pavilion Drive Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor United Kingdom | United Kingdom | British | 294355310001 | |||||||||
| BOYD, Gordon Alexander | Administrateur | 500 Pavilion Drive Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor United Kingdom | England | British | 148856600001 | |||||||||
| BROWN, Katerina | Administrateur | St Martins House 16 St Martins Le Grand EC1A 4EN London C/O Morton Fraser Llp | Scotland | British | 232165890001 | |||||||||
| BUXTON, Tony Martyn | Administrateur | Oaklands Somerford Road GL7 1FA Cirencester 33 Glos United Kingdom | England | British | 132588550002 | |||||||||
| FITZSIMMONS, David Stephen | Administrateur | Hammer Tower Penshurst TN11 8HZ Tonbridge Kent | United Kingdom | British | 109928450001 | |||||||||
| GIBBINS, Stewart Charles | Administrateur | 500 Pavilion Drive Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor United Kingdom | United Kingdom | British | 148918290002 | |||||||||
| GREGSON, Paul Jonathan | Administrateur | 500 Pavilion Drive Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor United Kingdom | England | British | 154908310001 | |||||||||
| HARDMAN, Steven Neville | Administrateur | 500 Pavilion Drive Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor United Kingdom | Uk | British | 93743250007 | |||||||||
| HEWSON, John Francis | Administrateur | 30 Bedford Street London WC2E 9ED | United Kingdom | British | 120308140001 | |||||||||
| HINTON, Thomas Edward | Administrateur | Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor, 500 Pavilion Drive England | United Kingdom | British | 238940970001 | |||||||||
| HULLEY, Christine Wyn | Administrateur | 18 Knights Meadow CW7 2DL Winsford Cheshire | British | 35745290002 | ||||||||||
| HULLEY, Stephen Paul | Administrateur | 18 Knights Meadow CW7 2DL Winsford Cheshire | British | 58163070002 | ||||||||||
| LEE, Andrew William | Administrateur | c/o Morton Fraser Llp 16 St. Martin's Le Grand EC1A 4EN London St Martins House | United Kingdom | British | 87527870001 | |||||||||
| MACHIELS, Eric Philippe Marianne | Administrateur | 500 Pavilion Drive Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor United Kingdom | England | Belgian | 125748990002 | |||||||||
| MACKENZIE, Scott Leitch | Administrateur | St Martins House 16 St Martins Le Grand EC1A 4EN London C/O Morton Fraser Llp | United Kingdom | British | 277478140001 | |||||||||
| NAGLE, Michael | Administrateur | St Martins House 16 St Martins Le Grand EC1A 4EN London C/O Morton Fraser Llp | United Kingdom | British | 29436380007 | |||||||||
| PICKERING, Stephen Shane | Administrateur | Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor, 500 Pavilion Drive England | United Kingdom | British | 198076630001 | |||||||||
| QUINLAN, Rory John | Administrateur | Flat 12 25 Queen's Gate Gardens South Kensington SW7 5RP London | Australian | 113941780001 | ||||||||||
| ROUND, Richard Calvin | Administrateur | Elimbriar 8 Station Road Stanbridge LU7 9JF Leighton Buzzard Beds | Uk | British | 108158250002 | |||||||||
| WALTERS, Mark Alan | Administrateur | St Martins House 16 St Martins Le Grand EC1A 4EN London C/O Morton Fraser Llp | England | British | 317548840001 | |||||||||
| ZUYDAM, David Mel | Administrateur | St Martins House 16 St Martins Le Grand EC1A 4EN London C/O Morton Fraser Llp | England | British | 259635370001 |
Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur LISSETT AIRFIELD (HOLDINGS) LIMITED ?
| Nom | Notifié le | Adresse | Cessé | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Infinis Wind Holdings Limited | 06 avr. 2016 | Northampton Business Park NN4 7YJ Northampton First Floor, 500 Pavilion Drive England | Non | ||||||||||
| |||||||||||||
Nature du contrôle
| |||||||||||||
LISSETT AIRFIELD (HOLDINGS) LIMITED a-t-elle des charges ?
| Classification | Dates | Statut | Détails | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Créé le 15 déc. 2017 Livré le 29 d éc. 2017 | En cours | ||
La charge flottante couvre tout: Oui Contient une promesse négative: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| A registered charge | Créé le 09 oct. 2013 Livré le 11 oct. 2013 | Totalement satisfaite | ||
Brève description Intellectual property. The chargor charges, by way of first fixed charge, all of the rights which it now has and all of the rights which it obtains at any time in the future in intellectual property.. Intellectual property means:. (A) all copyright (including rights in computer software), patents, trade marks, trade names, service marks, business names (including internet domain names), design rights, database rights, semi-conductor topography rights and all other intellectual property or similar proprietary rights (whether registered or not and including applications to register or rights to apply for registration) which, in each case, are of a type which are not disposed of in the ordinary course of trading;. (B) any intellectual property that supplements or replaces intellectual property described in (a) above; and. (C) any intellectual property acquired after the date of this deed which is designated as intellectual property by a chargor and the security agent at or about the time of its acquisition. Notification of addition to or amendment of charge. La charge flottante couvre tout: Oui Contient une charge flottante: Oui Contient une charge fixe: Oui | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
| Debenture | Créé le 19 nov. 2007 Livré le 26 nov. 2007 | Totalement satisfaite | Montant garanti All sums due or to become due under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Brèves mentions Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Personnes ayant droit
| ||||
Transactions
| ||||
LISSETT AIRFIELD (HOLDINGS) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?
| Numéro de dossier | Dates | Type | Praticiens | Autre | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Members voluntary liquidation |
|
Source de données
- Companies House du Royaume-Uni
Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers. - Licence: CC0