HAWKSTONE BIDCO LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Bilan annuel
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéHAWKSTONE BIDCO LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 06138538
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéNon
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de HAWKSTONE BIDCO LIMITED ?

    • Société inactive (99999) / Activités des organisations et organismes extraterritoriaux

    Où se situe HAWKSTONE BIDCO LIMITED ?

    Adresse du siège social
    The Inspire
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    North Yorkshire
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de HAWKSTONE BIDCO LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    BANGLEMIST LIMITED05 mars 200705 mars 2007

    Quels sont les derniers comptes de HAWKSTONE BIDCO LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2013

    Quel est le statut du dernier bilan annuel pour HAWKSTONE BIDCO LIMITED ?

    Bilan annuel
    Dernier bilan annuel

    Quels sont les derniers dépôts pour HAWKSTONE BIDCO LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Bulletin officiel final dissous par radiation volontaire

    1 pagesGAZ2(A)

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01
    A3MAJ7BS

    Nomination de Mr James Alexander Burrell en tant qu'administrateur le 10 nov. 2014

    2 pagesAP01
    X3LCCXAX

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2013

    19 pagesAA
    A3ERCF77

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    4 pagesMR04
    L3AYISN6

    Inscription de la charge 061385380005, créée le 12 juin 2014

    92 pagesMR01
    A3AA6GIG

    Satisfaction de la charge 2 en totalité

    1 pagesMR04
    X39AMSSJ

    Satisfaction de la charge 3 en totalité

    1 pagesMR04
    X39AMSVN

    Déclaration annuelle jusqu'au 05 mars 2014 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital05 mars 2014

    État du capital au 05 mars 2014

    • Capital: GBP 1
    SH01
    X330KES1

    Nomination de Mrs Geraldine Josephine Gallagher en tant qu'administrateur le 31 janv. 2014

    2 pagesAP01
    X31NAH7E

    Cessation de la nomination de Matthew Edward Bennison en tant que directeur le 31 janv. 2014

    1 pagesTM01
    X3156W4P

    Cessation de la nomination de Matthew Edward Bennison en tant que secrétaire le 31 janv. 2014

    1 pagesTM02
    X3156VW7

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2012

    18 pagesAA
    A2H53BHS

    Déclaration des objets de la société

    2 pagesCC04
    A2614M5K

    Résolutions

    Resolutions
    11 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    incorporation

    Résolution d'adoption des statuts

    RES01

    Déclaration annuelle jusqu'au 05 mars 2013 avec liste complète des actionnaires

    5 pagesAR01
    X23N5LC8

    legacy

    18 pagesMG01
    A239BLK0

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2011

    20 pagesAA
    A1I7CIH6

    Déclaration annuelle jusqu'au 05 mars 2012 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01
    X142LUMG

    legacy

    14 pagesMG01
    ADXLUZYW

    Comptes annuels établis au 31 déc. 2010

    22 pagesAA
    ASS40YUQ

    Nomination de Mr Matthew Edward Bennison en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01
    X9PN1W1G

    Nomination de Mr Matthew Edward Bennison en tant que secrétaire

    1 pagesAP03
    X9PO9W1P

    Cessation de la nomination de Timothy Doubleday en tant que directeur

    1 pagesTM01
    X9PK9W1L

    Qui sont les dirigeants de HAWKSTONE BIDCO LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BURRELL, James Alexander
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    Administrateur
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United KingdomBritishAccountant192486560001
    GALLAGHER, Geraldine Josephine
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandIrishFinance Director185108770001
    HUNTER, Gail Susan
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishHuman Resources Director89557480002
    TROY, Anthony Gerrard
    Fountains Bent
    Darley Road, Bristwith
    HG3 2PN Harrogate
    North Yorkshire
    Administrateur
    Fountains Bent
    Darley Road, Bristwith
    HG3 2PN Harrogate
    North Yorkshire
    United KingdomIrishDirector104500230001
    BENNISON, Matthew Edward
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    161785830001
    DOUBLEDAY, Timothy
    Hornbeam Park
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Secrétaire
    Hornbeam Park
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    British156120950001
    GALLAGHER, Geraldine Josephine
    Risplith House
    HG4 3EP Risplith
    North Yorkshire
    Secrétaire
    Risplith House
    HG4 3EP Risplith
    North Yorkshire
    Irish185108770001
    CLIFFORD CHANCE SECRETARIES LIMITED
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Secrétaire désigné
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    900005620001
    BENNISON, Matthew Edward
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Hornbeam Square West
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    EnglandBritishCompany Director108534390002
    DAY, Mark
    Welton Hill
    Kidd Lane
    HU15 1PH Welton Brough
    North Humberside
    Administrateur
    Welton Hill
    Kidd Lane
    HU15 1PH Welton Brough
    North Humberside
    EnglandBritishDirector124446000001
    DOUBLEDAY, Timothy John
    Hornbeam Park
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    Administrateur
    Hornbeam Park
    HG2 8PA Harrogate
    The Inspire
    North Yorkshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishChief Financial Officer91011320001
    LEVY, Adrian Joseph Morris
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Administrateur
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    United KingdomBritishSolicitor147682410001
    NISBETT, Paul Sandle
    The Grove
    Bletchley
    MK3 6BZ Milton Keynes
    5
    Buckinghamshire
    Administrateur
    The Grove
    Bletchley
    MK3 6BZ Milton Keynes
    5
    Buckinghamshire
    EnglandBritishCompany Director132613500001
    PUDGE, David John
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    Administrateur
    10 Upper Bank Street
    E14 5JJ London
    United KingdomBritishSolicitor162620820001

    HAWKSTONE BIDCO LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 12 juin 2014
    Livré le 18 juin 2014
    En cours
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Cbre Loan Servicing Limited
    Transactions
    • 18 juin 2014Enregistrement d'une charge (MR01)
    English law deed of accession
    Créé le 27 févr. 2013
    Livré le 01 mars 2013
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from each obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Citicorp Trustee Company Limited
    Transactions
    • 01 mars 2013Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 27 juin 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 01 déc. 2011
    Livré le 10 déc. 2011
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any obligor or chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Bank of Scotland PLC
    Transactions
    • 10 déc. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 03 juin 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 25 mai 2007
    Livré le 30 mai 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transactions
    • 30 mai 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 juin 2014Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 04 avr. 2007
    Livré le 16 avr. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from any obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Agent)
    Transactions
    • 16 avr. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 07 sept. 2007Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0