FINDON URBAN LOFTS (BBB) LIMITED

FINDON URBAN LOFTS (BBB) LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéFINDON URBAN LOFTS (BBB) LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 06177716
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de FINDON URBAN LOFTS (BBB) LIMITED ?

    • Développement de projets de construction (41100) / Construction

    Où se situe FINDON URBAN LOFTS (BBB) LIMITED ?

    Adresse du siège social
    1 Kings Avenue
    Winchmore Hill
    N21 3NA London
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de FINDON URBAN LOFTS (BBB) LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 déc. 2014

    Quels sont les derniers dépôts pour FINDON URBAN LOFTS (BBB) LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des créanciers

    7 pages4.72

    Changement d'adresse du siège social de 1st Floor (North) Devonshire House Devonshire Street London W1W 5DS à 1 Kings Avenue Winchmore Hill London N21 3NA le 01 déc. 2015

    2 pagesAD01

    Deuxième dépôt de AP01 précédemment soumis à Companies House

    5 pagesRP04
    Annotations
    DateAnnotation
    30 nov. 2015Clarification Second filed AP01 for Constantin Balau.

    Déclaration des affaires avec le formulaire 4.19 attaché

    6 pages4.20

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    1 pages600

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution extraordinaire pour la liquidation au 20 nov. 2015

    LRESEX

    Cessation de la nomination de Nicos Avraamides en tant que directeur le 05 nov. 2015

    1 pagesTM01

    Nomination de Mr Constantin Balau en tant qu'administrateur le 05 nov. 2015

    3 pagesAP01
    Annotations
    DateAnnotation
    30 nov. 2015Clarification A second filed AP01 was registered on 30th November 2015.

    La procédure de radiation volontaire a été suspendue.

    1 pagesSOAS(A)

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2014

    6 pagesAA

    Premier avis au Bulletin officiel pour la radiation volontaire

    1 pagesGAZ1(A)

    Demande de radiation de la société du registre du commerce

    3 pagesDS01

    Démission de l'auditeur

    1 pagesAUD

    Déclaration annuelle jusqu'au 22 mars 2015 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital30 mars 2015

    État du capital au 30 mars 2015

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2013

    7 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 22 mars 2014 avec liste complète des actionnaires

    3 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital02 avr. 2014

    État du capital au 02 avr. 2014

    • Capital: GBP 100
    SH01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Nicos Avraamides le 30 avr. 2013

    2 pagesCH01

    Comptes pour une petite entreprise établis au 31 déc. 2012

    6 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 22 mars 2013 avec liste complète des actionnaires

    4 pagesAR01

    Nomination de Mr Nicos Avraamides en tant qu'administrateur

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Yotam Yinhal en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Cessation de la nomination de Peter Petrou en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Changement d'adresse du siège social de * 18-22 Wigmore Street London W1U 2RG* le 13 mai 2013

    1 pagesAD01

    Cessation de la nomination de Ionel Cringasu en tant que directeur

    1 pagesTM01

    Qui sont les dirigeants de FINDON URBAN LOFTS (BBB) LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    BALAU, Constantin
    Gordon House Road
    NW5 1LP London
    Unit 10 Spectrum House
    England
    Administrateur
    Gordon House Road
    NW5 1LP London
    Unit 10 Spectrum House
    England
    RomaniaRomanianBusinessman202420260001
    YINHAL, Yotam
    Nethercourt Avenue
    Finchley
    N3 1PT London
    30
    United Kingdom
    Secrétaire
    Nethercourt Avenue
    Finchley
    N3 1PT London
    30
    United Kingdom
    IsraeliAccountant121530580001
    QA REGISTRARS LIMITED
    The Studio
    St Nicholas Close
    WD6 3EW Elstree
    Hertfordshire
    Secrétaire
    The Studio
    St Nicholas Close
    WD6 3EW Elstree
    Hertfordshire
    118891220001
    AVRAAMIDES, Nicos
    Gordon House Road
    Kentish Town
    NW5 1LP London
    Unit 17
    England
    Administrateur
    Gordon House Road
    Kentish Town
    NW5 1LP London
    Unit 17
    England
    CyprusCypriotDirector178199290001
    CRINGASU, Ionel
    32-34 Gordon House Road
    NW5 1LP London
    Unit 17 Spectrum House
    Administrateur
    32-34 Gordon House Road
    NW5 1LP London
    Unit 17 Spectrum House
    RomaniaRomanianDirector170075700001
    PETROU, Peter
    18-22 Wigmore Street
    W1U 2RG London
    Flat 7
    England
    Administrateur
    18-22 Wigmore Street
    W1U 2RG London
    Flat 7
    England
    EnglandBritishAccountant154623050001
    PETROU, Peter
    18-22 Flat 7
    Wigmore Street
    W1U 2RG London
    Administrateur
    18-22 Flat 7
    Wigmore Street
    W1U 2RG London
    EnglandBritishAccountant154623050001
    YINHAL, Yotam
    Spectrum House
    32-34 Gordon House Road
    NW5 1LP London
    Unit 17
    England
    Administrateur
    Spectrum House
    32-34 Gordon House Road
    NW5 1LP London
    Unit 17
    England
    United KingdomIsraeliBusinessman159618670001
    YINHAL, Yotam
    Nethercourt Avenue
    Finchley
    N3 1PT London
    30
    United Kingdom
    Administrateur
    Nethercourt Avenue
    Finchley
    N3 1PT London
    30
    United Kingdom
    United KingdomIsraeliAccountant157402620001
    QA NOMINEES LIMITED
    The Studio
    St Nicholas Close
    WD6 3EW Elstree
    Hertfordshire
    Administrateur
    The Studio
    St Nicholas Close
    WD6 3EW Elstree
    Hertfordshire
    118891210001

    FINDON URBAN LOFTS (BBB) LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Deed of rent charge
    Créé le 11 oct. 2011
    Livré le 12 oct. 2011
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    By way of first fixed charge all rents now and in the future owing to it in respect of the property and all monies standing to the credit of the rent account see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Mizrahi Tefahot Bank Limited
    Transactions
    • 12 oct. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    Legal charge
    Créé le 11 oct. 2011
    Livré le 12 oct. 2011
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The flats 112 and 411 and the f/h of 195-205 richmond road london t/no 369807.
    Personnes ayant droit
    • Mizrahi Tefahot Bank Limited
    Transactions
    • 12 oct. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    Debenture
    Créé le 11 oct. 2011
    Livré le 12 oct. 2011
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Mizrahi Tefahot Bank Limited
    Transactions
    • 12 oct. 2011Enregistrement d'une charge (MG01)
    Legal charge
    Créé le 08 sept. 2010
    Livré le 11 sept. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H 195-197 richmond road london t/no EGL318159 see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Dunbar Bank PLC
    Transactions
    • 11 sept. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 18 oct. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Letter of set off
    Créé le 08 sept. 2010
    Livré le 11 sept. 2010
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All monies from time to time held to the credit of the company in or earned by the company on a designated account (the deposit) maintained by the company with the bank.
    Personnes ayant droit
    • Dunbar Bank PLC
    Transactions
    • 11 sept. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 18 oct. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Charge over construction contract
    Créé le 03 juin 2009
    Livré le 04 juin 2009
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All rights title and interest in and to the contract by way of equitable charge its benefit in all appointments contracts guarantees undertakings and warranties in relation to the development see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Dunbar Bank PLC
    Transactions
    • 04 juin 2009Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 oct. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Charge over agreement for lease and development agreement
    Créé le 15 août 2008
    Livré le 20 août 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All its present and future rights, title and interest in and to the agreements meaning the agreement for lease and the development agreement respectively dated 30 july 2008. see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Dunbar Bank PLC
    Transactions
    • 20 août 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 oct. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Floating charge
    Créé le 15 août 2008
    Livré le 20 août 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    By way of a first floating charge all the undertaking and assets of the company whatsoever and wheresoever both present and future see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Dunbar Bank PLC
    Transactions
    • 20 août 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 oct. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Legal charge
    Créé le 15 août 2008
    Livré le 20 août 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H land k/a 199-205 (odd numbers), richmond road, london t/NO369807. All rights to and interest in any insurances in respect of the property the gross rents licence fees and other monies receivable in respect of the property (the rental income) all interest and rights under any contracts or agreements or claims for or in respect of the sale purchase leasing mortgaging management carrying out of works to development or redevelopment of or other dealing with or ownership of the property or any part thereof the goodwill of any business and floating charge all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment now or from time to time at the property.
    Personnes ayant droit
    • Dunbar Bank PLC
    Transactions
    • 20 août 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 18 oct. 2011Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (MG02)
    Second legal charge
    Créé le 23 nov. 2007
    Livré le 28 nov. 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H 199, 201 203 and 205 richmond road hackney london t/no 369807.
    Personnes ayant droit
    • Ziv Haft Trusts Company LTD
    Transactions
    • 28 nov. 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 août 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Legal charge
    Créé le 01 juin 2007
    Livré le 06 juin 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    F/H property k/a 199-205 richmond road hackney t/n EGL251395 and 369807 any shares or membership. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Marfin Popular Bank Public Co LTD
    Transactions
    • 06 juin 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 août 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)
    Debenture
    Créé le 01 juin 2007
    Livré le 06 juin 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Personnes ayant droit
    • Marfin Popular Bank Co LTD
    Transactions
    • 06 juin 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 29 août 2008Déclaration de satisfaction d'une charge en totalité ou en partie (403a)

    FINDON URBAN LOFTS (BBB) LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    20 nov. 2015Commencement of winding up
    15 nov. 2016Dissolved on
    Creditors voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Ninos Koumettou
    Alexander Lawson & Co
    1 Kings Avenue
    N21 3NA Winchmore Hill
    London
    practitioner
    Alexander Lawson & Co
    1 Kings Avenue
    N21 3NA Winchmore Hill
    London

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0