BRABCO 719 LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéBRABCO 719 LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 06219344
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de BRABCO 719 LIMITED ?

    • Développement de projets de construction (41100) / Construction

    Où se situe BRABCO 719 LIMITED ?

    Adresse du siège social
    C/O Mercury Corporate Recovery Solutions Ltd Birkdale Terrace
    346 Chester Road
    M16 9EZ Manchester
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels sont les derniers comptes de BRABCO 719 LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au09 sept. 2020

    Quels sont les derniers dépôts pour BRABCO 719 LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Retour de la réunion finale dans une liquidation volontaire des membres

    12 pagesLIQ13

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 08 sept. 2022

    12 pagesLIQ03

    Changement d'adresse du siège social de C/O Mercury Corporate Recovery Solutions Ltd Empress Business Centre 380 Chester Road Manchester United Kingdom à C/O Mercury Corporate Recovery Solutions Ltd Birkdale Terrace 346 Chester Road Manchester M16 9EZ le 05 sept. 2022

    2 pagesAD01

    Avis au Registre du commerce et des sociétés de l'avis de désistement

    5 pagesNDISC

    Déclaration des reçus et paiements des liquidateurs jusqu'à 08 sept. 2021

    11 pagesLIQ03

    Comptes de micro-entité établis au 09 sept. 2020

    3 pagesAA

    Comptes de micro-entité établis au 31 mars 2020

    3 pagesAA

    Période comptable précédente raccourcie du 31 mars 2021 au 09 sept. 2020

    1 pagesAA01

    Changement d'adresse du siège social de 30 Tabley Street Liverpool L1 8DB à C/O Mercury Corporate Recovery Solutions Ltd Empress Business Centre 380 Chester Road Manchester le 21 sept. 2020

    1 pagesAD01

    Déclaration de solvabilité

    5 pagesLIQ01

    Résolutions

    Resolutions
    1 pagesRESOLUTIONS
    Résolutions
    CatégorieDateDescriptionType
    liquidation

    Résolution spéciale pour la liquidation au 09 sept. 2020

    LRESSP

    Nomination d'un liquidateur volontaire

    3 pages600

    Déclaration de confirmation établie le 08 janv. 2020 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes de micro-entité établis au 31 mars 2019

    2 pagesAA

    Satisfaction de la charge 4 en totalité

    2 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 1 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 11 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 2 en totalité

    2 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 5 en totalité

    1 pagesMR04

    Satisfaction de la charge 3 en totalité

    1 pagesMR04

    Déclaration de confirmation établie le 25 janv. 2019 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes de micro-entité établis au 31 mars 2018

    2 pagesAA

    Déclaration de confirmation établie le 25 janv. 2018 sans mise à jour

    3 pagesCS01

    Comptes de micro-entité établis au 31 mars 2017

    2 pagesAA

    Qui sont les dirigeants de BRABCO 719 LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    PRICHARD, Brigette Jane
    Hodge Hill Hall
    Cartmel Fell
    LA11 6NQ Grange Over Sands
    Cumbria
    Secrétaire
    Hodge Hill Hall
    Cartmel Fell
    LA11 6NQ Grange Over Sands
    Cumbria
    British107711780001
    PRICHARD, Jonathon Simon
    Hodge Hill Hall
    Cartmel Fell
    LA11 6NQ Grange Over Sands
    Cumbria
    Administrateur
    Hodge Hill Hall
    Cartmel Fell
    LA11 6NQ Grange Over Sands
    Cumbria
    EnglandBritishArchitect91666330001
    BRABNERS SECRETARIES LIMITED
    1 Dale Street
    L2 2PP Liverpool
    Merseyside
    Secrétaire
    1 Dale Street
    L2 2PP Liverpool
    Merseyside
    79429720001
    BRABNERS DIRECTORS LIMITED
    1 Dale Street
    L2 2PP Liverpool
    Merseyside
    Administrateur
    1 Dale Street
    L2 2PP Liverpool
    Merseyside
    79429560001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur BRABCO 719 LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Mr Jonathon Simon Prichard
    Birkdale Terrace
    346 Chester Road
    M16 9EZ Manchester
    C/O Mercury Corporate Recovery Solutions Ltd
    06 avr. 2016
    Birkdale Terrace
    346 Chester Road
    M16 9EZ Manchester
    C/O Mercury Corporate Recovery Solutions Ltd
    Non
    Nationalité: British
    Pays de résidence: United Kingdom
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, le droit de nommer ou de révoquer une majorité des membres du conseil d'administration de la société.

    BRABCO 719 LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    Assignment of rental income
    Créé le 13 avr. 2012
    Livré le 27 avr. 2012
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    All right title and interest in and to the rental income see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Investec Bank PLC
    Transactions
    • 27 avr. 2012Enregistrement d'une charge (MG01)
    • 22 août 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Assignment of building contract
    Créé le 24 juin 2008
    Livré le 03 juil. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Brèves mentions
    The assigned documents being the agreement and all collateral instruments arising there from see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 03 juil. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 juin 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Assignment of agreement for lease
    Créé le 24 juin 2008
    Livré le 03 juil. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    The assigned documents being the agreements and all collateral instruments arising there from;.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 03 juil. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 juin 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Assignment of agreement for lease development agreement and guarantee
    Créé le 24 juin 2008
    Livré le 03 juil. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All rights title benefit and interest in the assigned documents see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 03 juil. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 juin 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Mortgage
    Créé le 14 avr. 2008
    Livré le 19 avr. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Development site k/a kings dock mill, the strand, liverpool also k/a land bounded by hurst street, tabley street, cornhill and shaw alley, liverpool together with all buildings & fixtures (including trade fixtures). Fixed plant & machinery by way of fixed charge, all present & future book & other debts, floating charge over all moveable plant machinery, implements, utensils, furniture & equipment by way of assignment. The goodwill of the business (if any), the full benefit of all licences & guarantees.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 19 avr. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 juin 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 14 avr. 2008
    Livré le 19 avr. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transactions
    • 19 avr. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 21 juin 2016Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 11 mars 2008
    Livré le 13 mars 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/Hold land known as kings dock mill being land bounded by hurst st, tabley street, cornhill and shaws alley, liverpool; all fixed plant machinery and equipment thereon and goodwill of business; see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Investec Bank (UK) Limited
    Transactions
    • 13 mars 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 août 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Assignment of agreement for lease
    Créé le 08 août 2007
    Livré le 15 août 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    All right title and interest in to and under the agreement for lease of all that l/h land k/a kings dock mill being land bounded by hurst street, tabley street, cornhill and shaws alley, liverpool between liverpool city council and the company. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Investec Bank (UK) Limited
    Transactions
    • 15 août 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 03 sept. 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Charge over shares
    Créé le 08 août 2007
    Livré le 14 août 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    11,998 ordinary shares of £1 and £16,500 preference shares of £1 in tabley commercial limited together with all stocks share as warrants or other securities rights dividends interest of other property. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Investec Bank (UK) Limited
    Transactions
    • 14 août 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 août 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal charge
    Créé le 08 août 2007
    Livré le 14 août 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H land k/a 16-22 cornhill 40-44 shaws alley and land and buildings on the west side of tabley street liverpool merseyside t/no MS114238, l/h land and buildings on the north west side tabley street liverpool t/no MS11291, l/h land on the north west side of tabley street liverpool t/no MS466676. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Investec Bank (UK) Limited
    Transactions
    • 14 août 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 août 2019Satisfaction d'une charge (MR04)
    Debenture
    Créé le 08 août 2007
    Livré le 14 août 2007
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Personnes ayant droit
    • Investec Bank (UK) Limited
    Transactions
    • 14 août 2007Enregistrement d'une charge (395)
    • 22 août 2019Satisfaction d'une charge (MR04)

    BRABCO 719 LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    06 sept. 2023Due to be dissolved on
    09 sept. 2020Commencement of winding up
    Members voluntary liquidation
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    Francesca Tackie
    Empress Business Centre
    380 Chester Road
    M16 9EA Manchester
    practitioner
    Empress Business Centre
    380 Chester Road
    M16 9EA Manchester

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0