OWEN PUGH PROPERTIES LIMITED

OWEN PUGH PROPERTIES LIMITED

  • Vue d'ensemble
  • Résumé
  • Objet social
  • Adresse
  • Dénominations sociales précédentes
  • Comptes
  • Dépôts
  • Dirigeants
  • Personnes ayant un contrôle significatif
  • Charges
  • Insolvabilité
  • Source de données
  • Vue d'ensemble

    Nom de la sociétéOWEN PUGH PROPERTIES LIMITED
    Statut de la sociétéDissoute
    Forme juridiqueSociété à responsabilité limitée
    Numéro de société 06252475
    JuridictionAngleterre/Pays de Galles
    Date de création
    Date de cessation d'activité

    Résumé

    A des PSCs super sécurisésNon
    A des chargesOui
    A un historique d'insolvabilitéOui
    Le siège social est contestéNon

    Quel est l'objet de OWEN PUGH PROPERTIES LIMITED ?

    • Achat et vente de biens immobiliers propres (68100) / Activités immobilières

    Où se situe OWEN PUGH PROPERTIES LIMITED ?

    Adresse du siège social
    4 Hardman Square
    M3 3EB Manchester
    Adresse du siège social non livrableNon

    Quels étaient les noms précédents de OWEN PUGH PROPERTIES LIMITED ?

    Dénominations sociales précédentes
    Nom de la sociétéDeJusqu'au
    NORHAM HOUSE 1116 LIMITED18 mai 200718 mai 2007

    Quels sont les derniers comptes de OWEN PUGH PROPERTIES LIMITED ?

    Derniers comptes
    Derniers comptes arrêtés au31 mars 2016

    Quels sont les derniers dépôts pour OWEN PUGH PROPERTIES LIMITED ?

    Dépôts
    DateDescriptionDocumentType

    Gazette finale dissoute à la suite d'une liquidation

    1 pagesGAZ2

    Avis de transition de l'administration à la dissolution

    24 pagesAM23

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    26 pagesAM10

    Avis de l'ordonnance de révocation de l'administrateur de ses fonctions

    12 pagesAM16

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    29 pagesAM10

    Avis de prolongation de la période de l'administration

    3 pagesAM19

    Rapport d'avancement de l'administrateur

    14 pagesAM10

    Avis d'approbation réputée des propositions

    3 pagesAM06

    Déclaration des affaires avec le formulaire AM02SOA

    9 pagesAM02

    Déclaration de la proposition de l'administrateur

    20 pagesAM03

    Changement d'adresse du siège social de Cramlington Road Dudley Cramlington Northumberland NE23 7PR à 4 Hardman Square Manchester M3 3EB le 27 oct. 2017

    2 pagesAD01

    Nomination d'un administrateur

    3 pagesAM01

    Modification des coordonnées de l'administrateur Mr Robin Scott Armstrong le 06 oct. 2017

    2 pagesCH01

    Cessation de la nomination de Jonathan Rae Grant en tant que directeur le 29 sept. 2017

    1 pagesTM01

    Inscription de la charge 062524750010, créée le 28 juil. 2017

    45 pagesMR01

    Modification des coordonnées du secrétaire Katherine Anne Dickie le 08 mai 2017

    1 pagesCH03

    Déclaration de confirmation établie le 18 mai 2017 avec mises à jour

    5 pagesCS01

    Nomination de Mr Alan Park en tant qu'administrateur le 18 mai 2017

    2 pagesAP01

    Cessation de la nomination de Richard John Dent Lowery en tant que directeur le 18 mai 2017

    1 pagesTM01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2016

    19 pagesAA

    Inscription de la charge 062524750009, créée le 11 nov. 2016

    8 pagesMR01

    Déclaration annuelle jusqu'au 18 mai 2016 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital15 juin 2016

    État du capital au 15 juin 2016

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Nomination de Mr Richard John Dent Lowery en tant qu'administrateur le 01 avr. 2016

    2 pagesAP01

    Comptes annuels établis au 31 mars 2015

    13 pagesAA

    Déclaration annuelle jusqu'au 18 mai 2015 avec liste complète des actionnaires

    6 pagesAR01
    Dépôts associés
    CatégorieDateDescriptionType
    capital20 mai 2015

    État du capital au 20 mai 2015

    • Capital: GBP 1
    SH01

    Qui sont les dirigeants de OWEN PUGH PROPERTIES LIMITED ?

    Dirigeants
    NomNommé leDate de démissionRôleAdresseIdentification de la sociétéPays de résidenceNationalitéDate de naissanceProfessionNuméro
    APPLEGARTH, Katherine Anne
    Cramlington Road
    Dudley
    NE23 7PR Cramlington
    Northumberland
    England
    Secrétaire
    Cramlington Road
    Dudley
    NE23 7PR Cramlington
    Northumberland
    England
    British181186620002
    ARMSTRONG, Robin Scott
    Hardman Square
    M3 3EB Manchester
    4
    Administrateur
    Hardman Square
    M3 3EB Manchester
    4
    EnglandBritishGroup Logistics Director135000980002
    DICKSON, John Raymond
    The Farmhouse
    West Marlish
    NE61 4ER Morpeth
    Northumberland
    Administrateur
    The Farmhouse
    West Marlish
    NE61 4ER Morpeth
    Northumberland
    EnglandBritishCompany Director108398500001
    PARK, Alan
    Hardman Square
    M3 3EB Manchester
    4
    Administrateur
    Hardman Square
    M3 3EB Manchester
    4
    United KingdomBritishFinance Director231749470001
    DICKSON, John Raymond
    The Farmhouse
    West Marlish
    NE61 4ER Morpeth
    Northumberland
    Secrétaire
    The Farmhouse
    West Marlish
    NE61 4ER Morpeth
    Northumberland
    BritishCompany Director108398500001
    DIXON, Keith
    4 Enfield Avenue
    Swalwell
    NE16 3EE Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Secrétaire
    4 Enfield Avenue
    Swalwell
    NE16 3EE Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    BritishCompany Director1692810001
    NORHAM HOUSE SECRETARY LIMITED
    Norham House
    12 New Bridge Street West
    NE1 8AS Newcastle Upon Tyne
    Tyne &Wear
    Secrétaire
    Norham House
    12 New Bridge Street West
    NE1 8AS Newcastle Upon Tyne
    Tyne &Wear
    101749170001
    DIXON, Keith
    4 Enfield Avenue
    Swalwell
    NE16 3EE Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Administrateur
    4 Enfield Avenue
    Swalwell
    NE16 3EE Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    BritishCompany Director1692810001
    GRANT, Jonathan Rae
    Cramlington Road
    Dudley
    NE23 7PR Cramlington
    Northumberland
    Administrateur
    Cramlington Road
    Dudley
    NE23 7PR Cramlington
    Northumberland
    United KingdomBritishCommercial Director196766100001
    LOWERY, Richard John Dent
    Cramlington Road
    Dudley
    NE23 7PR Cramlington
    Northumberland
    Administrateur
    Cramlington Road
    Dudley
    NE23 7PR Cramlington
    Northumberland
    United KingdomBritishFinance Director115481860001
    ROBINSON, Sally
    Cramlington Road
    Dudley
    NE23 7PR Cramlington
    Northumberland
    Administrateur
    Cramlington Road
    Dudley
    NE23 7PR Cramlington
    Northumberland
    EnglandBritishFinance Director159156020001
    SAMUEL, Peter Bell
    Cramlington Road
    Dudley
    NE23 7PR Cramlington
    Northumberland
    Administrateur
    Cramlington Road
    Dudley
    NE23 7PR Cramlington
    Northumberland
    EnglandBritishDirector104237060001
    WHITE, Grahame
    3 Ripon Close
    Barns Park
    NE23 7XJ Cramlington
    Northumberland
    Administrateur
    3 Ripon Close
    Barns Park
    NE23 7XJ Cramlington
    Northumberland
    EnglandBritishCompany Director96977240001
    NORHAM HOUSE DIRECTOR LIMITED
    Norham House
    12 New Bridge Street West
    NE1 8AS Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    Administrateur
    Norham House
    12 New Bridge Street West
    NE1 8AS Newcastle Upon Tyne
    Tyne & Wear
    101749130001

    Qui sont les personnes ayant un contrôle significatif sur OWEN PUGH PROPERTIES LIMITED ?

    Personnes ayant un contrôle significatif
    NomNotifié leAdresseCessé
    Cramlington Road
    Dudley
    NE23 7PR Cramlington
    Dudley
    United Kingdom
    06 avr. 2016
    Cramlington Road
    Dudley
    NE23 7PR Cramlington
    Dudley
    United Kingdom
    Non
    Forme juridiqueLimited By Shares
    Pays d'enregistrementUnited Kingdom
    Autorité légaleUnited Kingdom
    Lieu d'enregistrementCompanies House
    Numéro d'enregistrement05314796
    Nature du contrôle
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des actions de la société.
    • La personne détient, directement ou indirectement, plus de 75 % des droits de vote dans la société.

    OWEN PUGH PROPERTIES LIMITED a-t-elle des charges ?

    Charges
    ClassificationDatesStatutDétails
    A registered charge
    Créé le 28 juil. 2017
    Livré le 03 août 2017
    En cours
    La charge flottante couvre tout: Oui
    Contient une promesse négative: Oui
    Contient une charge flottante: Oui
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Merino Industries LTD (As Security Agent)
    Transactions
    • 03 août 2017Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 11 nov. 2016
    Livré le 11 nov. 2016
    En cours
    Brève description
    Freehold property known as land & buildings known as 1&2 rowlands buildings, dudley, cramlington registered at h m land registry with title numbers TY478703 and TY523755 together with such right, title and interest as the company may have in the land shaded green in the plan attached to the mortgage instrument.
    Contient une promesse négative: Oui
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 11 nov. 2016Enregistrement d'une charge (MR01)
    A registered charge
    Créé le 11 nov. 2013
    Livré le 13 nov. 2013
    En cours
    Brève description
    F/H property at factory road blaydon t/no TY59819. Notification of addition to or amendment of charge.
    Contient une charge fixe: Oui
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 13 nov. 2013Enregistrement d'une charge (MR01)
    Legal mortgage
    Créé le 17 sept. 2010
    Livré le 23 sept. 2010
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from owen pugh holdings limited to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Miners welfare site cramlington road dudley northumberland t/no TY468284; with the benefit of all rights, licences, guarantees, rent deposits, contracts, deeds undertakings & warranties relating to the property. Any shares or membership rights in any management company for the property. Any goodwill of any business from time to time carried on at the property. Any rental & other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property & all other payments whatever in respect of the property.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 23 sept. 2010Enregistrement d'une charge (MG01)
    Legal mortgage
    Créé le 23 avr. 2008
    Livré le 26 avr. 2008
    Totalement satisfaite
    Montant garanti
    All monies due or to become due from owen pugh holdings limited to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    L/H property k/a shibdon business centre blaydon tyne and wear with the benefit of all rights, licences, guarantees, rent deposits, contracts, deeds undertakings & warranties relating to the property. Any shares or membership rights in any management company for the property. Any goodwill of any business from time to time carried on at the property. Any rental & other money payable and any legal licence or other interest created in respect of the property & all other payments whatever in respect of the property.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 26 avr. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    • 01 avr. 2015Satisfaction d'une charge (MR04)
    Legal mortgage
    Créé le 14 avr. 2008
    Livré le 18 avr. 2008
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from owen pugh holdings limited to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land lying to the south & east of rowlands buildings, dudley and land to the south & east of victory cottages, dudley t/n's TY286788 & TY395351 with the benefit of all rights, licences, guarantees, rent deposits, contracts, deeds undertakings & warranties relating to the property. Any shares or membership rights in any management company for the property. Any goodwill of any business from time to time carried on at the property. Any rental & other money payable and any legal licence or other interest created in respect of the property & all other payments whatever in respect of the property.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 18 avr. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    Debenture
    Créé le 18 févr. 2008
    Livré le 21 févr. 2008
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 21 févr. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    Legal mortgage
    Créé le 18 févr. 2008
    Livré le 21 févr. 2008
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from owen pugh holdings limited to the chargee on any account whatosever
    Brèves mentions
    Land at bassington industrial estate cramlington t/no ND154134 with the benefit of all rights, licences, guarantees, rent deposits, contracts, deeds undertakings & warranties relating to the property. Any shares or membership rights in any management company for the property. Any goodwill of any business from time to time carried on at the property. Any rental & other money payable and any legal licence or other interest created in respect of the property & all other payments whatever in respect of the property.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 21 févr. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    Legal mortgage
    Créé le 18 févr. 2008
    Livré le 21 févr. 2008
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    F/H property k/a land lying to the south and east of rowlands buildings and land lying to the south and east of victory cottages dudley t/no TY286788 and TY395351 with the benefit of all rights, licences, guarantees, rent deposits, contracts, deeds undertakings & warranties relating to the property. Any shares or membership rights in any management company for the property. Any goodwill of any business from time to time carried on at the property. Any rental & other money payable and any legal licence or other interest created in respect of the property & all other payments whatever in respect of the property.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 21 févr. 2008Enregistrement d'une charge (395)
    Legal mortgage
    Créé le 18 févr. 2008
    Livré le 21 févr. 2008
    En cours
    Montant garanti
    All monies due or to become due from owen pugh holdings limited to the chargee on any account whatsoever
    Brèves mentions
    Land at cramlington road and lying to the west of west view dudley cramlington t/no's TY440277 and TY445741.
    Personnes ayant droit
    • Hsbc Bank PLC
    Transactions
    • 21 févr. 2008Enregistrement d'une charge (395)

    OWEN PUGH PROPERTIES LIMITED a-t-elle des procédures d'insolvabilité ?

    Numéro de dossierDatesTypePraticiensAutre
    1
    DateType
    19 sept. 2019Administration ended
    09 oct. 2017Administration started
    In administration
    NomRôleAdresseNommé leCessé le
    David John Dunckley
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    practitioner
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Christopher Petts
    2nd Floor Rotterdam House 116 Quayside
    NE1 3DY Newcastle Upon Tyne
    practitioner
    2nd Floor Rotterdam House 116 Quayside
    NE1 3DY Newcastle Upon Tyne

    Source de données

    • Companies House du Royaume-Uni
      Le registre officiel des sociétés au Royaume-Uni, offrant un accès public aux informations sur les sociétés telles que les noms, les adresses, les administrateurs et les documents financiers.
    • Licence: CC0